info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 3
Cargos no vigentes 14
Apariciones en BORME 30
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apoderado Gelf Madrid (Spain) SL 30/04/2018 Actualidad
Apo.Manc. Goodman Industrial Logistics (Spain) SL 17/04/2018 Actualidad
Apoderado Goodman Real Estate Spain SL 21/02/2014 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Manc. Goodman Can Estella Logistics (Spain) SL 18/06/2018 03/01/2019
Apo.Manc. Goodman Industrial Logistics (Spain) SL 26/02/2014 17/10/2018
Apoderado Celogix España SL 30/04/2018 30/07/2018
Apoderado Gelf Madrid (Spain) SL 26/03/2014 27/07/2018
Apoderado Gelf Madrid (Spain) SL 17/09/2013 30/04/2018
Apo.Manc. Celogix España SL 10/09/2013 30/04/2018
Apoderado Goodman Industrial Logistics (Spain) SL 20/09/2013 17/04/2018
Apoderado Goodman Real Estate Spain SL 16/09/2013 16/04/2018
Apo.Manc. Goodman Can Margarit Logistics (Spain) SL 02/06/2016 09/02/2018
Apo.Manc. Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 1 SA 17/09/2013 11/12/2015
Apo.Manc. Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 2 SL 19/09/2013 11/11/2015
Apoderado Ocm Gaudi Sfbp Holdco SL 17/09/2013 05/11/2015
Apoderado Ocm Gaudi Viladecans SL 17/09/2013 23/10/2015
Apo.Manc. Ocm Gaudi Viladecans SL 21/03/2014 23/10/2015
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Vanden Berghe Carl Renaat M .

03

Ene 2019

Revocaciones

Con fecha 03/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Kerkhofs Sandra Karin B
Apo.Manc. Bex Hanna Maria

PDF Anuncio nº 9371 de 2019

Datos registrales: T 36869 , F 6, S 8, H M 659799, I/A 6

17

Oct 2018

Revocaciones

Con fecha 17/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Kerkhofs Sandra Karin B
Apo.Manc. Bex Hanna Maria

PDF Anuncio nº 426009 de 2018

Datos registrales: T 26949 , F 208, S 8, H M 386802, I/A 43

30

Jul 2018

Revocaciones

Con fecha 30/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Kerkhofs Sandra Karin B
Apoderado Bex Hanna Maria

PDF Anuncio nº 327507 de 2018

Datos registrales: T 34021 , F 16, S 8, H M 351831, I/A 29

27

Jul 2018

Revocaciones

Con fecha 27/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Kerkhofs Sandra Karin B
Apoderado Bex Hanna Maria

PDF Anuncio nº 325764 de 2018

Datos registrales: T 25288 , F 122, S 8, H M 455324, I/A 25

18

Jun 2018

Nombramientos

Con fecha 18/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Virag Eva
Apo.Manc. Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Sol. Palacio Olive Francisco
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerkhofs Sandra Karin B
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Sol. Garcia Cuenca Ignacio
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J
Apo.Sol. Burgos Diaz-Guerra Ruth
Apo.Manc. Bex Hanna Maria

PDF Anuncio nº 267190 de 2018

Datos registrales: T 36869 , F 4, S 8, H M 659799, I/A 4

30

Abr 2018

Nombramientos

Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Virag Eva
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apoderado Palacio Olive Francisco
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerkhofs Sandra Karin B
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Garcia Cuenca Ignacio
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J
VsecrNoConsj Burgos Diaz-Guerra Ruth
Apoderado Bex Hanna Maria

PDF Anuncio nº 200726 de 2018

Datos registrales: T 34021 , F 14, S 8, H M 351831, I/A 28

30

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Sol. Usano Benitez David
Apoderado Sels Kelly
Apo.Sol. Sanchez Cidrera Ana Isabel
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Katrijn Vandeberg
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Sol. Gomez Cuetara Martinez Isabel
Apoderado Gert Siffert
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J
Apoderado Bigeriego Suarez Blanco Isabel
Apo.Sol. Bex Hanna Maria
Apoderado Basañez Fernandez Isabel

PDF Anuncio nº 200726 de 2018

Datos registrales: T 34021 , F 14, S 8, H M 351831, I/A 28

30

Abr 2018

Nombramientos

Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Virag Eva
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apoderado Palacio Olive Francisco
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerkhofs Sandra Karin B
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Garcia Cuenca Ignacio
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J
VsecrNoConsj Burgos Diaz-Guerra Ruth
Apoderado Bex Hanna Maria

PDF Anuncio nº 200437 de 2018

Datos registrales: T 25288 , F 121, S 8, H M 455324, I/A 24

30

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Sol. Usano Benitez David
Apoderado Sels Kelly
Apo.Sol. Sanchez Cidrera Ana Isabel
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Katrijn Vandeberg
Apoderado Huyghe Paul
Apo.Sol. Gomez Cuetara Martinez Isabel
Apoderado Gert Siffert
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J
Apoderado Bigeriego Suarez Blanco Isabel
Apoderado Bex Hanna Maria
Apoderado Basañez Fernandez Isabel

PDF Anuncio nº 200437 de 2018

Datos registrales: T 25288 , F 121, S 8, H M 455324, I/A 24

17

Abr 2018

Nombramientos

Con fecha 17/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Virag Eva
Apo.Manc. Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Sol. Palacio Olive Francisco
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerkhofs Sandra Karin B
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Sol. Garcia Cuenca Ignacio
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J
Apo.Sol. Burgos Diaz-Guerra Ruth
Apo.Manc. Bex Hanna Maria

PDF Anuncio nº 179204 de 2018

Datos registrales: T 26949 , F 206, S 8, H M 386802, I/A 41

17

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 17/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 34 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 179204 de 2018

Datos registrales: T 26949 , F 206, S 8, H M 386802, I/A 41

16

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 16/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Sol. Usano Benitez David
Apoderado Servicios Generales De Gestion SL
Apoderado Sels Kelly
Apo.Sol. Sanchez Cidrera Ana Isabel
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Katrijn Vandeberg
Apoderado Huyghe Paul
Apo.Sol. Gomez Cuetara Martinez Isabel
Apoderado Gert Siffert
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J
Apoderado Bigeriego Suarez Blanco Isabel
Apoderado Bex Hanna Maria
Apoderado Basañez Fernandez Isabel
Apoderado B. Vander Stichele Emmanuel Luc

PDF Anuncio nº 176978 de 2018

Datos registrales: T 28913 , F 202, S 8, H M 344010, I/A 32

09

Feb 2018

Revocaciones

Con fecha 09/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J
Apoderado Basañez Fernandez Isabel

PDF Anuncio nº 86147 de 2018

Datos registrales: T 34817 , F 57, S 8, H M 626260, I/A 12

02

Jun 2016

Nombramientos

Con fecha 02/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Wauters Felix
Apo.Sol. Vanpaemel Dries
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Sol. Van Mieghem Kris
SecreNoConsj Van Bambost Isabella
Presidente Ravell Machado Guillermo
VsecrNoConsj Martinez Rodriguez Patricia
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Sol. Garcia Cuenca Ignacio
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 247151 de 2016

Datos registrales: T 34817 , F 50, S 8, H M 626260, I/A 2

11

Dic 2015

Revocaciones

Con fecha 11/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 32 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 513942 de 2015

Datos registrales: T 28913 , F 215, S 8, H M 1547, I/A 75

11

Nov 2015

Revocaciones

Con fecha 11/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 32 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 466266 de 2015

Datos registrales: T 26600 , F 105, S 8, H M 363877, I/A 32

05

Nov 2015

Revocaciones

Con fecha 05/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 28 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 457882 de 2015

Datos registrales: T 26818 , F 98, S 8, H M 363974, I/A 24

23

Oct 2015

Revocaciones

Con fecha 23/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 26 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 438300 de 2015

Datos registrales: T 25229 , F 210, S 8, H M 454330, I/A 18

26

Mar 2014

Nombramientos

Con fecha 26/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Huyghe Paul
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 147433 de 2014

Datos registrales: T 25288 , F 116, S 8, H M 455324, I/A 14

21

Mar 2014

Nombramientos

Con fecha 21/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 142613 de 2014

Datos registrales: T 25229 , F 110, S 8, H M 454330, I/A 15

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2019-7-28 Madrid 11/01/2019
PDF BORME-A-2018-206-28 Madrid 25/10/2018
PDF BORME-A-2018-151-28 Madrid 07/08/2018
PDF BORME-A-2018-150-28 Madrid 06/08/2018
PDF BORME-A-2018-121-28 Madrid 26/06/2018
PDF BORME-A-2018-89-28 Madrid 10/05/2018
PDF BORME-A-2018-79-28 Madrid 24/04/2018
PDF BORME-A-2018-78-28 Madrid 23/04/2018
PDF BORME-A-2018-38-28 Madrid 22/02/2018
PDF BORME-A-2016-110-28 Madrid 10/06/2016
PDF BORME-A-2015-241-28 Madrid 18/12/2015
PDF BORME-A-2015-220-28 Madrid 18/11/2015
PDF BORME-A-2015-217-28 Madrid 13/11/2015
PDF BORME-A-2015-208-28 Madrid 30/10/2015
PDF BORME-A-2014-64-28 Madrid 02/04/2014
PDF BORME-A-2014-62-28 Madrid 31/03/2014
PDF BORME-A-2014-45-28 Madrid 06/03/2014
PDF BORME-A-2014-41-28 Madrid 28/02/2014
PDF BORME-A-2013-186-28 Madrid 30/09/2013
PDF BORME-A-2013-184-28 Madrid 26/09/2013
Ver más

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret