Última actualización: 26 de Julio de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 3 |
---|---|
Cargos no vigentes | 16 |
Apariciones en BORME | 34 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Gelf Madrid (Spain) SL | 30/04/2018 | Actualidad |
Apo.Manc. | Goodman Industrial Logistics (Spain) SL | 17/04/2018 | Actualidad |
Apoderado | Goodman Real Estate Spain SL | 21/02/2014 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Loreto Investments 2018 SL | 15/06/2018 | 26/07/2019 |
Apo.Manc. | Goodman Can Estella Logistics (Spain) SL | 18/06/2018 | 26/07/2019 |
Apo.Manc. | Goodman Real Estate Spain SL | 16/04/2018 | 24/07/2019 |
Apoderado | Gelf Madrid (Spain) SL | 26/03/2014 | 24/07/2019 |
Apo.Manc. | Goodman Industrial Logistics (Spain) SL | 26/02/2014 | 22/07/2019 |
Apoderado | Celogix España SL | 30/04/2018 | 22/07/2019 |
Apoderado | Gelf Madrid (Spain) SL | 17/09/2013 | 30/04/2018 |
Apo.Manc. | Celogix España SL | 10/09/2013 | 30/04/2018 |
Apoderado | Goodman Industrial Logistics (Spain) SL | 20/09/2013 | 17/04/2018 |
Apoderado | Goodman Real Estate Spain SL | 16/09/2013 | 16/04/2018 |
Apo.Manc. | Goodman Can Margarit Logistics (Spain) SL | 02/06/2016 | 09/02/2018 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 1 SA | 17/09/2013 | 11/12/2015 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 2 SL | 19/09/2013 | 11/11/2015 |
Apoderado | Ocm Gaudi Sfbp Holdco SL | 17/09/2013 | 05/11/2015 |
Apoderado | Ocm Gaudi Viladecans SL | 17/09/2013 | 23/10/2015 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Viladecans SL | 21/03/2014 | 23/10/2015 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Van Oost Dominiek Andre H .
26
Jul 2019
Con fecha 26/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Datos registrales: T 37258 , F 186, S 8, H M 664475, I/A 9
26
Jul 2019
Con fecha 26/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Datos registrales: T 36869 , F 216, S 8, H M 659799, I/A 8
24
Jul 2019
Con fecha 24/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Manc. | Kerkhofs Sandra Karin B |
Apo.Manc. | Bex Hanna Maria |
Apo.Manc. | Berghe Carl Renaat M. Vanden |
Datos registrales: T 28913 , F 209, S 8, H M 344010, I/A 36
24
Jul 2019
Con fecha 24/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Datos registrales: T 37549 , F 171, S 8, H M 455324, I/A 28
22
Jul 2019
Con fecha 22/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Datos registrales: T 26949 , F 214, S 8, H M 386802, I/A 45
22
Jul 2019
Con fecha 22/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Datos registrales: T 37549 , F 200, S 8, H M 351831, I/A 31
18
Jun 2018
Con fecha 18/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Virag Eva |
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Palacio Olive Francisco |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerkhofs Sandra Karin B |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Sol. | Garcia Cuenca Ignacio |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apo.Sol. | Burgos Diaz-Guerra Ruth |
Apo.Manc. | Bex Hanna Maria |
Datos registrales: T 36869 , F 4, S 8, H M 659799, I/A 4
15
Jun 2018
Con fecha 15/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Virag Eva |
Apoderado | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Palacio Olive Francisco |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerkhofs Sandra Karin B |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | J. Desmyter Liesbeth Valerie |
Apoderado | Garcia Cuenca Ignacio |
Apoderado | Burgos Diaz-Guerra Ruth |
Apoderado | Bex Hanna Maria |
Apoderado | Berghe Carl Renaat M. Vanden |
Datos registrales: T 37258 , F 72, S 8, H M 664475, I/A 4
30
Abr 2018
Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Virag Eva |
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Palacio Olive Francisco |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerkhofs Sandra Karin B |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Garcia Cuenca Ignacio |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
VsecrNoConsj | Burgos Diaz-Guerra Ruth |
Apoderado | Bex Hanna Maria |
Datos registrales: T 34021 , F 14, S 8, H M 351831, I/A 28
30
Abr 2018
Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Usano Benitez David |
Apoderado | Sels Kelly |
Apo.Sol. | Sanchez Cidrera Ana Isabel |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Katrijn Vandeberg |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Sol. | Gomez Cuetara Martinez Isabel |
Apoderado | Gert Siffert |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | Bigeriego Suarez Blanco Isabel |
Apo.Sol. | Bex Hanna Maria |
Apoderado | Basañez Fernandez Isabel |
Datos registrales: T 34021 , F 14, S 8, H M 351831, I/A 28
30
Abr 2018
Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Virag Eva |
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Palacio Olive Francisco |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerkhofs Sandra Karin B |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Garcia Cuenca Ignacio |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
VsecrNoConsj | Burgos Diaz-Guerra Ruth |
Apoderado | Bex Hanna Maria |
Datos registrales: T 25288 , F 121, S 8, H M 455324, I/A 24
30
Abr 2018
Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Usano Benitez David |
Apoderado | Sels Kelly |
Apo.Sol. | Sanchez Cidrera Ana Isabel |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Katrijn Vandeberg |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apo.Sol. | Gomez Cuetara Martinez Isabel |
Apoderado | Gert Siffert |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | Bigeriego Suarez Blanco Isabel |
Apoderado | Bex Hanna Maria |
Apoderado | Basañez Fernandez Isabel |
Datos registrales: T 25288 , F 121, S 8, H M 455324, I/A 24
17
Abr 2018
Con fecha 17/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Virag Eva |
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Palacio Olive Francisco |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerkhofs Sandra Karin B |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Sol. | Garcia Cuenca Ignacio |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apo.Sol. | Burgos Diaz-Guerra Ruth |
Apo.Manc. | Bex Hanna Maria |
Datos registrales: T 26949 , F 206, S 8, H M 386802, I/A 41
17
Abr 2018
Con fecha 17/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 26949 , F 206, S 8, H M 386802, I/A 41
16
Abr 2018
Con fecha 16/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Virag Eva |
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Palacio Olive Francisco |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerkhofs Sandra Karin B |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Sol. | Garcia Cuenca Ignacio |
Apo.Sol. | Burgos Diaz-Guerra Ruth |
Apo.Manc. | Bex Hanna Maria |
Datos registrales: T 28913 , F 202, S 8, H M 344010, I/A 32
16
Abr 2018
Con fecha 16/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Usano Benitez David |
Apoderado | Servicios Generales De Gestion SL |
Apoderado | Sels Kelly |
Apo.Sol. | Sanchez Cidrera Ana Isabel |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Katrijn Vandeberg |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apo.Sol. | Gomez Cuetara Martinez Isabel |
Apoderado | Gert Siffert |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | Bigeriego Suarez Blanco Isabel |
Apoderado | Bex Hanna Maria |
Apoderado | Basañez Fernandez Isabel |
Apoderado | B. Vander Stichele Emmanuel Luc |
Datos registrales: T 28913 , F 202, S 8, H M 344010, I/A 32
09
Feb 2018
Con fecha 09/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | Basañez Fernandez Isabel |
Datos registrales: T 34817 , F 57, S 8, H M 626260, I/A 12
02
Jun 2016
Con fecha 02/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Wauters Felix |
Apo.Sol. | Vanpaemel Dries |
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Van Mieghem Kris |
SecreNoConsj | Van Bambost Isabella |
Presidente | Ravell Machado Guillermo |
VsecrNoConsj | Martinez Rodriguez Patricia |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Sol. | Garcia Cuenca Ignacio |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Datos registrales: T 34817 , F 50, S 8, H M 626260, I/A 2
11
Dic 2015
Con fecha 11/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 28913 , F 215, S 8, H M 1547, I/A 75
11
Nov 2015
Con fecha 11/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 26600 , F 105, S 8, H M 363877, I/A 32
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2019-147-28 | Madrid | 02/08/2019 | |
BORME-A-2019-145-28 | Madrid | 31/07/2019 | |
BORME-A-2019-143-28 | Madrid | 29/07/2019 | |
BORME-A-2018-121-28 | Madrid | 26/06/2018 | |
BORME-A-2018-120-28 | Madrid | 25/06/2018 | |
BORME-A-2018-89-28 | Madrid | 10/05/2018 | |
BORME-A-2018-79-28 | Madrid | 24/04/2018 | |
BORME-A-2018-78-28 | Madrid | 23/04/2018 | |
BORME-A-2018-38-28 | Madrid | 22/02/2018 | |
BORME-A-2016-110-28 | Madrid | 10/06/2016 | |
BORME-A-2015-241-28 | Madrid | 18/12/2015 | |
BORME-A-2015-220-28 | Madrid | 18/11/2015 | |
BORME-A-2015-217-28 | Madrid | 13/11/2015 | |
BORME-A-2015-208-28 | Madrid | 30/10/2015 | |
BORME-A-2014-64-28 | Madrid | 02/04/2014 | |
BORME-A-2014-62-28 | Madrid | 31/03/2014 | |
BORME-A-2014-45-28 | Madrid | 06/03/2014 | |
BORME-A-2014-41-28 | Madrid | 28/02/2014 | |
BORME-A-2013-186-28 | Madrid | 30/09/2013 | |
BORME-A-2013-184-28 | Madrid | 26/09/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades