info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 4
Cargos no vigentes 33
Apariciones en BORME 59
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apoderado Gelf Madrid (Spain) SL 26/03/2014 Actualidad
Apo.Manc. Goodman Industrial Logistics (Spain) SL 26/02/2014 Actualidad
Apoderado Goodman Real Estate Spain SL 21/02/2014 Actualidad
Apoderado Goodman Industrial Logistics (Spain) SL 20/09/2013 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apoderado Gelf Madrid (Spain) SL 17/09/2013 30/04/2018
Apo.Manc. Celogix España SL 10/09/2013 30/04/2018
Apoderado Goodman Industrial Logistics (Spain) SL 19/09/2012 17/04/2018
Apoderado Goodman Real Estate Spain SL 16/09/2013 16/04/2018
Apo.Manc. Goodman Real Estate Spain SL 28/02/2013 16/04/2018
Apo.Manc. Goodman Can Margarit Logistics (Spain) SL 02/06/2016 09/02/2018
Apo.Manc. Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 1 SA 17/09/2013 11/12/2015
Apo.Manc. Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 2 SL 19/09/2013 11/11/2015
Apoderado Ocm Gaudi Sfbp Holdco SL 17/09/2013 05/11/2015
Apoderado Ocm Gaudi Viladecans SL 17/09/2013 23/10/2015
Apo.Manc. Ocm Gaudi Viladecans SL 21/03/2014 23/10/2015
Apoderado Goodman Industrial Logistics (Spain) SL 24/06/2011 20/09/2013
Apoderado Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 2 SL 17/05/2011 19/09/2013
Apo.Manc. Ocm Gaudi Viladecans SL 17/05/2011 17/09/2013
Apo.Manc. Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 1 SA 18/05/2011 17/09/2013
Apo.Manc. Ocm Gaudi Sfbp Holdco SL 19/05/2011 17/09/2013
Apo.Manc. Gelf Madrid (Spain) SL 18/05/2011 17/09/2013
Apo.Manc. Goodman Real Estate Spain SL 19/05/2011 16/09/2013
Apo.Manc. Celogix España SL 18/05/2011 10/09/2013
Consejero Goodman Real Estate Spain SL 31/07/2012 28/02/2013
Ver más
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Huyghe Paul .

30

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:



PDF Anuncio nº 200726 de 2018

Datos registrales: T 34021 , F 14, S 8, H M 351831, I/A 28

30

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:



PDF Anuncio nº 200437 de 2018

Datos registrales: T 25288 , F 121, S 8, H M 455324, I/A 24

17

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 17/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 34 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 179204 de 2018

Datos registrales: T 26949 , F 206, S 8, H M 386802, I/A 41

16

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 16/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:



PDF Anuncio nº 176978 de 2018

Datos registrales: T 28913 , F 202, S 8, H M 344010, I/A 32

09

Feb 2018

Revocaciones

Con fecha 09/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J
Apoderado Basañez Fernandez Isabel

PDF Anuncio nº 86147 de 2018

Datos registrales: T 34817 , F 57, S 8, H M 626260, I/A 12

02

Jun 2016

Nombramientos

Con fecha 02/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Wauters Felix
Apo.Sol. Vanpaemel Dries
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Sol. Van Mieghem Kris
SecreNoConsj Van Bambost Isabella
Presidente Ravell Machado Guillermo
VsecrNoConsj Martinez Rodriguez Patricia
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Sol. Garcia Cuenca Ignacio
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 247151 de 2016

Datos registrales: T 34817 , F 50, S 8, H M 626260, I/A 2

11

Dic 2015

Revocaciones

Con fecha 11/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 32 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 513942 de 2015

Datos registrales: T 28913 , F 215, S 8, H M 1547, I/A 75

11

Nov 2015

Revocaciones

Con fecha 11/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 32 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 466266 de 2015

Datos registrales: T 26600 , F 105, S 8, H M 363877, I/A 32

05

Nov 2015

Revocaciones

Con fecha 05/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 28 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 457882 de 2015

Datos registrales: T 26818 , F 98, S 8, H M 363974, I/A 24

23

Oct 2015

Revocaciones

Con fecha 23/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 26 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 438300 de 2015

Datos registrales: T 25229 , F 210, S 8, H M 454330, I/A 18

26

Mar 2014

Nombramientos

Con fecha 26/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Huyghe Paul
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 147433 de 2014

Datos registrales: T 25288 , F 116, S 8, H M 455324, I/A 14

21

Mar 2014

Nombramientos

Con fecha 21/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 142613 de 2014

Datos registrales: T 25229 , F 110, S 8, H M 454330, I/A 15

26

Feb 2014

Nombramientos

Con fecha 26/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J
Apo.Manc. B. Vander Stichele Emmanuel Luc

PDF Anuncio nº 104256 de 2014

Datos registrales: T 26949 , F 201, S 8, H M 386802, I/A 31

21

Feb 2014

Nombramientos

Con fecha 21/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Huyghe Paul
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J
Apoderado B. Vander Stichele Emmanuel Luc

PDF Anuncio nº 94962 de 2014

Datos registrales: T 28913 , F 197, S 8, H M 344010, I/A 21

20

Sep 2013

Nombramientos

Con fecha 20/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Huyghe Paul
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 418077 de 2013

Datos registrales: T 23416 , F 225, S 8, H M 386802, I/A 29

20

Sep 2013

Revocaciones

Con fecha 20/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Manteleers Bart
Apoderado Huyghe Paul
Apoderado Beeckman Karine Antonia Caroline

PDF Anuncio nº 418077 de 2013

Datos registrales: T 23416 , F 225, S 8, H M 386802, I/A 29

19

Sep 2013

Nombramientos

Con fecha 19/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vanden Berghe Carl Renaat M
Apo.Manc. Van Oost Dominiek Andre H
Apo.Manc. Manteleers Bart Henricus A
Apo.Manc. Kerckhofs Birgit Anneke T
Apo.Manc. Huyghe Paul
Apo.Manc. Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 413909 de 2013

Datos registrales: T 26600 , F 102, S 8, H M 363877, I/A 26

19

Sep 2013

Revocaciones

Con fecha 19/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Huyghe Paul
Apoderado Beeckman Karine Antonia C

PDF Anuncio nº 413909 de 2013

Datos registrales: T 26600 , F 102, S 8, H M 363877, I/A 26

17

Sep 2013

Nombramientos

Con fecha 17/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Huyghe Paul
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 411581 de 2013

Datos registrales: T 26818 , F 95, S 8, H M 363974, I/A 19

17

Sep 2013

Nombramientos

Con fecha 17/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vanden Berghe Carl Renaat M
Apoderado Van Oost Dominiek Andre H
Apoderado Manteleers Bart Henricus A
Apoderado Kerckhofs Birgit Anneke T
Apoderado Huyghe Paul
Apoderado Desmyter Liesbeth Valerie J

PDF Anuncio nº 411571 de 2013

Datos registrales: T 25229 , F 108, S 8, H M 454330, I/A 13

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2018-89-28 Madrid 10/05/2018
PDF BORME-A-2018-79-28 Madrid 24/04/2018
PDF BORME-A-2018-78-28 Madrid 23/04/2018
PDF BORME-A-2018-38-28 Madrid 22/02/2018
PDF BORME-A-2016-110-28 Madrid 10/06/2016
PDF BORME-A-2015-241-28 Madrid 18/12/2015
PDF BORME-A-2015-220-28 Madrid 18/11/2015
PDF BORME-A-2015-217-28 Madrid 13/11/2015
PDF BORME-A-2015-208-28 Madrid 30/10/2015
PDF BORME-A-2014-64-28 Madrid 02/04/2014
PDF BORME-A-2014-62-28 Madrid 31/03/2014
PDF BORME-A-2014-45-28 Madrid 06/03/2014
PDF BORME-A-2014-41-28 Madrid 28/02/2014
PDF BORME-A-2013-186-28 Madrid 30/09/2013
PDF BORME-A-2013-184-28 Madrid 26/09/2013
PDF BORME-A-2013-183-28 Madrid 25/09/2013
PDF BORME-A-2013-182-28 Madrid 24/09/2013
PDF BORME-A-2013-177-28 Madrid 17/09/2013
PDF BORME-A-2013-47-28 Madrid 08/03/2013
PDF BORME-A-2012-190-28 Madrid 02/10/2012
Ver más

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret