Última actualización: 30 de Abril de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 4 |
---|---|
Cargos no vigentes | 33 |
Apariciones en BORME | 59 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Gelf Madrid (Spain) SL | 26/03/2014 | Actualidad |
Apo.Manc. | Goodman Industrial Logistics (Spain) SL | 26/02/2014 | Actualidad |
Apoderado | Goodman Real Estate Spain SL | 21/02/2014 | Actualidad |
Apoderado | Goodman Industrial Logistics (Spain) SL | 20/09/2013 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Gelf Madrid (Spain) SL | 17/09/2013 | 30/04/2018 |
Apo.Manc. | Celogix España SL | 10/09/2013 | 30/04/2018 |
Apoderado | Goodman Industrial Logistics (Spain) SL | 19/09/2012 | 17/04/2018 |
Apoderado | Goodman Real Estate Spain SL | 16/09/2013 | 16/04/2018 |
Apo.Manc. | Goodman Real Estate Spain SL | 28/02/2013 | 16/04/2018 |
Apo.Manc. | Goodman Can Margarit Logistics (Spain) SL | 02/06/2016 | 09/02/2018 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 1 SA | 17/09/2013 | 11/12/2015 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 2 SL | 19/09/2013 | 11/11/2015 |
Apoderado | Ocm Gaudi Sfbp Holdco SL | 17/09/2013 | 05/11/2015 |
Apoderado | Ocm Gaudi Viladecans SL | 17/09/2013 | 23/10/2015 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Viladecans SL | 21/03/2014 | 23/10/2015 |
Apoderado | Goodman Industrial Logistics (Spain) SL | 24/06/2011 | 20/09/2013 |
Apoderado | Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 2 SL | 17/05/2011 | 19/09/2013 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Viladecans SL | 17/05/2011 | 17/09/2013 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Sfbp Propco San Fernando 1 SA | 18/05/2011 | 17/09/2013 |
Apo.Manc. | Ocm Gaudi Sfbp Holdco SL | 19/05/2011 | 17/09/2013 |
Apo.Manc. | Gelf Madrid (Spain) SL | 18/05/2011 | 17/09/2013 |
Apo.Manc. | Goodman Real Estate Spain SL | 19/05/2011 | 16/09/2013 |
Apo.Manc. | Celogix España SL | 18/05/2011 | 10/09/2013 |
Consejero | Goodman Real Estate Spain SL | 31/07/2012 | 28/02/2013 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Huyghe Paul .
30
Abr 2018
Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Usano Benitez David |
Apoderado | Sels Kelly |
Apo.Sol. | Sanchez Cidrera Ana Isabel |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Katrijn Vandeberg |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Sol. | Gomez Cuetara Martinez Isabel |
Apoderado | Gert Siffert |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | Bigeriego Suarez Blanco Isabel |
Apo.Sol. | Bex Hanna Maria |
Apoderado | Basañez Fernandez Isabel |
Datos registrales: T 34021 , F 14, S 8, H M 351831, I/A 28
30
Abr 2018
Con fecha 30/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Usano Benitez David |
Apoderado | Sels Kelly |
Apo.Sol. | Sanchez Cidrera Ana Isabel |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Katrijn Vandeberg |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apo.Sol. | Gomez Cuetara Martinez Isabel |
Apoderado | Gert Siffert |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | Bigeriego Suarez Blanco Isabel |
Apoderado | Bex Hanna Maria |
Apoderado | Basañez Fernandez Isabel |
Datos registrales: T 25288 , F 121, S 8, H M 455324, I/A 24
17
Abr 2018
Con fecha 17/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 26949 , F 206, S 8, H M 386802, I/A 41
16
Abr 2018
Con fecha 16/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Usano Benitez David |
Apoderado | Servicios Generales De Gestion SL |
Apoderado | Sels Kelly |
Apo.Sol. | Sanchez Cidrera Ana Isabel |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Katrijn Vandeberg |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apo.Sol. | Gomez Cuetara Martinez Isabel |
Apoderado | Gert Siffert |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | Bigeriego Suarez Blanco Isabel |
Apoderado | Bex Hanna Maria |
Apoderado | Basañez Fernandez Isabel |
Apoderado | B. Vander Stichele Emmanuel Luc |
Datos registrales: T 28913 , F 202, S 8, H M 344010, I/A 32
09
Feb 2018
Con fecha 09/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | Basañez Fernandez Isabel |
Datos registrales: T 34817 , F 57, S 8, H M 626260, I/A 12
02
Jun 2016
Con fecha 02/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Wauters Felix |
Apo.Sol. | Vanpaemel Dries |
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Sol. | Van Mieghem Kris |
SecreNoConsj | Van Bambost Isabella |
Presidente | Ravell Machado Guillermo |
VsecrNoConsj | Martinez Rodriguez Patricia |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Sol. | Garcia Cuenca Ignacio |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Datos registrales: T 34817 , F 50, S 8, H M 626260, I/A 2
11
Dic 2015
Con fecha 11/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 28913 , F 215, S 8, H M 1547, I/A 75
11
Nov 2015
Con fecha 11/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 26600 , F 105, S 8, H M 363877, I/A 32
05
Nov 2015
Con fecha 05/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 26818 , F 98, S 8, H M 363974, I/A 24
23
Oct 2015
Con fecha 23/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Young Stephen Richard |
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Usano Benitez David |
Apoderado | Sels Kelly |
Apoderado | Sanchez Cidrera Ana Isabel |
Apoderado | Ravell Machado Guillermo |
Apoderado | Prince Dominique Emile Lisette |
Apoderado | Perez Rivares Juan Antonio |
Apoderado | Peeters Daniel Cornelius Dymphna |
Apoderado | Murray Nicholas Stuart Granville |
Apo.Sol. | Martinez Rodriguez Patricia |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Katrijn Vandeberg |
Apoderado | Jimeno Esteban Maria Soledad |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apoderado | Gomez Cuetara Martinez Isabel |
Apoderado | Gimenez Aliaga Marta |
Apoderado | Gert Siffert |
Apoderado | Echenique Conde Pablo |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apo.Manc. | Bigeriego Suarez Blanco Isabel |
Apoderado | Bagaria Mateos Eduardo |
Apoderado | Albiñana Cilveti Ignacio |
Datos registrales: T 25229 , F 210, S 8, H M 454330, I/A 18
26
Mar 2014
Con fecha 26/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Datos registrales: T 25288 , F 116, S 8, H M 455324, I/A 14
21
Mar 2014
Con fecha 21/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vander-Stichele Emmanuel Luc Bernard |
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Datos registrales: T 25229 , F 110, S 8, H M 454330, I/A 15
26
Feb 2014
Con fecha 26/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apo.Manc. | B. Vander Stichele Emmanuel Luc |
Datos registrales: T 26949 , F 201, S 8, H M 386802, I/A 31
21
Feb 2014
Con fecha 21/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Apoderado | B. Vander Stichele Emmanuel Luc |
Datos registrales: T 28913 , F 197, S 8, H M 344010, I/A 21
20
Sep 2013
Con fecha 20/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Datos registrales: T 23416 , F 225, S 8, H M 386802, I/A 29
20
Sep 2013
Con fecha 20/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Manteleers Bart |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apoderado | Beeckman Karine Antonia Caroline |
Datos registrales: T 23416 , F 225, S 8, H M 386802, I/A 29
19
Sep 2013
Con fecha 19/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apo.Manc. | Van Oost Dominiek Andre H |
Apo.Manc. | Manteleers Bart Henricus A |
Apo.Manc. | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apo.Manc. | Huyghe Paul |
Apo.Manc. | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Datos registrales: T 26600 , F 102, S 8, H M 363877, I/A 26
19
Sep 2013
Con fecha 19/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apoderado | Beeckman Karine Antonia C |
Datos registrales: T 26600 , F 102, S 8, H M 363877, I/A 26
17
Sep 2013
Con fecha 17/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Datos registrales: T 26818 , F 95, S 8, H M 363974, I/A 19
17
Sep 2013
Con fecha 17/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vanden Berghe Carl Renaat M |
Apoderado | Van Oost Dominiek Andre H |
Apoderado | Manteleers Bart Henricus A |
Apoderado | Kerckhofs Birgit Anneke T |
Apoderado | Huyghe Paul |
Apoderado | Desmyter Liesbeth Valerie J |
Datos registrales: T 25229 , F 108, S 8, H M 454330, I/A 13
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-89-28 | Madrid | 10/05/2018 | |
BORME-A-2018-79-28 | Madrid | 24/04/2018 | |
BORME-A-2018-78-28 | Madrid | 23/04/2018 | |
BORME-A-2018-38-28 | Madrid | 22/02/2018 | |
BORME-A-2016-110-28 | Madrid | 10/06/2016 | |
BORME-A-2015-241-28 | Madrid | 18/12/2015 | |
BORME-A-2015-220-28 | Madrid | 18/11/2015 | |
BORME-A-2015-217-28 | Madrid | 13/11/2015 | |
BORME-A-2015-208-28 | Madrid | 30/10/2015 | |
BORME-A-2014-64-28 | Madrid | 02/04/2014 | |
BORME-A-2014-62-28 | Madrid | 31/03/2014 | |
BORME-A-2014-45-28 | Madrid | 06/03/2014 | |
BORME-A-2014-41-28 | Madrid | 28/02/2014 | |
BORME-A-2013-186-28 | Madrid | 30/09/2013 | |
BORME-A-2013-184-28 | Madrid | 26/09/2013 | |
BORME-A-2013-183-28 | Madrid | 25/09/2013 | |
BORME-A-2013-182-28 | Madrid | 24/09/2013 | |
BORME-A-2013-177-28 | Madrid | 17/09/2013 | |
BORME-A-2013-47-28 | Madrid | 08/03/2013 | |
BORME-A-2012-190-28 | Madrid | 02/10/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades