Última actualización: 4 de Febrero de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 2 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A64438625 |
Denominación anterior | Fonrestaura Internacional SA |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Rb De Catalunya Num.135 P.Pr (Barcelona). |
Capital social | 152.230,0 euros |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERADO | Salegui Arbizu Esteban | 19/01/2012 | 04/02/2019 |
APODERADO | Rafel Miarnau Ignacio | 24/12/2009 | 04/02/2019 |
PRESIDENTE | Nueva Caja Rural De Aragon Sociedad Cooperativa De | 13/07/2016 | 04/02/2019 |
CONSEJERO | Nueva Caja Rural De Aragon Sociedad Cooperativa De | 04/09/2013 | 04/02/2019 |
PRESIDENTE | Limaskoa SL | 13/07/2016 | 04/02/2019 |
AUDIT.CUENT. | Laes Nexia Ac SL | 30/06/2011 | 04/02/2019 |
LIQUIDADOR | Impulse Asset Bcn SL | 23/10/2018 | 04/02/2019 |
APODERADO | Cortezo Dolagaray Barbara | 30/06/2011 | 04/02/2019 |
APODERADO | Coromina Morato Lluis | 24/12/2009 | 04/02/2019 |
APODERADO | Brañas Garza Jose | 24/12/2009 | 04/02/2019 |
REPR.143 RRM | Abellan Gomez Jesus | 23/10/2018 | 04/02/2019 |
APODERADO | Abellan Gomez Jesus | 24/12/2009 | 04/02/2019 |
APODERADO | Abellan Gomez Jesus | 30/06/2011 | 04/02/2019 |
APODERADO | Abellan Gomez Jesus | 25/03/2011 | 04/02/2019 |
PRESIDENTE | Salengoa SL | 13/07/2016 | 23/10/2018 |
REPR.143 RRM | Rafel Miarnau Ignacio | 13/07/2016 | 23/10/2018 |
CONSEJERO | Limaskoa SL | 04/09/2013 | 23/10/2018 |
CONSEJERO | Elegasa SL | 04/09/2013 | 23/10/2018 |
REPR.143 RRM | Cortezo Dolagaray Barbara | Desconocido | 23/10/2018 |
PRESIDENTE | Charent SL | 13/07/2016 | 23/10/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Inverporfolio Internacional SA.
04
Feb 2019
Con fecha 04/02/2019 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 42717 , F 130, S 8, H B 344116, I/A 34
04
Feb 2019
Con fecha 04/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Impulse Asset Bcn SL |
REPR.143 RRM | Abellan Gomez Jesus |
Datos registrales: T 42717 , F 130, S 8, H B 344116, I/A 34
23
Oct 2018
Con fecha 23/10/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 42717 , F 129, S 8, H B 344116, I/A 33
23
Oct 2018
Con fecha 23/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Impulse Asset Bcn SL |
REPR.143 RRM | Abellan Gomez Jesus |
Datos registrales: T 42717 , F 129, S 8, H B 344116, I/A 33
23
Oct 2018
Con fecha 23/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Sas Llusa Pedro |
PRESIDENTE | Salengoa SL |
REPR.143 RRM | Salegui Usarraga Gabriel |
REPR.143 RRM | Salegui Escolano Aitor |
REPR.143 RRM | Salegui Arbizu Esteban |
REPR.143 RRM | Rafel Miarnau Ignacio |
CONSEJERO | Nueva Caja De Aragon Sociedad Cooperativa De Credi |
SECR.NO CONS | Martin Martin Marta |
CONSEJERO | Limaskoa SL |
CONSEJERO | Invermatillas SL |
PRESIDENTE | Inmobiliaria Atazar SA |
PRESIDENTE | Gesnostrum Sociedad Gestora SL |
REPR.143 RRM | Ferreras Gamazo Enrique Jesus |
CONSEJERO | Elegasa SL |
CONSEJERO | Edificios Patrimoniales SA |
REPR.143 RRM | De Muguiro Miranda Javier |
REPR.143 RRM | Cortezo Dolagaray Barbara |
REPR.143 RRM | Coromina Morato Luis |
CONSEJERO | Charent SL |
Datos registrales: T 42717 , F 129, S 8, H B 344116, I/A 33
22
Oct 2018
Con fecha 22/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Inverporfolio Internacional SA |
REPR.143 RRM | Abellan Gomez Jesus |
Datos registrales: T 45090 , F 90, S 8, H B 476536, I/A 12
12
Mar 2018
Con fecha 12/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Sas Llusa Pedro |
Datos registrales: T 42717 , F 129, S 8, H B 344116, I/A 32
12
Mar 2018
Con fecha 12/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Puyalto Lucindo Marcos |
Datos registrales: T 42717 , F 129, S 8, H B 344116, I/A 32
28
Abr 2017
Con fecha 28/04/2017, la sociedad cambia su domicilio social a RB DE CATALUNYA Num.135 P.PR (BARCELONA).
Datos registrales: T 42717 , F 128, S 8, H B 344116, I/A 31
28
Abr 2017
Reducción de capital
Datos registrales: T 42717 , F 128, S 8, H B 344116, I/A 31
21
Abr 2017
Con fecha 21/04/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 4.- PRORROGA DE LA DURACION DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 42717 , F 128, S 8, H B 344116, I/A 30
18
Ene 2017
Con fecha 18/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Sirovillaran SL |
REPR.143 RRM | Gil Fernandez Villaran Mariano |
Datos registrales: T 42717 , F 128, S 8, H B 344116, I/A 29
01
Ago 2016
Con fecha 01/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Ferreras Gamazo Enrique Jesus |
Datos registrales: T 42717 , F 128, S 8, H B 344116, I/A 28
01
Ago 2016
Con fecha 01/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Medina Miguel Maria Elena |
Datos registrales: T 42717 , F 128, S 8, H B 344116, I/A 28
13
Jul 2016
Con fecha 13/07/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PERIODICIDAD Y CONVOCATORIA DE LA JUNTA.
Datos registrales: T 42717 , F 126, S 8, H B 344116, I/A 27
13
Jul 2016
Con fecha 13/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
PRESIDENTE | Salengoa SL |
REPR.143 RRM | Rafel Miarnau Ignacio |
PRESIDENTE | Nueva Caja Rural De Aragon Sociedad Cooperativa De |
REPR.143 RRM | Medina Miguel Maria Elena |
PRESIDENTE | Limaskoa SL |
PRESIDENTE | Invermatillas SL |
PRESIDENTE | Inmobiliaria Atazar SA |
PRESIDENTE | Gesnostrum Sociedad Gestora SL |
PRESIDENTE | Elegasa SL |
PRESIDENTE | Edificios Patrimoniales SA |
PRESIDENTE | Charent SL |
Datos registrales: T 42717 , F 126, S 8, H B 344116, I/A 27
13
Jul 2016
Con fecha 13/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
V-SEC NO CON | Pedrosa Negrete Eduardo |
REPR.143 RRM | Medina Miguel Maria Elena |
CONSEJERO | Invernostra SL |
Datos registrales: T 42717 , F 126, S 8, H B 344116, I/A 27
13
Jul 2016
Con fecha 13/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Puyalto Lucindo Marcos |
SECR.NO CONS | Martin Martin Marta |
Datos registrales: T 42717 , F 126, S 8, H B 344116, I/A 26
13
Jul 2016
Con fecha 13/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Moliner Burrel Alejandro |
SECR.NO CONS | Azinovic Gamo Ivan |
Datos registrales: T 42717 , F 126, S 8, H B 344116, I/A 26
13
Jul 2016
Reducción de capital
Datos registrales: T 42717 , F 125, S 8, H B 344116, I/A 25
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2019-29-08 | Barcelona | 12/02/2019 | |
BORME-A-2018-210-08 | Barcelona | 31/10/2018 | |
BORME-A-2018-209-08 | Barcelona | 30/10/2018 | |
BORME-A-2018-56-08 | Barcelona | 20/03/2018 | |
BORME-A-2017-86-08 | Barcelona | 09/05/2017 | |
BORME-A-2017-83-08 | Barcelona | 04/05/2017 | |
BORME-A-2017-21-08 | Barcelona | 31/01/2017 | |
BORME-A-2016-151-08 | Barcelona | 09/08/2016 | |
BORME-A-2016-141-08 | Barcelona | 26/07/2016 | |
BORME-A-2015-188-08 | Barcelona | 01/10/2015 | |
BORME-A-2015-135-08 | Barcelona | 20/07/2015 | |
BORME-A-2013-173-08 | Barcelona | 11/09/2013 | |
BORME-A-2012-22-08 | Barcelona | 01/02/2012 | |
BORME-A-2011-223-28 | Madrid | 24/11/2011 | |
BORME-A-2011-134-08 | Barcelona | 14/07/2011 | |
BORME-A-2011-69-08 | Barcelona | 08/04/2011 | |
BORME-A-2010-40-08 | Barcelona | 01/03/2010 | |
BORME-A-2010-32-08 | Barcelona | 17/02/2010 | |
BORME-A-2010-4-08 | Barcelona | 08/01/2010 | |
BORME-A-2009-227-08 | Barcelona | 27/11/2009 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades