info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 0
Cargos no vigentes 8
Apariciones en BORME 15
Cargos directivos en empresas
Esta persona no tiene ningún cargo en la actualidad, o no hay datos disponibles.
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
APOD.MANCOMU Legar Developments SL 16/10/2013 22/02/2017
APOD.MANCOMU Cargill Aquafeed Spain SL 16/09/2015 21/02/2017
APOD.MANCOMU Cargill Spain International Holdings SL 16/10/2013 09/11/2016
APOD.MANCOMU Cargill SL 18/10/2013 09/11/2016
APOD.MANCOMU Cargill Costanera SL 08/09/2014 09/11/2016
APOD.MANCOMU Cargill Central American Holdings SL 16/10/2013 09/11/2016
APOD.MANCOMU Cargill Andina SL 08/09/2014 09/11/2016
APOD.MANCOMU Cargill Oil Packers SL 17/10/2013 03/04/2014
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Stuart Wayne Spoor .

21

Feb 2017

Revocaciones

Con fecha 21/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Yvonne Margaret Florence Pugh
APOD.MANCOMU Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Michael David Freeman
APOD.MANCOMU Matthew James Allit
APOD.MANCOMU Mateo Alujas Jose Maria
APOD.MANCOMU Catherine Mary Johnston

PDF Anuncio nº 98065 de 2017

Datos registrales: T 45188 , F 216, S 8, H B 471539, I/A 14

22

Feb 2017

Revocaciones

Con fecha 22/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Yvonne Margaret Florence Pugh
APODERADO Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Michael David Freeman
APOD.MANCOMU Matthew James Allit
APODERADO Magam Al Khadi
APODERADO Catherine Mary Johnston

PDF Anuncio nº 98004 de 2017

Datos registrales: T 44152 , F 115, S 8, H B 267585, I/A 32

09

Nov 2016

Revocaciones

Con fecha 09/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Yvonne Margaret Florence Pugh
APODERADO Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Michael David Freeman
APODERADO Maña Bove Alexandre
APOD.MANCOMU Matthew James Allit
APODERADO Mateo Alujas Jose Maria
APODERADO Lopez Navarro Antonia Josefa
APODERADO Catherine Mary Johnston

PDF Anuncio nº 460843 de 2016

Datos registrales: T 45344 , F 183, S 8, H B 232881, I/A 267

09

Nov 2016

Revocaciones

Con fecha 09/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Yvonne Margaret Florence Pugh
APOD.MANCOMU Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Michael David Freeman
APOD.MANCOMU Matthew James Allit
APOD.SOL/MAN Mateo Alujas Jose Maria
APOD.MANCOMU Catherine Mary Johnston

PDF Anuncio nº 460839 de 2016

Datos registrales: T 45348 , F 21, S 8, H B 456086, I/A 15

09

Nov 2016

Revocaciones

Con fecha 09/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Yvonne Margaret Florence Pugh
APOD.MANCOMU Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Michael David Freeman
APOD.MANCOMU Matthew James Allit
APODERAD.SOL Mateo Alujas Jose Maria
APOD.MANCOMU Catherine Mary Johnston

PDF Anuncio nº 460837 de 2016

Datos registrales: T 45352 , F 81, S 8, H B 456096, I/A 15

09

Nov 2016

Revocaciones

Con fecha 09/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Yvonne Margaret Florence Pugh
APODERADO Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Michael David Freeman
APOD.MANCOMU Matthew James Allit
APODERADO Mateo Alujas Jose Maria
APODERADO Catherine Mary Johnston

PDF Anuncio nº 460833 de 2016

Datos registrales: T 44446 , F 23, S 8, H B 417284, I/A 21

09

Nov 2016

Revocaciones

Con fecha 09/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Yvonne Margaret Florence Pugh
APODERADO Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Michael David Freeman
APOD.MANCOMU Matthew James Allit
APODERADO Mateo Alujas Jose Maria
APODERADO Catherine Mary Johnston

PDF Anuncio nº 460823 de 2016

Datos registrales: T 44805 , F 142, S 8, H B 418932, I/A 19

16

Sep 2015

Nombramientos

Con fecha 16/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Yvonne Margaret Florence Pugh
APOD.MANCOMU Udit Ashwin Vora
APOD.MANCOMU Tracey Anne Brazier
APOD.MANCOMU Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Rachael Louise Johnson
APOD.MANCOMU Nicola Louise Coughlan
APOD.MANCOMU Nicholas Carter
APOD.MANCOMU Nagam Al Khadi
APOD.MANCOMU Michael David Freeman
APOD.MANCOMU Matthew James Allit
APOD.MANCOMU Marie Higgins
APOD.MANCOMU Elizabeth Jane Eastgate
APOD.MANCOMU David Michael Collings
APOD.MANCOMU David Collins
APOD.MANCOMU Catherine Mary Johnston
APOD.MANCOMU Alison Mulhollan

PDF Anuncio nº 384220 de 2015

Datos registrales: T 44926 , F 178, S 8, H B 471539, I/A 5

08

Sep 2014

Nombramientos

Con fecha 08/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Yvonne Margaret Florence Pugh
APOD.MANCOMU Tracey Anne Brazier
APOD.MANCOMU Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Stuart James Rich
APOD.MANCOMU Nicola Louise Coughlan
APOD.MANCOMU Nicholas Carter
APOD.MANCOMU Nagam Al Khadi
APOD.MANCOMU Marie Higgins
APOD.MANCOMU Lynda Diane Lane
APOD.MANCOMU Grazyna Przybyla Rossetti
APOD.MANCOMU Frederique Fillon
APOD.MANCOMU David Collins
APOD.MANCOMU Catherine Mary Johnston
APOD.MANCOMU Catherine Anne Alston
APOD.MANCOMU Alison Mulhollan

PDF Anuncio nº 370986 de 2014

Datos registrales: T 44439 , F 118, S 8, H B 456096, I/A 6

08

Sep 2014

Nombramientos

Con fecha 08/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Yvonne Margaret Florence Pugh
APOD.MANCOMU Tracey Anne Brazier
APOD.MANCOMU Susan Liley
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Stuart James Rich
APOD.MANCOMU Nicola Louise Coughlan
APOD.MANCOMU Nicholas Carter
APOD.MANCOMU Nagam Al Khadi
APOD.MANCOMU Marie Higgins
APOD.MANCOMU Lynda Diane Lane
APOD.MANCOMU Grazyna Przybyla Rossetti
APOD.MANCOMU Frederique Fillon
APOD.MANCOMU David Collins
APOD.MANCOMU Catherine Mary Johnston
APOD.MANCOMU Catherine Anne Alston
APOD.MANCOMU Alison Mulhollan

PDF Anuncio nº 370892 de 2014

Datos registrales: T 44439 , F 53, S 8, H B 456086, I/A 6

18

Oct 2013

Nombramientos

Con fecha 18/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Lynda Diane Lane

PDF Anuncio nº 456962 de 2013

Datos registrales: T 40995 , F 93, S 8, H B 232881, I/A 203

17

Oct 2013

Nombramientos

Con fecha 17/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Lynda Diane Lane

PDF Anuncio nº 455497 de 2013

Datos registrales: T 43000 , F 4, S 8, H B 177237, I/A 83

16

Oct 2013

Nombramientos

Con fecha 16/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Lynda Diane Lane

PDF Anuncio nº 452790 de 2013

Datos registrales: T 35829 , F 59, S 8, H B 267585, I/A 20

16

Oct 2013

Nombramientos

Con fecha 16/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Lynda Diane Lane

PDF Anuncio nº 452786 de 2013

Datos registrales: T 43039 , F 99, S 8, H B 418932, I/A 9

16

Oct 2013

Nombramientos

Con fecha 16/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Stuart Wayne Spoor
APOD.MANCOMU Lynda Diane Lane

PDF Anuncio nº 452584 de 2013

Datos registrales: T 42984 , F 183, S 8, H B 417284, I/A 11

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2017-42-08 Barcelona 01/03/2017
PDF BORME-A-2016-218-08 Barcelona 16/11/2016
PDF BORME-A-2015-182-08 Barcelona 23/09/2015
PDF BORME-A-2014-178-08 Barcelona 18/09/2014
PDF BORME-A-2013-205-08 Barcelona 25/10/2013
PDF BORME-A-2013-204-08 Barcelona 24/10/2013
PDF BORME-A-2013-203-08 Barcelona 23/10/2013

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret