Última actualización: 12 de Agosto de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 0 |
---|---|
Cargos no vigentes | 7 |
Apariciones en BORME | 8 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Karen Millen Spain SL | 18/12/2013 | 08/04/2022 |
Apo.Manc. | Karen Millen Spain SL | 12/11/2013 | 12/08/2020 |
Apo.Man.Soli | Karen Millen Spain SL | 12/11/2013 | 12/08/2020 |
Presidente | Karen Millen Spain SL | 12/11/2013 | 13/03/2020 |
Consejero | Karen Millen Spain SL | 12/11/2013 | 13/03/2020 |
Apoderado | Karen Millen Spain SL | 24/09/2009 | 16/12/2011 |
Consejero | K.M. Spain Retail SL | 10/03/2009 | 11/03/2010 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Shearwood Michael .
12
Ago 2020
Con fecha 12/08/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Shearwood Michael |
Datos registrales: T 30253 , F 113, S 8, H M 357285, I/A 29
13
Mar 2020
Con fecha 13/03/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Shearwood Michael |
Consejero | Metheringham Gemma |
SecreNoConsj | Heatons Secretaries LTD |
VsecrNoConsj | Gustafson Gomez John R |
Representan | Christy Truscott James |
Consejero | Arthur Ware Andrew John |
Datos registrales: T 30253 , F 111, S 8, H M 357285, I/A 24
18
Dic 2013
Con fecha 18/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Sutherland Robinson Christopher Michael |
Apo.Sol. | Shearwood Michael |
Apo.Sol. | Metheringham Gemma |
Apo.Manc. | Mary Green Elaine |
Apo.Manc. | Lacave Del Polo Pilar |
Apo.Manc. | Je-Anne Winters Gail |
Apo.Manc. | Helen Fitzgerald Lewis Rebecca |
Apo.Manc. | Griffiths Robert John |
Apo.Manc. | Galdeano Bonel Gemma |
Apo.Manc. | Faulkner Sarah Jane |
Apo.Manc. | Elizabeth Thomas Laura |
Apo.Sol. | Elizabeth Marshall Joanne |
Apo.Manc. | Dear Emily Sarah |
Apo.Sol. | Arthur Ware Andrew John |
Apo.Manc. | Aamar Mirza Mohammed |
Datos registrales: T 30253 , F 109, S 8, H M 357285, I/A 20
12
Nov 2013
Con fecha 12/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Sutherland Robinson Christopher Michael |
Presidente | Shearwood Michael |
Apo.Manc. | Metheringham Gemma |
Apo.Manc. | Mary Green Elaine |
Apo.Manc. | Je-Anne Winters Gail |
Apo.Manc. | Jane Plummer Helen |
Apo.Manc. | Helen Fitzgerald Lewis Rebecca |
Apo.Manc. | Griffiths Robert John |
Apoderado | Galdeano Bonel Gemma |
Apo.Manc. | Elizabeth Thomas Laura |
Apo.Manc. | Elizabeth Marshall Joanne |
Apo.Man.Soli | Arthur Ware Andrew John |
Apo.Manc. | Aamar Mirza Mohammed |
Datos registrales: T 30253 , F 106, S 8, H M 357285, I/A 19
16
Dic 2011
Con fecha 16/12/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sherwood Michael |
Apoderado | Shearwood Michael |
Apoderado | Lustman Margaret Eve |
Apoderado | Glanville Richard Spencer |
Datos registrales: T 20222 , F 176, S 8, H M 357285, I/A 13
11
Mar 2010
Con fecha 11/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Wilks Jessica Louise |
Consejero | Shearwood Michael |
Consejero | Lustman Margaret Eve |
Presidente | Lovelock Derek John |
VsecrNoConsj | Gustafson Gomez John R |
Vicepresid. | Glanville Richard Spencer |
Datos registrales: T 26496 , F 193, S 8, H M 477471, I/A 3
24
Sep 2009
Con fecha 24/09/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tehan Patrick Kieran |
Apoderado | Shearwood Michael |
Apoderado | Lustman Margaret Eve |
Apoderado | Lovelock Derek John |
Apoderado | Jeffery Paul James |
Apoderado | Hobin Mairead Theresa |
Apoderado | Griffiths Robert |
Apoderado | Glanville Richard Spencer |
Apoderado | Bywaters Marion |
Apoderado | Britton Sally Anne |
Datos registrales: T 20222 , F 173, S 8, H M 357285, I/A 7
10
Mar 2009
Con fecha 10/03/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Shearwood Michael |
Consejero | Lustman Margaret Eve |
Consejero | Lovelock Derek John |
Consejero | Glanville Richard Spencer |
Datos registrales: T 26496 , F 187, S 8, H M 477471, I/A 1
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2020-160-28 | Madrid | 19/08/2020 |
BORME-A-2020-56-28 | Madrid | 20/03/2020 |
BORME-A-2013-246-28 | Madrid | 26/12/2013 |
BORME-A-2013-222-28 | Madrid | 20/11/2013 |
BORME-A-2011-245-28 | Madrid | 28/12/2011 |
BORME-A-2010-57-28 | Madrid | 25/03/2010 |
BORME-A-2009-191-28 | Madrid | 06/10/2009 |
BORME-A-2009-54-28 | Madrid | 20/03/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades