info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 8
Cargos no vigentes 2
Apariciones en BORME 11
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Sol. Geoxyz Spain SL 20/09/2023 Actualidad
Apo.Sol. Falck Sci SA 01/12/2022 Actualidad
Apoderado Sorte Renova SL 08/06/2021 Actualidad
Apo.Sol. Freitag Living SL 04/12/2020 Actualidad
Apo.Sol. Avramar Seafood SL 15/10/2019 Actualidad
Apo.Sol. Gymcol China Investments SL 06/08/2018 Actualidad
APODERAD.SOL Joebstl Logistics Spain SL 18/09/2013 Actualidad
APODERADO Z Recreational Spain SL 03/06/2013 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Sol. Eines Systems SL 31/10/2019 18/06/2020
Apoderado Uti Iberia SL 08/07/2015 17/02/2017
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Sanchis Bas Angela .

20

Sep 2023

Nombramientos

Con fecha 20/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Sanchis Bas Angela
Apo.Sol. Guillen Ferrer Maria Jose

PDF Anuncio nº 416629 de 2023

Datos registrales: T 11401, L 8679, F 37, S 8, H V 211914, I/A 2

01

Dic 2022

Nombramientos

Con fecha 01/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Sanchis Bas Angela
Apo.Sol. Ramon Contreras Alejandro
Apo.Sol. Masana Preciado Pau
Secretario Franca Pinto Joao
Apo.Sol. Cubel Sanchez Pablo German
Apo.Sol. Cuatrecasas Gimenez-Salinas Elena

PDF Anuncio nº 543175 de 2022

Datos registrales: T 6112, L 3418, F 225, S 8, H V 6998, I/A 81

08

Jun 2021

Nombramientos

Con fecha 08/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Sanchis Bas Angela
Apoderado Guillen Ferrer Maria Jose
Apoderado Gombau Rius Roland
Apoderado Goerlich Buch Carla

PDF Anuncio nº 289796 de 2021

Datos registrales: T 41048 , F 91, S 8, H M 727973, I/A 2

04

Dic 2020

Nombramientos

Con fecha 04/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Sanchis Bas Angela
Apo.Sol. Martinez Moreno Paula
Apo.Sol. Guillen Ferrer Maria Jose

PDF Anuncio nº 439788 de 2020

Datos registrales: T 4096 , F 208, S 8, H A 158510, I/A 3

18

Jun 2020

Revocaciones

Con fecha 18/06/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Sanchis Bas Angela
Apo.Sol. Galbis Fuster Beatriz
Apo.Sol. Dekker Vicens Daniel
Apo.Sol. Alcacer Yuste Pilar

PDF Anuncio nº 195121 de 2020

Datos registrales: T 8316, L 5607, F 12, S 8, H V 109199, I/A 8

31

Oct 2019

Nombramientos

Con fecha 31/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Sanchis Bas Angela
Apo.Sol. Galbis Fuster Beatriz
Apo.Sol. Dekker Vicens Daniel
Apo.Sol. Alcacer Yuste Pilar

PDF Anuncio nº 463342 de 2019

Datos registrales: T 8316, L 5607, F 12, S 8, H V 109199, I/A 7

15

Oct 2019

Nombramientos

Con fecha 15/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Sanchis Bas Angela
Apo.Sol. Galbis Fuster Beatriz
Apo.Sol. Dekker Vicens Daniel
Apo.Sol. Alcacer Yuste Pilar

PDF Anuncio nº 441402 de 2019

Datos registrales: T 1787, L 1348, F 114, S 8, H CS 42117, I/A 5

06

Ago 2018

Nombramientos

Con fecha 06/08/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Sanchis Bas Angela
Apo.Sol. Guillen Ferrer Maria Jose
Apo.Sol. Furest Santamaria Maria

PDF Anuncio nº 336324 de 2018

Datos registrales: T 8229, L 5521, F 72, S 8, H V 106380, I/A 13

08

Jul 2015

Nombramientos

Con fecha 08/07/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Sanchis Bas Angela
Apoderado Guillen Ferrer Maria Jose
Apoderado Casp Mascarell Xavier

PDF Anuncio nº 292649 de 2015

Datos registrales: T 29508 , F 67, S 8, H M 295091, I/A 48

18

Sep 2013

Nombramientos

Con fecha 18/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERAD.SOL Sanchis Bas Angela
APODERAD.SOL Moya Latorre Andrea
APODERAD.SOL Guillen Ferrer Maria Jose
APODERAD.SOL Gregor Erlebach

PDF Anuncio nº 414901 de 2013

Datos registrales: T 43465 , F 111, S 8, H B 92986, I/A 23

03

Jun 2013

Nombramientos

Con fecha 03/06/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Sanchis Bas Angela
APODERADO Guillen Ferrer Maria Jose
APODERADO Domenech Martinez Hugo

PDF Anuncio nº 266605 de 2013

Datos registrales: T 43350 , F 52, S 8, H B 426227, I/A 6

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2023-185-46 Valencia 27/09/2023
PDF BORME-A-2022-234-46 Valencia 12/12/2022
PDF BORME-A-2021-112-28 Madrid 15/06/2021
PDF BORME-A-2020-239-03 Alicante 15/12/2020
PDF BORME-A-2020-121-46 Valencia 25/06/2020
PDF BORME-A-2019-215-46 Valencia 08/11/2019
PDF BORME-A-2019-205-12 Castellón 24/10/2019
PDF BORME-A-2018-155-46 Valencia 13/08/2018
PDF BORME-A-2015-133-28 Madrid 16/07/2015
PDF BORME-A-2013-185-08 Barcelona 27/09/2013
PDF BORME-A-2013-108-08 Barcelona 11/06/2013

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret