Última actualización: 15 de Junio de 2016
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 0 |
---|---|
Cargos no vigentes | 9 |
Apariciones en BORME | 13 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Presidente | Coast Fashions Spain SL | 12/06/2013 | 15/06/2016 |
Consejero | Coast Fashions Spain SL | 24/09/2012 | 15/06/2016 |
Apoderado | Coast Fashions Spain SL | 12/06/2013 | 15/06/2016 |
Presidente | Karen Millen Spain SL | 16/12/2011 | 12/11/2013 |
Consejero | Karen Millen Spain SL | 15/04/2009 | 12/11/2013 |
Apoderado | Karen Millen Spain SL | 24/09/2009 | 12/11/2013 |
Apo.Man.Soli | Karen Millen Spain SL | 15/04/2009 | 12/11/2013 |
Presidente | K.M. Spain Retail SL | 01/04/2009 | 11/03/2010 |
Consejero | K.M. Spain Retail SL | 10/03/2009 | 11/03/2010 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Lovelock Derek John .
15
Jun 2016
Con fecha 15/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lovelock Derek John |
Datos registrales: T 30204 , F 140, S 8, H M 543694, I/A 7
15
Jun 2016
Con fecha 15/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mcdonald Margaret |
Consejero | Lovelock Derek John |
VsecrNoConsj | Gustafson Gomez John R |
Consejero | Glanville Richard Spencer |
Datos registrales: T 30204 , F 140, S 8, H M 543694, I/A 6
12
Nov 2013
Con fecha 12/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tehan Patrick Kieran |
Apo.Man.Soli | Soufipour Sanam |
Apo.Man.Soli | Price Steven |
Apo.Man.Soli | Metheringham Gemma |
Apoderado | Lovelock Derek John |
Apo.Man.Soli | Lauga Philippe |
Apoderado | Jeffery Paul James |
Apoderado | Hobin Mairead Theresa |
Apoderado | Griffiths Robert |
Apo.Man.Soli | Capp Sarah Jane |
Apoderado | Bywaters Marion |
Apoderado | Britton Sally Anne |
Datos registrales: T 30253 , F 106, S 8, H M 357285, I/A 19
12
Nov 2013
Con fecha 12/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Soufipour Sanam |
Consejero | Price Steven |
Presidente | Lovelock Derek John |
Datos registrales: T 30253 , F 106, S 8, H M 357285, I/A 19
12
Jun 2013
Con fecha 12/06/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mcdonald Margaret |
Presidente | Lovelock Derek John |
VsecrNoConsj | Gustafson Gomez John R |
Consejero | Glanville Richard Spencer |
Datos registrales: T 30204 , F 136, S 8, H M 543694, I/A 2
24
Sep 2012
Con fecha 24/09/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Soufipour Sanam |
Consejero | Price Stephen |
Consejero | Metheringham Gemma |
Consejero | Lovelock Derek John |
Datos registrales: T 30204 , F 125, S 8, H M 543694, I/A 1
16
Dic 2011
Con fecha 16/12/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Soufipour Sanam |
Apo.Man.Soli | Price Steven |
Apo.Man.Soli | Metheringham Gemma |
Presidente | Lovelock Derek John |
Apo.Man.Soli | Lauga Philippe |
Apoderado | Badia Merino Pablo |
Datos registrales: T 20222 , F 176, S 8, H M 357285, I/A 13
11
Mar 2010
Con fecha 11/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Wilks Jessica Louise |
Consejero | Shearwood Michael |
Consejero | Lustman Margaret Eve |
Presidente | Lovelock Derek John |
VsecrNoConsj | Gustafson Gomez John R |
Vicepresid. | Glanville Richard Spencer |
Datos registrales: T 26496 , F 193, S 8, H M 477471, I/A 3
24
Sep 2009
Con fecha 24/09/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tehan Patrick Kieran |
Apoderado | Shearwood Michael |
Apoderado | Lustman Margaret Eve |
Apoderado | Lovelock Derek John |
Apoderado | Jeffery Paul James |
Apoderado | Hobin Mairead Theresa |
Apoderado | Griffiths Robert |
Apoderado | Glanville Richard Spencer |
Apoderado | Bywaters Marion |
Apoderado | Britton Sally Anne |
Datos registrales: T 20222 , F 173, S 8, H M 357285, I/A 7
15
Abr 2009
Con fecha 15/04/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sherwood Michael |
Apo.Man.Soli | Sharma Sanjib |
Apo.Man.Soli | Lustman Margaret Eve |
Apo.Man.Soli | Lovelock Derek John |
Apo.Man.Soli | Glanville Richard Spencer |
Apo.Man.Soli | Capp Sarah Jane |
Datos registrales: T 20222 , F 171, S 8, H M 357285, I/A 5
15
Abr 2009
Con fecha 15/04/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Wilks Jessica Louise |
Consejero | Sherwood Michael |
Consejero | Lustman Margaret Eve |
Consejero | Lovelock Derek John |
Presidente | Lovelock Dereck John |
VsecrNoConsj | Gustafson Gomez John R |
Consejero | Glanville Richard Spencer |
Datos registrales: T 20222 , F 170, S 8, H M 357285, I/A 4
01
Abr 2009
Con fecha 01/04/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Wilks Jessica Louise |
Apoderado | Sherwood Michael |
Apoderado | Sharma Sanjib |
Apoderado | Lustman Margaret Eve |
Presidente | Lovelock Derek John |
Apoderado | Lovelock Dereck John |
VsecrNoConsj | Gustafson Gomez John R |
Vicepresid. | Glanville Richard Spencer |
Apoderado | Capp Sarah Jane |
Datos registrales: T 26496 , F 191, S 8, H M 477471, I/A 2
10
Mar 2009
Con fecha 10/03/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Shearwood Michael |
Consejero | Lustman Margaret Eve |
Consejero | Lovelock Derek John |
Consejero | Glanville Richard Spencer |
Datos registrales: T 26496 , F 187, S 8, H M 477471, I/A 1
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2016-118-28 | Madrid | 22/06/2016 |
BORME-A-2013-222-28 | Madrid | 20/11/2013 |
BORME-A-2013-115-28 | Madrid | 20/06/2013 |
BORME-A-2012-194-28 | Madrid | 08/10/2012 |
BORME-A-2011-245-28 | Madrid | 28/12/2011 |
BORME-A-2010-57-28 | Madrid | 25/03/2010 |
BORME-A-2009-191-28 | Madrid | 06/10/2009 |
BORME-A-2009-78-28 | Madrid | 27/04/2009 |
BORME-A-2009-70-28 | Madrid | 15/04/2009 |
BORME-A-2009-54-28 | Madrid | 20/03/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades