info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 1
Cargos no vigentes 7
Apariciones en BORME 10
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Sol. Aktua Soluciones Financieras Holdings SL 15/04/2013 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Presidente Propco Boxes 2 SL 08/05/2013 04/11/2020
Consejero Propco Boxes 2 SL 08/05/2013 04/11/2020
Presidente Real Estate Ventures Spain SL 30/10/2013 28/05/2018
Consejero Real Estate Ventures Spain SL 30/10/2013 28/05/2018
Consejero Aktua Soluciones Financieras SL 09/04/2013 05/08/2016
Consejero Aktua Soluciones Financieras Holdings SL 10/12/2012 05/08/2016
Secretario Aktua Soluciones Financieras Holdings SL 10/12/2012 05/01/2013
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Langworthy Ben Carlton .

04

Nov 2020

Ceses/Dimisiones

Con fecha 04/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Presidente Langworthy Ben Carlton
Consejero Kopstein Todd Everett
Consejero Kabaker Matthew Stephen
SecreNoConsj Garrigues Calderon Belen

PDF Anuncio nº 389413 de 2020

Datos registrales: T 30885 , F 222, S 8, H M 555886, I/A 14

28

May 2018

Ceses/Dimisiones

Con fecha 28/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Vicesecret. Montalvo De Marcos Diego
Consejero Langworthy Ben Carlton
Consejero Kopstein Todd Everet
Consejero Kabaker Matthew Stephen
SecreNoConsj Fernandez Santos Luis

PDF Anuncio nº 238155 de 2018

Datos registrales: T 34405 , F 27, S 8, H M 474915, I/A 59

05

Ago 2016

Ceses/Dimisiones

Con fecha 05/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero West Lance Nevin
Consejero The Mortgage Opportunity Group Lcc
Consejero Terol Esteban Alberto
SecreNoConsj Sotomayor Aparicio Barbara
Representan Libman Brian Lewis
Consejero Langworthy Ben Carlton
Consejero Kabaker Matthew Stephen
Consejero Altamar Fund Services SL
Representan Aguirre Peman Claudio

PDF Anuncio nº 337809 de 2016

Datos registrales: T 30235 , F 218, S 8, H M 544202, I/A 27

05

Ago 2016

Ceses/Dimisiones

Con fecha 05/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero West Lance Nevin
Consejero The Mortgage Opportunity Group LLC
Consejero Terol Esteban Alberto
SecreNoConsj Sotomayor Aparicio Barbara
Representan Libman Brian Lewis
Consejero Langworthy Ben Carlton
Consejero Kabaker Matthew Stephen
Consejero Altamar Fund Services SL
Representan Aguirre Peman Claudio

PDF Anuncio nº 337768 de 2016

Datos registrales: T 34661 , F 61, S 8, H M 431049, I/A 111

30

Oct 2013

Nombramientos

Con fecha 30/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
SecreNoConsj Manchado Calderon Victoriano Jose
VsecrNoConsj Livesey John Vincent
Consejero Langworthy Ben Carlton
Consejero Kopstein Todd Everet
Consejero Kabaker Matthew Stephen
VsecrNoConsj De Vicente Rabanal Santiago

PDF Anuncio nº 477543 de 2013

Datos registrales: T 28900 , F 155, S 8, H M 474915, I/A 26

08

May 2013

Nombramientos

Con fecha 08/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero West Lance Nevin
SecreNoConsj Manchado Calderon Victoriano Jose
VsecrNoConsj Lopez San Claudio Jose Maria
Presidente Langworthy Ben Carlton
Consejero Kabaker Matthew Stephen
VsecrNoConsj De Vicente Rabanal Santiago

PDF Anuncio nº 225400 de 2013

Datos registrales: T 30885 , F 181, S 8, H M 555886, I/A 2

15

Abr 2013

Nombramientos

Con fecha 15/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Patterson Brian
Apo.Sol. Lerena Sierra Lara
Apo.Sol. Langworthy Ben Carlton
Apo.Sol. Kabaker Matthew Stephen
Apo.Sol. Garcia Fernandez Olga
Apo.Sol. Epstein Michael
Apo.Sol. Enciso Lopez Pablo
Apo.Sol. Boris Daniel Alan

PDF Anuncio nº 189337 de 2013

Datos registrales: T 30235 , F 200, S 8, H M 544202, I/A 8

09

Abr 2013

Nombramientos

Con fecha 09/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero West Lance Nevin
Consejero Terol Esteban Alberto
Consejero Quintana Gonzalez Eduardo
Consejero Langworthy Ben Carlton
Consejero Kabaker Matthew Stephen
SecreNoConsj Diez San Millan Lucia
Consejero Aguirre Peman Claudio

PDF Anuncio nº 181370 de 2013

Datos registrales: T 30329 , F 83, S 8, H M 431049, I/A 35

05

Ene 2013

Ceses/Dimisiones

Con fecha 05/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Secretario Langworthy Ben Carlton

PDF Anuncio nº 26439 de 2013

Datos registrales: T 30235 , F 174, S 8, H M 544202, I/A 6

10

Dic 2012

Nombramientos

Con fecha 10/12/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Presidente West Lance Nevin
Consejero Langworthy Ben Carlton
Consejero Kabaker Matthew Stephen

PDF Anuncio nº 523115 de 2012

Datos registrales: T 30235 , F 169, S 8, H M 544202, I/A 4

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2020-218-28 Madrid 12/11/2020
PDF BORME-A-2018-107-28 Madrid 06/06/2018
PDF BORME-A-2016-155-28 Madrid 16/08/2016
PDF BORME-A-2013-214-28 Madrid 08/11/2013
PDF BORME-A-2013-91-28 Madrid 17/05/2013
PDF BORME-A-2013-75-28 Madrid 22/04/2013
PDF BORME-A-2013-72-28 Madrid 17/04/2013
PDF BORME-A-2013-12-28 Madrid 18/01/2013
PDF BORME-A-2012-240-28 Madrid 17/12/2012

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret