info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 12
Cargos no vigentes 8
Apariciones en BORME 25
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Miem.Com.Ctr Bbva Colectivos Dos FP 15/11/2022 Actualidad
APODERAD.SOL Eco3 BV 26/10/2021 Actualidad
Apo.Sol. Banco Santander SA 03/06/2021 Actualidad
APODERAD.SOL Agfa NV 14/01/2019 Actualidad
Miem.Com.Ctr Bbva Colectivos Dos FP 18/06/2018 Actualidad
APOD.SOL/MAN Agfa Healthcare Spain SA 04/08/2016 Actualidad
Miem.Com.Ctr Bbva Colectivos Dos FP 23/10/2015 Actualidad
Miem.Com.Ctr Bbva Colectivos Dos FP 23/10/2015 Actualidad
Apo.Manc. Banco Santander SA 10/08/2015 Actualidad
Adm. Unico Estructuras Y Contratas Del Levante SL 26/12/2014 Actualidad
APOD.SOL/MAN Agfa Healthcare Spain SA 07/08/2014 Actualidad
Apo.Man.Soli Banco Santander SA 22/04/2013 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
REPR.SUCURS. Agfa NV 20/12/2021 04/03/2024
LIQUIDADOR Ipagsa Technologies SL 30/05/2022 04/01/2023
APODERAD.SOL Agfa NV 10/02/2015 17/06/2021
APOD.SOL/MAN Agfa NV 17/04/2014 17/06/2021
Miem.Com.Ctr Bbva Colectivos Dos FP 23/10/2015 07/06/2019
APODERADO Agfa Healthcare Spain SA 27/09/2012 04/08/2016
APODERADO Agfa Healthcare Spain SA 10/05/2012 27/09/2012
APODERADO Agfa Healthcare Spain SA Desconocido 10/05/2012
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Garcia Diez Rafael .

04

Mar 2024

Revocaciones

Con fecha 04/03/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
REPR.SUCURS. Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 122301 de 2024

Datos registrales: T 48094 , F 124, S 8, H B 426150, I/A 45

04

Ene 2023

Revocaciones

Con fecha 04/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
LIQUIDADOR Pieter Van Biervliet
LIQUIDADOR Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 18822 de 2023

Datos registrales: T 46754 , F 160, S 8, H B 522050, I/A 18

15

Nov 2022

Nombramientos

Con fecha 15/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Miem.Com.Ctr Rodriguez Vico Jose Antonio
Miem.Com.Ctr Ordeix Diaz Cati
Miem.Com.Ctr Masip I Perello Antonia
Miem.Com.Ctr Garcia Diez Rafael
Miem.Com.Ctr De Carolis Maria Alejandrina

PDF Anuncio nº 510539 de 2022

Datos registrales: T 38032 , F 169, S 8, H M 314168, I/A 46

30

May 2022

Nombramientos

Con fecha 30/05/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
LIQUIDADOR Pieter Van Biervliet
LIQUIDADOR Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 260302 de 2022

Datos registrales: T 46754 , F 158, S 8, H B 522050, I/A 15

20

Dic 2021

Nombramientos

Con fecha 20/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
REPR.SUCURS. Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 562999 de 2021

Datos registrales: T 43265 , F 199, S 8, H B 426150, I/A 38

26

Oct 2021

Nombramientos

Con fecha 26/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERAD.SOL Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 480740 de 2021

Datos registrales: T 47959 , F 30, S 8, H B 567536, I/A 4

17

Jun 2021

Revocaciones

Con fecha 17/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Muñoz Moreno Pedro
APOD.SOL/MAN John Roy Newland
APODERADO Izquierdo Gomez Jose Andres
APODERAD.SOL Garcia Diez Rafael
APODERAD.SOL Artola Vernedas Angel
APODERADO Alsina Alarcon Jaume

PDF Anuncio nº 310164 de 2021

Datos registrales: T 43265 , F 199, S 8, H B 426150, I/A 37

03

Jun 2021

Nombramientos

Con fecha 03/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 26 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 283846 de 2021

Datos registrales: T 1242 , F 102, S 8, H S 1960, I/A 4284

07

Jun 2019

Ceses/Dimisiones

Con fecha 07/06/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Miem.Com.Ctr Salla Mateu Pau
Miem.Com.Ctr Garcia Diez Rafael
Miem.Com.Ctr Alsina Alarcon Jaume

PDF Anuncio nº 258951 de 2019

Datos registrales: T 38032 , F 160, S 8, H M 314168, I/A 36

14

Ene 2019

Nombramientos

Con fecha 14/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERAD.SOL Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 28699 de 2019

Datos registrales: T 43265 , F 194, S 8, H B 426150, I/A 29

18

Jun 2018

Reelecciones

Con fecha 18/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Miem.Com.Ctr Vall Escala Roger
Miem.Com.Ctr Salla Mateu Pau
Miem.Com.Ctr Nieblas Becerra Juan
Miem.Com.Ctr Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 267145 de 2018

Datos registrales: T 26045 , F 24, S 8, H M 314168, I/A 33

04

Ago 2016

Nombramientos

Con fecha 04/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.SOL/MAN Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 335644 de 2016

Datos registrales: T 44429 , F 113, S 8, H B 352505, I/A 53

04

Ago 2016

Revocaciones

Con fecha 04/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Sanchez Hernandez Jose
APODERAD.SOL Puig Cabrelles Jose Vicente
APODERAD.SOL Nuñez Gomez Francisco Javier
APODERADO Novoa Duran Jose Manuel
APODERAD.SOL Navarro Goyanes Felipe Antonio
APODERADO Moñino Fuste Jose Maria
APODERADO Irayzoz Del Castillo Sergio
APODERADO Hualde Diaz Hortensio
APODERAD.SOL Gracia Fores Yolanda
APODERADO Garcia Diez Rafael
APODERADO Bosch Tirau Jose Maria
APODERAD.SOL Armisen Barrabeig Joaquin
APODERADO Alonso Vilalta Victor
APODERAD.SOL Aguas Torres Jesus

PDF Anuncio nº 335643 de 2016

Datos registrales: T 44429 , F 113, S 8, H B 352505, I/A 52

23

Oct 2015

Reelecciones

Con fecha 23/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Miem.Com.Ctr Vilchez Dominguez Rafael
Miem.Com.Ctr Torrents Arevalo Jose Antonio
Miem.Com.Ctr Sancho Rey Cristina
Miem.Com.Ctr Rosello Barrios Nuria
Miem.Com.Ctr Ramirez Santiago Pedro
Miem.Com.Ctr Piña Cavero Miriam
Miem.Com.Ctr Muñoz Jimenez Antonio
Miem.Com.Ctr Martin Garcia Faustino
Miem.Com.Ctr Haufe Martina
Miem.Com.Ctr Gomez Cañellas Francisco
Miem.Com.Ctr Garcia Diez Rafael
Miem.Com.Ctr Ferrer Guix Jordi
Miem.Com.Ctr De Leon Lopez Raul
Miem.Com.Ctr De La Calle Fernandez Jose Luis
Miem.Com.Ctr Charle Torre Montserrat

PDF Anuncio nº 440004 de 2015

Datos registrales: T 26045 , F 14, S 8, H M 314168, I/A 21

23

Oct 2015

Nombramientos

Con fecha 23/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Miem.Com.Ctr Vazquez Coronel Noelia
Miem.Com.Ctr Torrents Arevalo Jose Antonio
Miem.Com.Ctr Tejerina Pablos Roberto
Miem.Com.Ctr Sancho Rey Cristina
Miem.Com.Ctr Salla Mateu Pau
Miem.Com.Ctr Saiz Sanchez Miguel Angel
Miem.Com.Ctr Rosello Barrios Nuria
Miem.Com.Ctr Rodenas Aguilar Victor
Miem.Com.Ctr Reales Garcia Eugenio
Miem.Com.Ctr Ramirez Santiago Pedro
Miem.Com.Ctr Piña Cavero Miriam
Miem.Com.Ctr Muñoz Jimenez Antonio
Miem.Com.Ctr Morales Suarez Esther
Miem.Com.Ctr Martin Garcia Faustino
Miem.Com.Ctr Marques Ferrer Josep
Miem.Com.Ctr Haufe Martina
Miem.Com.Ctr Haba Benavente Manuel
Miem.Com.Ctr Guzman Vila Jose
Miem.Com.Ctr Garcia Franco Jose Ramon
Miem.Com.Ctr Garcia Diez Rafael
Miem.Com.Ctr Ferriz Berruezo Ramon
Miem.Com.Ctr Ferrer Guix Jordi
Miem.Com.Ctr Esquius Ausio Jose Maria
Miem.Com.Ctr De Leon Lopez Raul
Miem.Com.Ctr Charle Torre Montserrat
Miem.Com.Ctr Camprubi Baiges Ferran
Miem.Com.Ctr Albi Arabia Marti
Este acto mercantil contiene 27 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 440004 de 2015

Datos registrales: T 26045 , F 14, S 8, H M 314168, I/A 21

10

Ago 2015

Nombramientos

Con fecha 10/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Sanchez Dios Ruben
Apo.Manc. Romero De La Hera Francisco
Apo.Manc. Rodriguez Garcia Elena
Apo.Manc. Ramirez Romero Octavio
Apo.Manc. Puentes Martin Cesar
Apo.Manc. Perez Jigato Jose
Apo.Manc. Palacio Sanchez Jose Miguel
Apo.Manc. Padilla Moreno Maria Esther
Apo.Manc. Martin Moran Juan Maria
Apo.Manc. Martin Aguirre Jose Ignacio
Apo.Manc. Maria Isabel Cintas Saez
Apo.Manc. Lopez De Castro Maria Jesus
Apo.Manc. Lopez Campos Maria Isabel
Apo.Manc. Leal Couso Raquel
Apo.Manc. Langa Vidal Carlos
Apo.Manc. Jorge Lopez Garcia
Apo.Manc. Jimenez Urizar Jose Jaime
Apo.Manc. Isabel Josefa Miro Granada De Grado
Apo.Manc. Hernandez Martinez Santiago
Apo.Manc. Gregorio Gorriti Juan Florencio
Apo.Manc. Gomez-Martelo Gil De Bernabe Jorge
Apo.Manc. Gomez Solorzano Jose Luis
Apo.Manc. Gomez Paredes Jorge
Apo.Manc. Goma Simon Rocio Paz
Apo.Manc. Gamero Sosa Maria Jose
Apo.Manc. Fernandez Sanchez Jose Carlos
Apo.Manc. Fernandez Lopez Oscar
Apo.Manc. Diaz Iglesias Rafael Luis
Apo.Manc. De Los Santos Bernardos Carlos Martin
Apo.Manc. Costeja Cros Josep Maria
Apo.Manc. Cossarini Alessandra
Apo.Manc. Cerezo Pamplona Daniel
Apo.Manc. Cano Franganillo Alfonso
Apo.Manc. Buil De La Llave Maria
Apo.Manc. Bolado Rios Ramon
Apo.Manc. Ayuso Delibes Jaime
Apo.Manc. Aurora Legarda Gomez
Apo.Manc. Ariza Cornago Antonio
Apo.Manc. Antonio Ojeda Gartner
Apo.Manc. Antonio Garcia Mendez
Apo.Manc. Amian Virgili Javier
Apo.Manc. Alvarez Gomez Manuel
Apo.Manc. Alonso Lopez Luis
Apo.Manc. Alcibar Benedi Ernesto
Apo.Manc. Agullo Torres Alfonso
Apo.Manc. Aguilar Cardenas Maria Luisa
Apo.Manc. Aguilar Cardenas Alberto
Apo.Manc. Adrados San Felipe Luisa
Apo.Manc. Adones Jimenez Manuel Jose
Apo.Manc. Adamuz Libran Maria Teresa
Este acto mercantil contiene 121 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 342227 de 2015

Datos registrales: T 1089 , F 113, S 8, H S 1960, I/A 2865

10

Feb 2015

Nombramientos

Con fecha 10/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERAD.SOL Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 71515 de 2015

Datos registrales: T 43265 , F 186, S 8, H B 426150, I/A 15

26

Dic 2014

Nombramientos

Con fecha 26/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Adm. Unico Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 613 de 2015

Datos registrales: T 3822 , F 107, S 8, H A 142876, I/A 1

07

Ago 2014

Nombramientos

Con fecha 07/08/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.SOL/MAN Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 335628 de 2014

Datos registrales: T 43862 , F 169, S 8, H B 352505, I/A 47

17

Abr 2014

Nombramientos

Con fecha 17/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.SOL/MAN Garcia Diez Rafael

PDF Anuncio nº 182903 de 2014

Datos registrales: T 43265 , F 185, S 8, H B 426150, I/A 12

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2024-50-08 Barcelona 11/03/2024
PDF BORME-A-2023-9-08 Barcelona 13/01/2023
PDF BORME-A-2022-222-28 Madrid 22/11/2022
PDF BORME-A-2022-106-08 Barcelona 06/06/2022
PDF BORME-A-2021-248-08 Barcelona 29/12/2021
PDF BORME-A-2021-212-08 Barcelona 04/11/2021
PDF BORME-A-2021-120-08 Barcelona 25/06/2021
PDF BORME-A-2021-110-39 Cantabria 11/06/2021
PDF BORME-A-2019-112-28 Madrid 14/06/2019
PDF BORME-A-2019-15-08 Barcelona 23/01/2019
PDF BORME-A-2018-121-28 Madrid 26/06/2018
PDF BORME-A-2016-154-08 Barcelona 12/08/2016
PDF BORME-A-2015-209-28 Madrid 02/11/2015
PDF BORME-A-2015-156-39 Cantabria 18/08/2015
PDF BORME-A-2015-33-08 Barcelona 18/02/2015
PDF BORME-A-2015-2-03 Alicante 05/01/2015
PDF BORME-A-2014-155-08 Barcelona 18/08/2014
PDF BORME-A-2014-81-08 Barcelona 29/04/2014
PDF BORME-A-2013-81-39 Cantabria 30/04/2013
PDF BORME-A-2012-196-08 Barcelona 10/10/2012
Ver más

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret