info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 10
Cargos no vigentes 40
Apariciones en BORME 39
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Sol. Distribucion Y Explotacion De Maquinas Automaticas Del Norte SA 28/09/2011 Actualidad
Apo.Sol. Distribucion Y Explotacion De Maquinas Automaticas Del Norte SA 28/09/2011 Actualidad
Apo.Man.Soli Distribucion Y Explotacion De Maquinas Automaticas Del Norte SA 28/09/2011 Actualidad
Apo.Sol. Trebe Vending SL 26/08/2011 Actualidad
Apo.Sol. Trebe Vending SL 26/08/2011 Actualidad
Apo.Man.Soli Trebe Vending SL 26/08/2011 Actualidad
Apoderado Demas SL 02/06/2011 Actualidad
Secretario Demas SL 12/05/2011 Actualidad
Consejero Demas SL 12/05/2011 Actualidad
Apoderado Gmc Vending Zaragoza SL 18/11/2009 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
SECRETARIO Servecave SL 17/01/2018 08/02/2019
CONSEJERO Servecave SL 17/01/2018 08/02/2019
Secretario Acorn Spain 1 SL Desconocido 28/01/2019
Consejero Acorn Spain 1 SL Desconocido 28/01/2019
Apo.Man.Soli Acorn Spain 1 SL 14/02/2011 28/01/2019
Secretario Nordis Social Coffee SL 30/12/2008 09/01/2019
Consejero Nordis Social Coffee SL 30/12/2008 09/01/2019
Apo.Man.Soli Nordis Social Coffee SL 14/02/2011 09/01/2019
Apo.Man.Soli Ab Servicios Selecta España SL 22/12/2017 26/11/2018
Secretario Pelican Rouge Coffee Solutions SA 27/08/2013 08/01/2018
Consejero Pelican Rouge Coffee Solutions SA 27/08/2013 08/01/2018
Apo.Man.Soli Pelican Rouge Coffee Solutions SA 14/02/2011 08/01/2018
Apoderado B R B Internacional SA Desconocido 14/12/2015
Secretario Distribuciones Automaticas De Bebidas Del Condado SL 01/06/2011 03/12/2012
Consejero Distribuciones Automaticas De Bebidas Del Condado SL 01/06/2011 03/12/2012
Apo.Man.Soli Distribuciones Automaticas De Bebidas Del Condado SL 01/06/2011 03/12/2012
Consejero Benazahora Cafe SRL 24/05/2011 03/12/2012
Apo.Sol. Benazahora Cafe SRL 24/05/2011 03/12/2012
Apo.Sol. Benazahora Cafe SRL 24/05/2011 03/12/2012
Apo.Man.Soli Benazahora Cafe SRL 24/05/2011 03/12/2012
Ver más
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Caballero Alemany Manuel .

08

Feb 2019

Revocaciones

Con fecha 08/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Valderas Vargas Juan Carlos
APOD.SOL/MAN Ustero Alonso Jose Luis
APOD.SOL/MAN Rodicio Miravalles Ana
APOD.MANCOMU Fernandez Moreno Maria Del Carmen
SECRETARIO Caballero Alemany Manuel
APOD.MANCOMU Bernia Armengod Luis
APOD.SOL/MAN Abad Plaza Jorge

PDF Anuncio nº 73209 de 2019

Datos registrales: T 45350 , F 158, S 8, H B 373901, I/A 16

28

Ene 2019

Revocaciones

Con fecha 28/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Ustero Alonso Jose Luis
Apo.Man.Soli Rodicio Miravalles Ana
Apoderado Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Lacunza Lopez Diego
Apo.Man.Soli Gomez Paumard Olivier
Apo.Manc. Fernandez Moreno Maria Del Carmen
Apo.Man.Soli Cutuli Galvez Jose Luis
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel
Apo.Manc. Bernia Armengod Luis
Apo.Man.Soli Abad Plaza Jorge

PDF Anuncio nº 49230 de 2019

Datos registrales: T 32827 , F 29, S 8, H M 374093, I/A 31

28

Ene 2019

Ceses/Dimisiones

Con fecha 28/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 49230 de 2019

Datos registrales: T 32827 , F 29, S 8, H M 374093, I/A 31

09

Ene 2019

Revocaciones

Con fecha 09/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Ustero Alonso Jose Luis
Apo.Man.Soli Rodicio Miravalles Ana
Apo.Man.Soli Lacunza Lopez Diego
Apo.Man.Soli Gomez Paumard Olivier
Apo.Manc. Fernandez Moreno Maria Del Carmen
Apo.Man.Soli Cutuli Galvez Jose Luis
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel
Apo.Manc. Bernia Armengod Luis
Apo.Man.Soli Abad Plaza Jorge

PDF Anuncio nº 17018 de 2019

Datos registrales: T 36487 , F 163, S 8, H M 295720, I/A 28

09

Ene 2019

Ceses/Dimisiones

Con fecha 09/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Secretario Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 17018 de 2019

Datos registrales: T 36487 , F 163, S 8, H M 295720, I/A 28

26

Nov 2018

Revocaciones

Con fecha 26/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Valderas Vargas Juan Carlos
Apo.Man.Soli Ustero Alonso Jose Luis
Apo.Man.Soli Rodicio Miravalles Ana
Apo.Man.Soli Lacunza Lopez Diego
Apo.Man.Soli Gomez Paumard Olivier
Apo.Manc. Fernandez Moreno Maria Del Carmen
Apo.Sol. Esnal Aldekoa Ainhoa
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel
Apo.Manc. Bernia Armengod Luis
Apo.Man.Soli Abad Plaza Jorge

PDF Anuncio nº 483760 de 2018

Datos registrales: T 37994 , F 145, S 8, H M 207189, I/A 55

17

Ene 2018

Nombramientos

Con fecha 17/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
PRESIDENTE Rodicio Miravalles Ana
CONSEJERO Pelican Rouge BV
REPR.143 RRM Hugues Marie Bernard Georges Rougier
SECRETARIO Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 40972 de 2018

Datos registrales: T 45350 , F 157, S 8, H B 373901, I/A 14

22

Dic 2017

Nombramientos

Con fecha 22/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Lacunza Lopez Diego
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 5601 de 2018

Datos registrales: T 12881 , F 204, S 8, H M 207189, I/A 48

14

Dic 2015

Revocaciones

Con fecha 14/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Martin Alaya Luis
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Biern Lliviria Claudio Jose
Apoderado Biern Lliviria Carlos Ignacio

PDF Anuncio nº 518361 de 2015

Datos registrales: T 25342 , F 50, S 8, H M 98523, I/A 56

27

Ago 2013

Reelecciones

Con fecha 27/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Lawrie John Graham
Consejero Huarte Iribarren Jose Ignacio
Consejero Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 387792 de 2013

Datos registrales: T 31301 , F 31, S 8, H M 61661, I/A 83

21

Oct 2011

Nombramientos

Con fecha 21/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Villalba Diaz Antonio
APODERADO Timothy Michael Roe
APODERADO Michael Frank Greenwood
APODERADO John Graham Lawrie
APODERADO James Darwent
APODERADO Huarte Iribarren Jose Ignacio
APODERADO Caballero Alemany Manuel
APODERADO Andrew Wyatt Bristow

PDF Anuncio nº 437687 de 2011

Datos registrales: T 40075 , F 77, S 8, H B 358919, I/A 9

04

Oct 2011

Nombramientos

Con fecha 04/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Man.Soli Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel
Apo.Man.Soli Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 409679 de 2011

Datos registrales: T 23484 , F 84, S 8, H M 164767, I/A 27

28

Sep 2011

Nombramientos

Con fecha 28/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 400422 de 2011

Datos registrales: T 23579 , F 179, S 8, H M 423126, I/A 8

28

Sep 2011

Nombramientos

Con fecha 28/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Sol. Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel
Apo.Sol. Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 399897 de 2011

Datos registrales: T 2204 , F 201, S 8, H SS 6176, I/A 56

26

Ago 2011

Nombramientos

Con fecha 26/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Villalba Diaz Antonio
Apo.Sol. Roe Timothy Michael
Apo.Man.Soli Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel
Apo.Man.Soli Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 362507 de 2011

Datos registrales: T 1768 , F 76, S 8, H SS 16154, I/A 12

02

Ago 2011

Nombramientos

Con fecha 02/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Wyatt Bristow Andrew
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Man.Soli Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Manc. Greenwood Michael Frank
Apo.Manc. Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 338865 de 2011

Datos registrales: T 26355 , F 39, S 8, H M 24803, I/A 142

02

Ago 2011

Nombramientos

Con fecha 02/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Roe Timothy Michael
Vicepresid. Lawrie John Graham
Consejero Huarte Iribarren Jose Ignacio
Secretario Caballero Alemany Manuel
Consejero Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 338864 de 2011

Datos registrales: T 26355 , F 37, S 8, H M 24803, I/A 141

02

Jun 2011

Nombramientos

Con fecha 02/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 254743 de 2011

Datos registrales: T 4569, L 3478, F 193, S 8, H MA 13085, I/A 22

02

Jun 2011

Revocaciones

Con fecha 02/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 254743 de 2011

Datos registrales: T 4569, L 3478, F 193, S 8, H MA 13085, I/A 22

02

Jun 2011

Nombramientos

Con fecha 02/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 254742 de 2011

Datos registrales: T 4569, L 3478, F 191, S 8, H MA 13085, I/A 21

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2019-33-08 Barcelona 18/02/2019
PDF BORME-A-2019-23-28 Madrid 04/02/2019
PDF BORME-A-2019-10-28 Madrid 16/01/2019
PDF BORME-A-2018-231-28 Madrid 03/12/2018
PDF BORME-A-2018-19-08 Barcelona 26/01/2018
PDF BORME-A-2018-3-28 Madrid 04/01/2018
PDF BORME-A-2015-243-28 Madrid 22/12/2015
PDF BORME-A-2013-168-28 Madrid 04/09/2013
PDF BORME-A-2011-210-08 Barcelona 04/11/2011
PDF BORME-A-2011-197-28 Madrid 17/10/2011
PDF BORME-A-2011-192-28 Madrid 07/10/2011
PDF BORME-A-2011-192-20 Guipúzcoa 07/10/2011
PDF BORME-A-2011-170-20 Guipúzcoa 06/09/2011
PDF BORME-A-2011-155-28 Madrid 16/08/2011
PDF BORME-A-2011-113-29 Málaga 14/06/2011
PDF BORME-A-2011-111-23 Jaén 10/06/2011
PDF BORME-A-2011-105-11 Cádiz 02/06/2011
PDF BORME-A-2011-100-29 Málaga 26/05/2011
PDF BORME-A-2011-42-28 Madrid 02/03/2011
PDF BORME-A-2011-39-28 Madrid 25/02/2011
Ver más

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret