Última actualización: 22 de Enero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B81502502 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Marie Curie Numero 17, Planta 5, 521 Hub Edific (Rivas-Vaciamadrid). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Hernando Rebollo Antonio | 22/01/2024 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Crecente Maseda Ana Belen | 22/01/2024 | Actualidad |
Apo.Manc. | Aparicio Puig Miguel Angel | 22/01/2024 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Aparicio Puig Miguel Angel | 22/01/2024 | Actualidad |
Apoderado | Hernando Rebollo Antonio | 18/01/2024 | Actualidad |
Consejero | Jenoc Olivier | 03/08/2022 | Actualidad |
Con.Delegado | Jenoc Olivier | 03/08/2022 | Actualidad |
Consejero | Leang Philippe | 03/01/2022 | Actualidad |
Presidente | Mouquet Annabel | 28/07/2021 | Actualidad |
Consejero | Mouquet Annabel | 19/01/2021 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 19/01/2021 | Actualidad |
Secretario | Aparicio Puig Miguel Angel | 28/08/2019 | Actualidad |
Apoderado | Vazquez Rodriguez De Alba Carlos | 17/04/2019 | Actualidad |
Apo.Manc. | Vazquez Rodriguez De Alba Carlos | 15/04/2019 | Actualidad |
Consejero | Carlier Geoffroy | 22/03/2019 | Actualidad |
Presidente | Ribaute Pierre | 12/02/2019 | Actualidad |
Consejero | Ribaute Pierre | 12/02/2019 | Actualidad |
Apoderado | Soria Campanales Pedro | 14/01/2019 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 15/01/2018 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 10/02/2015 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Jenoc Olivier | 12/05/2017 | 18/01/2024 |
Apo.Manc. | Jenoc Olivier | 12/05/2017 | 18/01/2024 |
Apo.Man.Soli | Crecente Maseda Ana Belen | 12/05/2017 | 18/01/2024 |
Consejero | Caillaud Vincent | 19/01/2021 | 18/01/2024 |
Apo.Manc. | Aparicio Puig Miguel Angel | 12/05/2017 | 18/01/2024 |
Apo.Man.Soli | Aparicio Puig Miguel Angel | 12/05/2017 | 18/01/2024 |
Apoderado | Lopez Solanes Carlos | 14/01/2019 | 23/11/2022 |
Apoderado | Lopez Fuentes Susana | 21/02/2014 | 23/11/2022 |
Consejero | Jenoc Olivier | 10/03/2017 | 03/08/2022 |
Cons.Del.Sol | Jenoc Olivier | 10/03/2017 | 03/08/2022 |
Presidente | Brochet Fabrice | 19/01/2021 | 28/07/2021 |
Consejero | Brochet Fabrice | 19/01/2021 | 28/07/2021 |
Consejero | Zaffran David | 19/09/2017 | 19/01/2021 |
Consejero | Ribaute Pierre | 26/03/2014 | 19/01/2021 |
Presidente | Carlier Geoffroy | 22/03/2019 | 19/01/2021 |
Consejero | Carlier Geoffroy | 29/07/2015 | 19/01/2021 |
Apoderado | Lopez Solanes Carlos | 10/07/2014 | 15/04/2019 |
Presidente | Ribaute Pierre | 26/03/2014 | 22/03/2019 |
Apoderado | Beato Marin Manuel | Desconocido | 21/02/2019 |
Apoderado | Aparicio Puig Miguel Angel | Desconocido | 21/02/2019 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Veolia Water Systems Iberica SL.
22
Ene 2024
Con fecha 22/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Hernando Rebollo Antonio |
Apo.Man.Soli | Aparicio Puig Miguel Angel |
Datos registrales: T 38643 , F 157, S 8, H M 176460, I/A 105
22
Ene 2024
Con fecha 22/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Crecente Maseda Ana Belen |
Apo.Manc. | Aparicio Puig Miguel Angel |
Datos registrales: T 38643 , F 156, S 8, H M 176460, I/A 104
18
Ene 2024
Con fecha 18/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Hernando Rebollo Antonio |
Datos registrales: T 38643 , F 154, S 8, H M 176460, I/A 103
18
Ene 2024
Con fecha 18/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Jenoc Olivier |
Apo.Man.Soli | Crecente Maseda Ana Belen |
Apo.Man.Soli | Aparicio Puig Miguel Angel |
Datos registrales: T 38643 , F 154, S 8, H M 176460, I/A 103
18
Ene 2024
Con fecha 18/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Caillaud Vincent |
Datos registrales: T 38643 , F 154, S 8, H M 176460, I/A 102
03
Ago 2022
Se omitió por error en la Inscripción 100ª la caducidad como miembro de orgáno de administración de JENOC OLIVIER nombrado en la Inscripción 78ª.
Datos registrales: T 38643 , F 153, S 8, H M 176460, I/A 100
03
Ago 2022
Con fecha 03/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes cancelaciones de oficio de nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Sol | Jenoc Olivier |
Datos registrales: T 38643 , F 153, S 8, H M 176460, I/A 100
23
Nov 2022
Con fecha 23/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lopez Solanes Carlos |
Apoderado | Lopez Fuentes Susana |
Datos registrales: T 38643 , F 154, S 8, H M 176460, I/A 101
03
Ago 2022
Con fecha 03/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Jenoc Olivier |
Datos registrales: T 38643 , F 153, S 8, H M 176460, I/A 100
03
Ene 2022
Con fecha 03/01/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Leang Philippe |
Datos registrales: T 38643 , F 153, S 8, H M 176460, I/A 99
28
Jul 2021
Con fecha 28/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Mouquet Annabel |
Datos registrales: T 38643 , F 153, S 8, H M 176460, I/A 98
28
Jul 2021
Con fecha 28/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Brochet Fabrice |
Datos registrales: T 38643 , F 153, S 8, H M 176460, I/A 98
30
Abr 2021
Con fecha 30/04/2021, la sociedad cambia su domicilio social a C/ MARIE CURIE NUMERO 17, PLANTA 5, 521 HUB EDIFIC (RIVAS-VACIAMADRID).
Datos registrales: T 38643 , F 152, S 8, H M 176460, I/A 97
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 38643 , F 152, S 8, H M 176460, I/A 96
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mouquet Annabel |
Consejero | Caillaud Vincent |
Presidente | Brochet Fabrice |
Datos registrales: T 38643 , F 152, S 8, H M 176460, I/A 95
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Zaffran David |
Consejero | Ribaute Pierre |
Presidente | Carlier Geoffroy |
Datos registrales: T 38643 , F 152, S 8, H M 176460, I/A 95
28
Ago 2019
Con fecha 28/08/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Aparicio Puig Miguel Angel |
Datos registrales: T 38643 , F 151, S 8, H M 176460, I/A 94
17
Abr 2019
Con fecha 17/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vazquez Rodriguez De Alba Carlos |
Datos registrales: T 38643 , F 151, S 8, H M 176460, I/A 93
15
Abr 2019
Con fecha 15/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vazquez Rodriguez De Alba Carlos |
Datos registrales: T 38643 , F 150, S 8, H M 176460, I/A 92
15
Abr 2019
Con fecha 15/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lopez Solanes Carlos |
Datos registrales: T 38643 , F 150, S 8, H M 176460, I/A 92
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-20-28 | Madrid | 29/01/2024 | |
BORME-A-2024-18-28 | Madrid | 25/01/2024 | |
BORME-A-2023-112-28 | Madrid | 15/06/2023 | |
BORME-A-2022-228-28 | Madrid | 30/11/2022 | |
BORME-A-2022-152-28 | Madrid | 10/08/2022 | |
BORME-A-2022-6-28 | Madrid | 11/01/2022 | |
BORME-A-2021-148-28 | Madrid | 04/08/2021 | |
BORME-A-2021-86-28 | Madrid | 10/05/2021 | |
BORME-A-2021-16-28 | Madrid | 26/01/2021 | |
BORME-A-2019-169-28 | Madrid | 04/09/2019 | |
BORME-A-2019-80-28 | Madrid | 26/04/2019 | |
BORME-A-2019-78-28 | Madrid | 24/04/2019 | |
BORME-A-2019-62-28 | Madrid | 29/03/2019 | |
BORME-A-2019-41-28 | Madrid | 28/02/2019 | |
BORME-A-2019-34-28 | Madrid | 19/02/2019 | |
BORME-A-2019-14-28 | Madrid | 22/01/2019 | |
BORME-A-2018-53-28 | Madrid | 15/03/2018 | |
BORME-A-2018-17-28 | Madrid | 24/01/2018 | |
BORME-A-2017-186-28 | Madrid | 28/09/2017 | |
BORME-A-2017-185-28 | Madrid | 27/09/2017 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades