Última actualización: 1 de Abril de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 2 años |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B85802577 |
Provincia | Madrid |
Fecha de constitución | 16 de Noviembre de 2009 (hace 14 años, 5 meses) |
Domicilio | C/ Orense, 85 (Madrid) |
Objeto social | Consultoria e ingenieria tecnologica en telecomunicaciones, en informaticay en sistemas de la informacion, electricidad y electronica, y el asesoramiento, comercializacion, implementacion, diseño, desarrollo y mantenimientode proyectos, etc |
Capital social | 5.189,0 euros |
Motivo de la disolución | Otras Causas. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Zulliger Pizarro Martin Exequiel | 16/06/2011 | 01/04/2022 |
Apo.Sol. | Zulliger Pizarro Federico Agustin | 07/02/2012 | 01/04/2022 |
Apo.Sol. | Zulliger Pizarro Ayelen Beatriz | 07/02/2012 | 01/04/2022 |
Apo.Manc. | Zulliger Pizarro Ayelen Beatriz | 16/06/2011 | 01/04/2022 |
Apo.Sol. | Santana Garcia Fuster Alejandro | 07/02/2012 | 01/04/2022 |
Apo.Manc. | Santana Garcia Fuster Alejandro | 16/06/2011 | 01/04/2022 |
Apo.Manc. | Cañete Romero Paloma | 16/06/2011 | 01/04/2022 |
Auditor | Auren Auditores Mad SL | 21/01/2015 | 01/04/2022 |
Presidente | Zulliger Pizarro Martin Exequiel | 07/02/2012 | 07/03/2017 |
Consejero | Zulliger Pizarro Martin Exequiel | 07/02/2012 | 07/03/2017 |
Consejero | Zulliger Pizarro Federico Agustin | 07/02/2012 | 07/03/2017 |
Secretario | Zulliger Pizarro Ayelen Beatriz | 26/05/2015 | 07/03/2017 |
Consejero | Zulliger Pizarro Ayelen Beatriz | 07/02/2012 | 07/03/2017 |
SecreNoConsj | Moreno Trias Vicente | 07/02/2012 | 26/05/2015 |
Vicepresid. | Santana Garcia Fuster Alejandro | 07/02/2012 | 15/04/2015 |
Consejero | Santana Garcia Fuster Alejandro | 07/02/2012 | 15/04/2015 |
Consejero | Fides Capital SL | 07/02/2012 | 15/04/2015 |
Representan | Cañete Romero Paloma | 07/02/2012 | 15/04/2015 |
Consejero | Hunt Chida Patricio Leonidas | 07/02/2012 | 12/06/2013 |
Adm. Unico | Zulliger Pizarro Ayelen Beatriz | 16/11/2009 | 07/02/2012 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Vadovice Interactiva SL.
01
Abr 2022
Con fecha 01/04/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 39850 , F 202, S 8, H M 489601, I/A 14
01
Abr 2022
Procedimiento concursal 724/2015. Fecha de resolución 28/12/2016. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 21/03/2022, NIF/CIF 03104455F. DELGADO PUERTA ANA ISABEL.
Datos registrales: T 39850 , F 202, S 8, H M 489601, I/A 14
01
Abr 2022
Procedimiento concursal 724/2015. FIRME: Si, Fecha de resolución 21/03/2022. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: AMAGOIA SERRANO BARRIENTOS. Resoluciones: CONCLUSION DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA.-
Datos registrales: T 39850 , F 202, S 8, H M 489601, I/A 14
01
Abr 2022
CERRADA LA HOJA REGISTRAL Y CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE LA MISMA.
Datos registrales: T 39850 , F 202, S 8, H M 489601, I/A 14
20
Nov 2019
Procedimiento concursal 724/2015. FIRME: No, Fecha de resolución 2/09/2019. Auto de formación de la sección de calificación. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.
Datos registrales: T 27176 , F 58, S 8, H M 489601, I/A B
20
Nov 2019
Procedimiento concursal 724/2015. FIRME: No, Fecha de resolución 2/09/2019. Auto de aprobación del plan de liquidación. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO.
Datos registrales: T 27176 , F 58, S 8, H M 489601, I/A B
07
Mar 2017
Con fecha 07/03/2017 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Otras Causas.
Datos registrales: T 27176 , F 57, S 8, H M 489601, I/A A
07
Mar 2017
Procedimiento concursal 724/2015. FIRME: No, Fecha de resolución 28/12/2016. Auto de apertura de la fase de liquidación. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: SE DECRETA LA APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Y EL CESE DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES SUSTITUIDOS POR LOS CONCURSALES.-
Datos registrales: T 27176 , F 57, S 8, H M 489601, I/A A
07
Mar 2017
Procedimiento concursal 724/2015. Fecha de resolución 28/12/2016. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Administrador Concursal. Fecha 28/12/2016, NIF/CIF 03104455F. DELGADO PUERTA ANA ISABEL.
Datos registrales: T 27176 , F 57, S 8, H M 489601, I/A A
07
Mar 2017
Procedimiento concursal 724/2015. FIRME: No, Fecha de resolución 28/12/2016. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: CARLOS NIETO DELGADO. Resoluciones: SE DECLARA EN CONCURSO VOLUNTARIO Y SE NOMBRA ADMINISTRADOR CONCURSAL.-
Datos registrales: T 27176 , F 57, S 8, H M 489601, I/A A
07
Mar 2017
Con fecha 07/03/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Zulliger Pizarro Martin Exequiel |
Consejero | Zulliger Pizarro Federico Agustin |
Consejero | Zulliger Pizarro Ayelen Beatriz |
Datos registrales: T 27176 , F 57, S 8, H M 489601, I/A A
16
Ene 2017
Se declara que el auditor nombrado ha sido sustituido por "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia de la escritura de fusión y segregación que causó la inscripción 1ª de la hoja 624.626.
Datos registrales: T 27176 , F 55, S 8, H M 489601, I/A 8M
04
Sep 2015
Con fecha 04/09/2015, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 250,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 5.06% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 5.189,0€.
Datos registrales: T 27176 , F 56, S 8, H M 489601, I/A 12
04
Sep 2015
Con fecha 04/09/2015, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 366,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 8.00% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 4.939,0€.
Datos registrales: T 27176 , F 56, S 8, H M 489601, I/A 12
04
Sep 2015
Con fecha 04/09/2015, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 513,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 12.64% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 4.573,0€.
Datos registrales: T 27176 , F 56, S 8, H M 489601, I/A 12
26
May 2015
Con fecha 26/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Zulliger Pizarro Ayelen Beatriz |
Datos registrales: T 27176 , F 56, S 8, H M 489601, I/A 11
26
May 2015
Con fecha 26/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Moreno Trias Vicente |
Datos registrales: T 27176 , F 56, S 8, H M 489601, I/A 11
15
Abr 2015
Con fecha 15/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Fides Capital SL |
Representan | Cañete Romero Paloma |
Datos registrales: T 27176 , F 56, S 8, H M 489601, I/A 10
15
Abr 2015
Con fecha 15/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Santana Garcia Fuster Alejandro |
Datos registrales: T 27176 , F 56, S 8, H M 489601, I/A 9
21
Ene 2015
Con fecha 21/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Auren Auditores Mad SL |
Datos registrales: T 27176 , F 55, S 8, H M 489601, I/A 8
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2022-69-28 | Madrid | 08/04/2022 |
BORME-A-2019-228-28 | Madrid | 27/11/2019 |
BORME-A-2017-54-28 | Madrid | 17/03/2017 |
BORME-A-2017-21-28 | Madrid | 31/01/2017 |
BORME-A-2015-181-28 | Madrid | 22/09/2015 |
BORME-A-2015-104-28 | Madrid | 05/06/2015 |
BORME-A-2015-77-28 | Madrid | 24/04/2015 |
BORME-A-2015-19-28 | Madrid | 29/01/2015 |
BORME-A-2013-115-28 | Madrid | 20/06/2013 |
BORME-A-2012-34-28 | Madrid | 17/02/2012 |
BORME-A-2011-124-28 | Madrid | 30/06/2011 |
BORME-A-2009-225-28 | Madrid | 25/11/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades