Última actualización: 9 de Septiembre de 2016
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 7 años, 7 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A82631623 |
Provincia | Madrid |
Capital social | 101.141.406,58 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez Ortega Manuel | 12/08/2009 | 09/09/2016 |
Apoderado | Saavedra Obermann Fernando | 13/05/2014 | 09/09/2016 |
Apo.Sol. | Rodriguez Carrion Carmen | 23/03/2015 | 09/09/2016 |
Apoderado | Martinez Taus Pablo | 13/05/2014 | 09/09/2016 |
Apo.Man.Soli | Martinez Taus Pablo | 15/06/2012 | 09/09/2016 |
Apo.Man.Soli | Martinez Jurado Luis Miguel | 15/06/2012 | 09/09/2016 |
Apo.Sol. | Katarzyna Kowal Agnieszka | 05/06/2015 | 09/09/2016 |
Presidente | Immele Robert Sylvain | 31/07/2014 | 09/09/2016 |
Presidente | Gonzalez Dominguez Ignacio | 17/02/2011 | 09/09/2016 |
Apoderado | Garcia Jimenez Marta | 13/05/2014 | 09/09/2016 |
Apo.Sol. | Fernandez Canseco Marta | 19/11/2012 | 09/09/2016 |
Apo.Sol. | Esteban Agueda Luis Maria | 23/03/2015 | 09/09/2016 |
Apo.Sol. | Esteban Agueda Luis Maria | 19/11/2012 | 09/09/2016 |
Auditor | Ernst & Young SL | 29/09/2015 | 09/09/2016 |
Auditor | Ernst & Young SL | 30/10/2014 | 09/09/2016 |
Aud.C.Con. | Deloitte SL | 22/12/2010 | 09/09/2016 |
Apo.Man.Soli | Del Barrio Gomez Jose Ignacio | 15/06/2012 | 09/09/2016 |
Apo.Man.Soli | Del Barrio Gomez Jose Ignacio | 15/06/2012 | 09/09/2016 |
Consejero | Degrave Philippe | 25/07/2013 | 09/09/2016 |
Apo.Man.Soli | Aguera Infante Raul | 12/08/2009 | 09/09/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Telvent Git SA.
09
Sep 2016
Con fecha 09/09/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 29966 , F 112, S 8, H M 257879, I/A 127
09
Sep 2016
Con fecha 09/09/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 29966 , F 112, S 8, H M 257879, I/A 127
09
Sep 2016
CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL. (artículo 233.2 RRM).
Datos registrales: T 29966 , F 112, S 8, H M 257879, I/A 127
08
Jul 2016
CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM.
Datos registrales: T 29966 , F 109, S 8, H M 257879, I/A126/M
08
Jul 2016
Sociedades absorbidas: TELVENT ENERGIA SA. TELVENT SERVICIOS COMPARTIDOS SA.
Datos registrales: T 29966 , F 109, S 8, H M 257879, I/A 126
06
Abr 2016
Con fecha 06/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Miguez Equizabal Eva Maria |
Datos registrales: T 29966 , F 109, S 8, H M 257879, I/A 125
04
Ene 2016
Con fecha 04/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Bone Gandia Fernando |
Datos registrales: T 29966 , F 108, S 8, H M 257879, I/A 124
30
Nov 2015
Con fecha 30/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicesecret. | D. Nemeth Laura |
Datos registrales: T 29966 , F 108, S 8, H M 257879, I/A 123
17
Nov 2015
Con fecha 17/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Helbert Cyrille |
Datos registrales: T 29966 , F 108, S 8, H M 257879, I/A 122
29
Sep 2015
Con fecha 29/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 29966 , F 107, S 8, H M 257879, I/A 121
05
Jun 2015
Con fecha 05/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Katarzyna Kowal Agnieszka |
Datos registrales: T 29966 , F 106, S 8, H M 257879, I/A 120
05
Jun 2015
Con fecha 05/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicepresid. | Rodriguez Carrion Carmen |
Datos registrales: T 29966 , F 106, S 8, H M 257879, I/A 119
05
Jun 2015
Con fecha 05/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Helbert Cyrille Pierre Michel |
Vicepresid. | Helbert Cyrille |
Datos registrales: T 29966 , F 106, S 8, H M 257879, I/A 119
19
May 2015
Con fecha 19/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lopez Toledo Segundo |
Datos registrales: T 29966 , F 106, S 8, H M 257879, I/A 118
06
Abr 2015
Con fecha 06/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Caceres Salazar Francisco |
Datos registrales: T 29966 , F 106, S 8, H M 257879, I/A 117
23
Mar 2015
Con fecha 23/03/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Miguez Equizabal Eva Maria |
Apo.Sol. | Irurre Perez Ainoa |
Apo.Sol. | Fernandez Canseco Marta |
Apo.Sol. | Esteban Agueda Luis Maria |
Datos registrales: T 29966 , F 105, S 8, H M 257879, I/A 116
23
Mar 2015
Con fecha 23/03/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Rodriguez Carrion Carmen |
Datos registrales: T 29966 , F 104, S 8, H M 257879, I/A 115
27
Feb 2015
Con fecha 27/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lopez Toledo Segundo |
Datos registrales: T 29966 , F 103, S 8, H M 257879, I/A 114
27
Feb 2015
Con fecha 27/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Usano Fernandez Rosa Maria |
Datos registrales: T 29966 , F 102, S 8, H M 257879, I/A 113
30
Oct 2014
Con fecha 30/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 29966 , F 102, S 8, H M 257879, I/A 112
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2016-179-28 | Madrid | 19/09/2016 | |
BORME-A-2016-136-28 | Madrid | 18/07/2016 | |
BORME-A-2016-72-28 | Madrid | 15/04/2016 | |
BORME-A-2016-6-28 | Madrid | 12/01/2016 | |
BORME-A-2015-235-28 | Madrid | 10/12/2015 | |
BORME-A-2015-225-28 | Madrid | 25/11/2015 | |
BORME-A-2015-193-28 | Madrid | 08/10/2015 | |
BORME-A-2015-110-28 | Madrid | 15/06/2015 | |
BORME-A-2015-97-28 | Madrid | 26/05/2015 | |
BORME-A-2015-70-28 | Madrid | 15/04/2015 | |
BORME-A-2015-61-28 | Madrid | 31/03/2015 | |
BORME-A-2015-45-28 | Madrid | 06/03/2015 | |
BORME-A-2014-213-28 | Madrid | 06/11/2014 | |
BORME-A-2014-176-28 | Madrid | 16/09/2014 | |
BORME-A-2014-155-28 | Madrid | 18/08/2014 | |
BORME-A-2014-118-28 | Madrid | 25/06/2014 | |
BORME-A-2014-96-28 | Madrid | 23/05/2014 | |
BORME-A-2014-58-28 | Madrid | 25/03/2014 | |
BORME-A-2014-51-28 | Madrid | 14/03/2014 | |
BORME-A-2013-234-28 | Madrid | 09/12/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades