Última actualización: 26 de Diciembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A58864737 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Agustin De Foxa 29 10ª (Madrid). |
Capital social | 1.750.496,64 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL | 28/02/2023 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Kpmg Auditores SL | 28/02/2023 | Actualidad |
Consejero | Villoria Martin Ure | 18/01/2023 | Actualidad |
Consejero | Scharer Stephan Patrick | 18/01/2023 | Actualidad |
Presidente | Lloyd Jonathan David | 18/01/2023 | Actualidad |
Consejero | Lloyd Jonathan David | 18/01/2023 | Actualidad |
VsecrNoConsj | Mesa Molina Jose Maria | 08/10/2020 | Actualidad |
SecreNoConsj | Lincke Karl H | 08/10/2020 | Actualidad |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 08/10/2020 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Kpmg Auditores SL | 08/10/2020 | Actualidad |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 03/08/2018 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Kpmg Auditores SL | 03/08/2018 | Actualidad |
Apoderado | Spati Daniel | 27/01/2016 | Actualidad |
Apoderado | Perez Iglesias Olga | 27/01/2016 | Actualidad |
Apoderado | Llorente Sierra Ruben | 27/01/2016 | Actualidad |
Apoderado | Hernandez Padilla Sergio | 27/01/2016 | Actualidad |
Apoderado | Hernandez Benito Ana Belen | 27/01/2016 | Actualidad |
Apoderado | Gutierrez Layuno Bruno | 27/01/2016 | Actualidad |
Apoderado | Del Villar Rubin Eduardo | 27/01/2016 | Actualidad |
Apoderado | Ayuso Barrios Alvaro | 27/01/2016 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Villoria Martin Ure | 22/10/2019 | 18/01/2023 |
Presidente | Lalanne Frederic Arnaud | 22/10/2019 | 18/01/2023 |
Consejero | Lalanne Frederic Arnaud | 22/10/2019 | 18/01/2023 |
Consejero | Fettig Herbert | 22/10/2019 | 18/01/2023 |
Secretario | Peña Boada Carlos | Desconocido | 08/10/2020 |
Presidente | Otto Streicher Michael | 26/06/2014 | 22/10/2019 |
Consejero | Otto Streicher Michael | 26/06/2014 | 22/10/2019 |
Consejero | Micki Tania | 26/06/2014 | 22/10/2019 |
Consejero | Hirvensalo Mikko Pertti | 27/12/2016 | 22/10/2019 |
Consejero | Hirvensalo Mikko Pertti | 23/08/2012 | 27/12/2016 |
Apo.Man.Soli | Spati Daniel | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Prieto Cabo Francisco Alberto | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Montes Aroca Julia | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Montes Aroca Julia | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Llorente Bajo Nicanor | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Herranz Ciudad Ester | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Apoderado | Garcia Perez Nestor | 17/04/2013 | 27/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Colleti Sandro | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Cabrera Gomez Isabel | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Apo.Man.Soli | Bally Frederic Louis | 29/08/2012 | 27/01/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Sulzer Pumps Spain SA.
26
Dic 2023
Con fecha 26/12/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9 Y 10 DE LOS ESTATUTOS Y LA CREACION DEL ARTICULO 15 BIS DE LOS MISMOS. .
Datos registrales: T 32123 , F 154, S 8, H M 331808, I/A 38
28
Feb 2023
Con fecha 28/02/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 32123 , F 154, S 8, H M 331808, I/A 37
18
Ene 2023
Con fecha 18/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Villoria Martin Ure |
Consejero | Scharer Stephan Patrick |
Presidente | Lloyd Jonathan David |
Datos registrales: T 32123 , F 154, S 8, H M 331808, I/A 36
18
Ene 2023
Con fecha 18/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Villoria Martin Ure |
Presidente | Lalanne Frederic Arnaud |
Consejero | Fettig Herbert |
Datos registrales: T 32123 , F 154, S 8, H M 331808, I/A 36
08
Oct 2020
Con fecha 08/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 32123 , F 153, S 8, H M 331808, I/A 35
08
Oct 2020
Con fecha 08/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Mesa Molina Jose Maria |
SecreNoConsj | Lincke Karl H |
Datos registrales: T 32123 , F 153, S 8, H M 331808, I/A 34
08
Oct 2020
Con fecha 08/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Peña Boada Carlos |
Datos registrales: T 32123 , F 153, S 8, H M 331808, I/A 34
22
Oct 2019
Con fecha 22/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Villoria Martin Ure |
Consejero | Lalanne Frederic Arnaud |
Consejero | Fettig Herbert |
Datos registrales: T 32123 , F 152, S 8, H M 331808, I/A 33
22
Oct 2019
Con fecha 22/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Otto Streicher Michael |
Consejero | Micki Tania |
Consejero | Hirvensalo Mikko Pertti |
Datos registrales: T 32123 , F 152, S 8, H M 331808, I/A 33
17
Oct 2019
Con fecha 17/10/2019, la sociedad cambia su domicilio social a C/ AGUSTIN DE FOXA 29 10ª (MADRID).
Datos registrales: T 32123 , F 152, S 8, H M 331808, I/A 32
03
Ago 2018
Con fecha 03/08/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 32123 , F 152, S 8, H M 331808, I/A 31
27
Dic 2016
Con fecha 27/12/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Hirvensalo Mikko Pertti |
Datos registrales: T 32123 , F 151, S 8, H M 331808, I/A 30
27
Dic 2016
Con fecha 27/12/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Hirvensalo Mikko Pertti |
Datos registrales: T 32123 , F 151, S 8, H M 331808, I/A 30
01
Feb 2016
Con fecha 01/02/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICADOS LOS ARTICULOS 1º, 3º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º Y 18º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. .
Datos registrales: T 32123 , F 151, S 8, H M 331808, I/A 29
27
Ene 2016
Con fecha 27/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Spati Daniel |
Apoderado | Sotillo Moyo Maria Jesus |
Apoderado | Sanroman Claver Gonzalo |
Apoderado | Ramalli Simone |
Apoderado | Querol Jimenez Ester |
Apoderado | Prieto Cabo Francisco Alberto |
Apoderado | Perez Iglesias Olga |
Apoderado | Muñoz Garcia Ruth |
Apoderado | Muñiz Docasal Beatriz |
Apoderado | Montes Aroca Julia |
Apoderado | Mercader Conesa Andres |
Apoderado | Martinez Perez Daniel |
Apoderado | Martin Negrete Juan |
Apoderado | Llorente Sierra Ruben |
Apoderado | Llorente Bajo Nicanor |
Apoderado | Herranz Ciudad Ester |
Apoderado | Hernandez Padilla Sergio |
Apoderado | Hernandez Benito Ana Belen |
Apoderado | Gutierrez Layuno Bruno |
Apoderado | Guerreiro Madeira Joao Andre |
Apoderado | Fernandez Sanchez Susana |
Apoderado | Del Villar Rubin Eduardo |
Apoderado | Codo Ibars Roger |
Apoderado | Cabrera Gomez Isabel |
Apoderado | Bally Frederic Louis |
Apoderado | Ayuso Barrios Alvaro |
Apoderado | Alonso Arranz Begoña |
Datos registrales: T 32123 , F 146, S 8, H M 331808, I/A 28
27
Ene 2016
Con fecha 27/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Spati Daniel |
Apo.Man.Soli | Sotillo Moyo Maria Jesus |
Apo.Man.Soli | Sanroman Claver Gonzalo |
Apo.Man.Soli | Rivas Lopez Miguel Angel |
Apo.Man.Soli | Ramalli Simone |
Apo.Man.Soli | Querol Jimenez Ester |
Apo.Man.Soli | Prieto Cabo Franciscoalberto |
Apo.Man.Soli | Prieto Cabo Francisco Alberto |
Apo.Man.Soli | Perez Laborda Hurtado Sarancho Gonzalo |
Apo.Man.Soli | Muñoz Garcia Ruth |
Apo.Man.Soli | Montes Aroca Julia |
Apo.Man.Soli | Mercader Conesa Andres |
Apo.Man.Soli | Martinez Perez Daniel |
Apo.Man.Soli | Martin Negrete Juan |
Apo.Man.Soli | Llorente Bajo Nicanor |
Apo.Man.Soli | Herranz Ciudad Ester |
Apo.Man.Soli | Hernandez Benito Ana Belen |
Apo.Man.Soli | Gutierrez Layuno Bruno |
Apo.Man.Soli | Guerreiro Madeira Joao Andre |
Apoderado | Garcia Perez Nestor |
Apo.Man.Soli | Fernandez Sanchez Susana |
Apo.Man.Soli | Del Villar Rubin Eduardo |
Apo.Man.Soli | Colleti Sandro |
Apo.Man.Soli | Cabrera Gomez Isabel |
Apo.Man.Soli | Bally Frederic Louis |
Apo.Man.Soli | Alonso Arranz Begoña |
Datos registrales: T 32123 , F 146, S 8, H M 331808, I/A 28
27
Abr 2015
Con fecha 27/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 32123 , F 145, S 8, H M 331808, I/A 27
27
Abr 2015
Con fecha 27/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 32123 , F 145, S 8, H M 331808, I/A 27
20
Abr 2015
Con fecha 20/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 32123 , F 145, S 8, H M 331808, I/A 26
26
Jun 2014
Con fecha 26/06/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Otto Streicher Michael |
Consejero | Micki Tania |
Datos registrales: T 32123 , F 145, S 8, H M 331808, I/A 25
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-2-28 | Madrid | 03/01/2024 | |
BORME-A-2023-46-28 | Madrid | 07/03/2023 | |
BORME-A-2023-17-28 | Madrid | 25/01/2023 | |
BORME-A-2020-201-28 | Madrid | 16/10/2020 | |
BORME-A-2019-209-28 | Madrid | 30/10/2019 | |
BORME-A-2019-205-28 | Madrid | 24/10/2019 | |
BORME-A-2018-155-28 | Madrid | 13/08/2018 | |
BORME-A-2017-3-28 | Madrid | 04/01/2017 | |
BORME-A-2016-26-28 | Madrid | 09/02/2016 | |
BORME-A-2016-23-28 | Madrid | 04/02/2016 | |
BORME-A-2015-84-28 | Madrid | 06/05/2015 | |
BORME-A-2015-79-28 | Madrid | 28/04/2015 | |
BORME-A-2014-124-28 | Madrid | 03/07/2014 | |
BORME-A-2014-97-28 | Madrid | 26/05/2014 | |
BORME-A-2013-77-28 | Madrid | 24/04/2013 | |
BORME-A-2012-236-28 | Madrid | 11/12/2012 | |
BORME-A-2012-173-28 | Madrid | 10/09/2012 | |
BORME-A-2012-170-28 | Madrid | 05/09/2012 | |
BORME-A-2012-82-28 | Madrid | 30/04/2012 | |
BORME-A-2012-44-28 | Madrid | 02/03/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades