Última actualización: 18 de Octubre de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 6 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A82101981 |
Denominación anterior | Clinica Perio SA |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Conde De Vilches 18 (Madrid). |
Capital social | 373.840,03 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Tejerina Diaz Luis | Desconocido | 18/10/2018 |
Presidente | Realza Capital Sgecr SA | 12/05/2015 | 18/10/2018 |
Consejero | Realza Capital Sgecr SA | 12/05/2015 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | Pocovi Ballester Bartolome | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | Perez Espuelas David Carlos | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | Mourelo Gomez Javier | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | Mourelo Gomez Javier | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | Mourelo Gomez Javier | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | Mourelo Gomez Javier | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | Martin Del Rio Pablo | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | Fernandez Perez Ivan | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 26/01/2017 | 18/10/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 12/05/2015 | 18/10/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 17/12/2010 | 18/10/2018 |
Aud.C.Con. | Deloitte SL | 10/10/2011 | 18/10/2018 |
Aud.C.Con. | Deloitte SL | 27/09/2013 | 18/10/2018 |
Aud.C.Con. | Deloitte SL | 17/12/2010 | 18/10/2018 |
Aud.C.Con. | Deloitte SL | 14/12/2012 | 18/10/2018 |
Apoderado | De Rivas Calles Angel Luis | 11/12/2009 | 18/10/2018 |
Apo.Sol. | De Rivas Calles Angel Luis | 22/03/2018 | 18/10/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Plenido SA.
18
Oct 2018
Con fecha 18/10/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 28302 , F 76, S 8, H M 218244, I/A 51
18
Oct 2018
Con fecha 18/10/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 28302 , F 76, S 8, H M 218244, I/A 51
18
Oct 2018
Con fecha 18/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Vega Moya Nadia |
Apoderado | Tejerina Diaz Luis |
Apo.Sol. | Samper Bañon Vicente |
Apo.Manc. | Rivera Lopez Ignacio |
Apo.Sol. | Pocovi Ballester Bartolome |
Apo.Manc. | Perez Espuelas David Carlos |
Apo.Sol. | Mourelo Gomez Javier |
Apo.Sol. | Martin Del Rio Pablo |
Apo.Sol. | Garcia Ruiz Maria Del Carmen |
Apo.Sol. | Galarraga Rodriguez Federico |
Apo.Sol. | Fernandez Perez Ivan |
Apoderado | De Rivas Calles Angel Luis |
Apo.Sol. | Bermudez Gallardo Raquel |
Apo.Manc. | Alfonso Ochotorena Rafael |
Datos registrales: T 28302 , F 76, S 8, H M 218244, I/A 51
18
Oct 2018
Con fecha 18/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Mancom. | Olave Martin Juan |
Adm. Mancom. | Gonzalez Burgada Jordi |
Socio único | Cartera Vivanta SL |
Datos registrales: T 28302 , F 76, S 8, H M 218244, I/A 51
13
Jun 2018
Supresión de la página web corporativa: www.plenido.com.
Datos registrales: T 28302 , F 76, S 8, H M 218244, I/A 50
22
Mar 2018
Con fecha 22/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Vega Moya Nadia |
Apo.Sol. | Samper Bañon Vicente |
Apo.Sol. | Rivera Lopez Ignacio |
Apo.Manc. | Pocovi Ballester Bartolome |
Apo.Manc. | Perez Espuelas David Carlos |
Apo.Sol. | Mourelo Gomez Javier |
Apo.Sol. | Martin Del Rio Pablo |
Apo.Sol. | Garcia Ruiz Maria Del Carmen |
Apo.Sol. | Galarraga Rodriguez Federico |
Apo.Sol. | Fernandez Perez Ivan |
Apo.Sol. | De Rivas Calles Angel Luis |
Apo.Sol. | Bermudez Gallardo Raquel |
Apo.Sol. | Alfonso Ochotorena Rafael |
Datos registrales: T 28302 , F 74, S 8, H M 218244, I/A 49
08
Feb 2018
Con fecha 08/02/2018, la sociedad cambia su domicilio social a C/ CONDE DE VILCHES 18 (MADRID).
Datos registrales: T 28302 , F 74, S 8, H M 218244, I/A 48
16
Oct 2017
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados.
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 47
16
Oct 2017
Con fecha 16/10/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificados los artículos 8, 10, 12, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de los estatutos sociales, e incorporado el artículo 22bis..
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 47
16
Oct 2017
Con fecha 16/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Mancom. | Olave Martin Juan |
Adm. Mancom. | Gonzalez Burgada Jordi |
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 47
16
Oct 2017
Con fecha 16/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Vidal Alonso Javier |
Consejero | Tejerina Diaz Luis |
Consejero | Realza Partners SL |
Consejero | Realza Capital Sgeic SA |
Consejero | Realza Asesores SL |
Representan | Peñaranda Gonzalez-Robatto Pedro |
Consejero | Gonzalez Acebes Juan Carlos |
Consejero | Garcia Muñoz Luis Javier |
Representan | De Zavala Valdes Alfredo |
Secretario | Benito Sanchez Roberto |
Consejero | Aparicio Magallon Carlos |
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 47
16
Oct 2017
Con fecha 16/10/2017 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias CARTERA GALENO SL.
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 47
29
Jun 2017
Con fecha 29/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Alandez Chamorro Francisco Javier |
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 46
07
Jun 2017
Con fecha 07/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Vidal Alonso Javier |
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 45
07
Jun 2017
Con fecha 07/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Davila Domecq Lorenzo |
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 45
26
Ene 2017
Con fecha 26/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 44
05
Ago 2016
Con fecha 05/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | De Rivas Calles Angel Luis |
Datos registrales: T 28302 , F 71, S 8, H M 218244, I/A 43
11
Abr 2016
Con fecha 11/04/2016, la sociedad cambia su domicilio social a C/ SAN FRANCISCO DE SALES 10 1& (MADRID).
Datos registrales: T 28302 , F 71, S 8, H M 218244, I/A 42
09
Dic 2015
Con fecha 09/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 28302 , F 71, S 8, H M 218244, I/A 41
12
May 2015
Con fecha 12/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Realza Partners SL |
Presidente | Realza Capital Sgecr SA |
Datos registrales: T 28302 , F 70, S 8, H M 218244, I/A 39
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-209-28 | Madrid | 30/10/2018 | |
BORME-A-2018-117-28 | Madrid | 20/06/2018 | |
BORME-A-2018-63-28 | Madrid | 02/04/2018 | |
BORME-A-2018-34-28 | Madrid | 16/02/2018 | |
BORME-A-2017-203-28 | Madrid | 24/10/2017 | |
BORME-A-2017-128-28 | Madrid | 07/07/2017 | |
BORME-A-2017-112-28 | Madrid | 15/06/2017 | |
BORME-A-2017-24-28 | Madrid | 03/02/2017 | |
BORME-A-2016-155-28 | Madrid | 16/08/2016 | |
BORME-A-2016-74-28 | Madrid | 19/04/2016 | |
BORME-A-2015-239-28 | Madrid | 16/12/2015 | |
BORME-A-2015-94-28 | Madrid | 21/05/2015 | |
BORME-A-2015-93-28 | Madrid | 20/05/2015 | |
BORME-A-2013-233-28 | Madrid | 05/12/2013 | |
BORME-A-2013-191-28 | Madrid | 07/10/2013 | |
BORME-A-2013-97-28 | Madrid | 27/05/2013 | |
BORME-A-2013-72-28 | Madrid | 17/04/2013 | |
BORME-A-2013-2-28 | Madrid | 03/01/2013 | |
BORME-A-2012-247-28 | Madrid | 27/12/2012 | |
BORME-A-2012-244-28 | Madrid | 21/12/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades