Última actualización: 23 de Noviembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A28783926 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Paseo De Recoletos Numero 37-41, Quinta Planta (Madrid). |
Capital social | 2.112.270,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VsecrNoConsj | Bermudez De Castro Navarro Miguel Pablo | 23/11/2023 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 21/01/2023 | Actualidad |
Apoderado | Salazar Fernandez Juan Carlos | 29/09/2021 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 03/02/2020 | Actualidad |
Vicepresid. | Seitz David Michael | 26/11/2019 | Actualidad |
Secretario | Seitz David Michael | 26/11/2019 | Actualidad |
Consejero | Seitz David Michael | 26/11/2019 | Actualidad |
Auditor | Rsm Spain Auditores SLP | 20/11/2018 | Actualidad |
Apoderado | Salazar Fernandez Juan Carlos | 04/09/2018 | Actualidad |
Vicepresid. | Mastalerz John Anthony | 29/05/2018 | Actualidad |
Consejero | Mastalerz John Anthony | 29/05/2018 | Actualidad |
Presidente | Fetsko Iii Michael Edward | 29/05/2018 | Actualidad |
Consejero | Fetsko Iii Michael Edward | 29/05/2018 | Actualidad |
Con.Delegado | Fetsko Iii Michael Edward | 29/05/2018 | Actualidad |
Auditor | Rsm Gasso Auditores SL | 18/11/2015 | Actualidad |
Auditor | Gasso Auditores SLP | 12/12/2014 | Actualidad |
Auditor | Gasso Auditores SLP | 17/02/2014 | Actualidad |
Vicepresid. | Seitz David Michael | 28/01/2014 | Actualidad |
Secretario | Seitz David Michael | 28/01/2014 | Actualidad |
Consejero | Seitz David Michael | 28/01/2014 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VsecrNoConsj | Merino Sanz Federico | 28/01/2014 | 23/11/2023 |
Presidente | Meyer David James | 04/11/2015 | 29/05/2018 |
Consejero | Meyer David James | 04/11/2015 | 29/05/2018 |
Con.Delegado | Meyer David James | 04/11/2015 | 29/05/2018 |
Vicepresid. | Hildum Keith Patrick | 28/01/2014 | 29/05/2018 |
Consejero | Hildum Keith Patrick | 28/01/2014 | 29/05/2018 |
Apoderado | Hartnett James J | Desconocido | 25/10/2017 |
Apoderado | Clark David Louis | Desconocido | 25/10/2017 |
Apoderado | Schwarz Roland Wilhelm | Desconocido | 04/11/2016 |
Presidente | Whiteford John Douglas | 12/12/2014 | 04/11/2015 |
Consejero | Whiteford John Douglas | 28/01/2014 | 04/11/2015 |
Con.Delegado | Whiteford John Douglas | 28/01/2014 | 04/11/2015 |
Vicepresid. | Whiteford John Douglas | 28/01/2014 | 12/12/2014 |
Presidente | Meyer David James | 28/01/2014 | 12/12/2014 |
Consejero | Meyer David James | 28/01/2014 | 12/12/2014 |
Representan | Waterman Dana Stephen | 25/01/2011 | 28/01/2014 |
Consejero | Waterman Dana Stephen | 25/01/2011 | 28/01/2014 |
Con.Delegado | Waterman Dana Stephen | 25/01/2011 | 28/01/2014 |
Consejero | Smith Gary Lynn | 20/06/2012 | 28/01/2014 |
Consejero | Lwi Elastomers International SL | 25/01/2011 | 28/01/2014 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Longwood Elastomers SA.
23
Nov 2023
Con fecha 23/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Bermudez De Castro Navarro Miguel Pablo |
Datos registrales: T 31151 , F 106, S 8, H M 39182, I/A 74
23
Nov 2023
Con fecha 23/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Merino Sanz Federico |
Datos registrales: T 31151 , F 106, S 8, H M 39182, I/A 74
21
Ene 2023
Con fecha 21/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 31151 , F 106, S 8, H M 39182, I/A 73
29
Sep 2021
Con fecha 29/09/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Salazar Fernandez Juan Carlos |
Datos registrales: T 31151 , F 106, S 8, H M 39182, I/A 72
03
Feb 2020
REVOCADO EL NOMBRAMIENTO DE AUDITOR PARA LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020 A LA ENTIDAD "RSM SPAIN AUDITORES SLP", anteriormente denominada "RSM GASSO AUDITORES SLP".
Datos registrales: T 31151 , F 106, S 8, H M 39182, I/A 71
03
Feb 2020
Con fecha 03/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 31151 , F 106, S 8, H M 39182, I/A 71
26
Nov 2019
Con fecha 26/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Seitz David Michael |
Datos registrales: T 31151 , F 105, S 8, H M 39182, I/A 70
20
Nov 2018
Con fecha 20/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Rsm Spain Auditores SLP |
Datos registrales: T 31151 , F 105, S 8, H M 39182, I/A 69
04
Sep 2018
Con fecha 04/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Salazar Fernandez Juan Carlos |
Datos registrales: T 31151 , F 104, S 8, H M 39182, I/A 68
29
May 2018
Con fecha 29/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mastalerz John Anthony |
Consejero | Fetsko Iii Michael Edward |
Datos registrales: T 31151 , F 104, S 8, H M 39182, I/A 67
29
May 2018
Con fecha 29/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Meyer David James |
Consejero | Hildum Keith Patrick |
Datos registrales: T 31151 , F 104, S 8, H M 39182, I/A 67
25
Oct 2017
Con fecha 25/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Hartnett James J |
Apoderado | Clark David Louis |
Datos registrales: T 31151 , F 104, S 8, H M 39182, I/A 66
04
Nov 2016
Con fecha 04/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Schwarz Roland Wilhelm |
Datos registrales: T 31151 , F 103, S 8, H M 39182, I/A 65
18
Nov 2015
Con fecha 18/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Rsm Gasso Auditores SL |
Datos registrales: T 31151 , F 103, S 8, H M 39182, I/A 64
04
Nov 2015
Con fecha 04/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Meyer David James |
Datos registrales: T 31151 , F 103, S 8, H M 39182, I/A 63
04
Nov 2015
Con fecha 04/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Whiteford John Douglas |
Datos registrales: T 31151 , F 103, S 8, H M 39182, I/A 63
12
Dic 2014
Con fecha 12/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Gasso Auditores SLP |
Datos registrales: T 31151 , F 102, S 8, H M 39182, I/A 62
12
Dic 2014
Con fecha 12/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Whiteford John Douglas |
Datos registrales: T 31151 , F 102, S 8, H M 39182, I/A 61
12
Dic 2014
Con fecha 12/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicepresid. | Whiteford John Douglas |
Presidente | Meyer David James |
Datos registrales: T 31151 , F 102, S 8, H M 39182, I/A 61
04
Mar 2014
Con fecha 04/03/2014, la sociedad cambia su domicilio social a PASEO DE RECOLETOS NUMERO 37-41, QUINTA PLANTA (MADRID).
Datos registrales: T 31151 , F 102, S 8, H M 39182, I/A 60
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-228-28 | Madrid | 30/11/2023 | |
BORME-A-2023-19-28 | Madrid | 27/01/2023 | |
BORME-A-2021-193-28 | Madrid | 06/10/2021 | |
BORME-A-2020-27-28 | Madrid | 10/02/2020 | |
BORME-A-2019-232-28 | Madrid | 03/12/2019 | |
BORME-A-2018-229-28 | Madrid | 29/11/2018 | |
BORME-A-2018-176-28 | Madrid | 12/09/2018 | |
BORME-A-2018-106-28 | Madrid | 05/06/2018 | |
BORME-A-2017-209-28 | Madrid | 02/11/2017 | |
BORME-A-2016-217-28 | Madrid | 15/11/2016 | |
BORME-A-2015-226-28 | Madrid | 26/11/2015 | |
BORME-A-2015-218-28 | Madrid | 16/11/2015 | |
BORME-A-2014-243-28 | Madrid | 22/12/2014 | |
BORME-A-2014-242-28 | Madrid | 19/12/2014 | |
BORME-A-2014-48-28 | Madrid | 11/03/2014 | |
BORME-A-2014-38-28 | Madrid | 25/02/2014 | |
BORME-A-2014-23-28 | Madrid | 04/02/2014 | |
BORME-A-2014-18-28 | Madrid | 28/01/2014 | |
BORME-A-2013-219-28 | Madrid | 15/11/2013 | |
BORME-A-2013-134-28 | Madrid | 17/07/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades