Última actualización: 30 de Junio de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 2 años, 9 meses |
---|---|
Forma jurídica | Limited company |
NIF | W0067319D |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Jose Celestino Mutis, Numero 4, 2c (San Sebastian De Los Reyes). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Walker Victor Charles | 18/06/2012 | 30/06/2021 |
Apoderado | Wagner Edward Harris | 09/01/2017 | 30/06/2021 |
Apo.Manc. | Soesman Ingo Martin Alexander | 09/01/2017 | 30/06/2021 |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington | 09/01/2017 | 30/06/2021 |
Apoderado | Shanks Geoffrey David Lorimer | 09/01/2017 | 30/06/2021 |
Apoderado | Sanchez Manso Marta Patricia | 21/04/2015 | 30/06/2021 |
Apoderado | Sanchez Manso Marta Patricia | 21/04/2015 | 30/06/2021 |
Apoderado | Onslow Elizabeth Jane | 21/04/2015 | 30/06/2021 |
Apoderado | Kelly John Michael | 21/04/2015 | 30/06/2021 |
Apoderado | Insley James Cristopher Paul | 11/09/2018 | 30/06/2021 |
Apo.Manc. | Hoogervorst John David | 09/01/2017 | 30/06/2021 |
R.L.C.Perma. | Green Richard William | 11/09/2018 | 30/06/2021 |
Apoderado | Green Richard William | 11/09/2018 | 30/06/2021 |
Apoderado | Fontanelles Ricard Daniel David | 21/04/2015 | 30/06/2021 |
Apo.Manc. | Brunekreef Alexander | 09/01/2017 | 30/06/2021 |
Apoderado | Vickers David Irving | 21/04/2015 | 11/09/2018 |
R.L.C.Perma. | Jennison Gary Antony | 09/01/2017 | 11/09/2018 |
Apoderado | Walker Charles Victor | 21/04/2015 | 09/01/2017 |
R.L.C.Perma. | Huda Khizerdul | 21/04/2015 | 09/01/2017 |
Apoderado | Huda Khizerdul | 21/04/2015 | 09/01/2017 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por London General Life Company LTD.
30
Jun 2021
Con fecha 30/06/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 37976 , F 196, S 8, H M 340473, I/A 12
30
Jun 2021
Con fecha 30/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Walker Victor Charles |
Apoderado | Wagner Edward Harris |
Apo.Manc. | Soesman Ingo Martin Alexander |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington |
Apoderado | Shanks Geoffrey David Lorimer |
Apoderado | Sanchez Manso Marta Patricia |
Apoderado | Onslow Elizabeth Jane |
Apoderado | Kelly John Michael |
Apoderado | Insley James Cristopher Paul |
Apo.Manc. | Hoogervorst John David |
Apoderado | Green Richard William |
Apoderado | Fontanelles Ricard Daniel David |
Apo.Manc. | Brunekreef Alexander |
Datos registrales: T 37976 , F 196, S 8, H M 340473, I/A 12
30
Jun 2021
Con fecha 30/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Green Richard William |
Datos registrales: T 37976 , F 196, S 8, H M 340473, I/A 12
22
Ene 2021
TOMA CONSTANCIA DE DIMISION Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD MATRIZ, ARTICULO 302 RRM.
Datos registrales: T 37976 , F 196, S 8, H M 340473, I/A 11
21
May 2019
Cambiado el NIF de la Sucursal, siendo el actual el W0067319D.
Datos registrales: T 19409 , F 140, S 8, H M 340473, I/A 1/M
11
Sep 2018
Con fecha 11/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Insley James Cristopher Paul |
Apoderado | Green Richard William |
Datos registrales: T 19409 , F 159, S 8, H M 340473, I/A 10
11
Sep 2018
Con fecha 11/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vickers David Irving |
Datos registrales: T 19409 , F 159, S 8, H M 340473, I/A 10
11
Sep 2018
Con fecha 11/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Jennison Gary Antony |
Datos registrales: T 19409 , F 159, S 8, H M 340473, I/A 10
09
Ene 2017
Con fecha 09/01/2017, la sociedad cambia su domicilio social a C/ JOSE CELESTINO MUTIS, NUMERO 4, 2C (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES).
Datos registrales: T 19409 , F 157, S 8, H M 340473, I/A 9
09
Ene 2017
Con fecha 09/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Wagner Edward Harris |
Apo.Manc. | Soesman Ingo Martin Alexander |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington |
Apoderado | Shanks Geoffrey David Lorimer |
R.L.C.Perma. | Jennison Gary Antony |
Apo.Manc. | Hoogervorst John David |
Apo.Manc. | Brunekreef Alexander |
Datos registrales: T 19409 , F 157, S 8, H M 340473, I/A 9
09
Ene 2017
Con fecha 09/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Walker Charles Victor |
Apoderado | Smith Martin Barrington |
Apoderado | Huda Khizerdul |
Apoderado | Fontanelles Ricard Daniel David |
Datos registrales: T 19409 , F 157, S 8, H M 340473, I/A 9
09
Ene 2017
Con fecha 09/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Huda Khizerdul |
Datos registrales: T 19409 , F 157, S 8, H M 340473, I/A 9
21
Abr 2015
Con fecha 21/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Walker Charles Victor |
Apoderado | Smith Martin Barrington |
Apoderado | Sanchez Manso Marta Patricia |
Apoderado | Huda Khizerdul |
Apoderado | Fontanelles Ricard Daniel David |
Datos registrales: T 19409 , F 157, S 8, H M 340473, I/A 8
21
Abr 2015
Con fecha 21/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vickers David Irving |
Apoderado | Sanchez Manso Marta Patricia |
Apoderado | Onslow Elizabeth Jane |
Apoderado | Kelly John Michael |
R.L.C.Perma. | Huda Khizerdul |
Datos registrales: T 19409 , F 155, S 8, H M 340473, I/A 7
21
Abr 2015
Con fecha 21/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Witt Geoffrey Alan |
Apoderado | Powell Roger Charles Jeremy |
Apoderado | Leach David Andrew |
Apoderado | Dalmau Salgas Jorge |
Datos registrales: T 19409 , F 155, S 8, H M 340473, I/A 7
21
Abr 2015
Con fecha 21/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Per.S. | Rodriguez Sobrino Edmundo |
R.L.C.Per.S. | Dalmau Salgas Jorge |
Datos registrales: T 19409 , F 155, S 8, H M 340473, I/A 7
18
Jun 2012
Con fecha 18/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Witt Geoffrey Alan |
Apoderado | Walker Victor Charles |
Apoderado | Powell Roger Charles Jeremy |
Apoderado | Leach David Andrew |
Apoderado | Fontanelles Ricard Daniel David |
Apoderado | Dalmau Salgas Jorge |
Datos registrales: T 19409 , F 153, S 8, H M 340473, I/A 6
18
Jun 2012
Con fecha 18/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Yus Respaldiza Javier |
Apoderado | Witt Geoffrey Alan |
Apoderado | Wilkinson Chris |
Apoderado | Walker Victor Charles |
Apoderado | Stodhart Andrew James |
Apoderado | Schauenberg Trevor |
Apoderado | Rua Patiño Maria Cruz |
Apoderado | Powell Roger Charles Jeremy |
Apoderado | Mieres Paul |
Apoderado | Mas Murcia Angel |
Apoderado | Levy Geoff |
Apoderado | Kenny Ian Steven |
Apoderado | Jarman Martin |
Apoderado | Insley James |
Apoderado | Hill Chris |
Apoderado | Fontanillas Richard Daniel David |
Apoderado | Estevez Luaña Rita |
Apoderado | Dalmau Salgas Jorge |
Apoderado | Cowdery Clive |
Datos registrales: T 19409 , F 153, S 8, H M 340473, I/A 6
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-128-28 | Madrid | 07/07/2021 |
BORME-A-2021-19-28 | Madrid | 29/01/2021 |
BORME-A-2019-99-28 | Madrid | 28/05/2019 |
BORME-A-2018-181-28 | Madrid | 19/09/2018 |
BORME-A-2017-11-28 | Madrid | 17/01/2017 |
BORME-A-2015-81-28 | Madrid | 30/04/2015 |
BORME-A-2012-124-28 | Madrid | 02/07/2012 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades