Última actualización: 7 de Julio de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 2 años, 9 meses |
---|---|
Forma jurídica | Limited company |
NIF | W0064975F |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Jose Celestino Mutis, Numero 4, 2c (San Sebastian De Los Reyes). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Walker Victor Charles | 11/05/2012 | 07/07/2021 |
Apoderado | Wagner Edward Harris | 09/01/2017 | 07/07/2021 |
Apo.Manc. | Soesman Ingo Martin Alexander | 09/01/2017 | 07/07/2021 |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington | 09/01/2017 | 07/07/2021 |
Apoderado | Shanks Geoffrey David Lorimer | 09/01/2017 | 07/07/2021 |
Apo.Manc. | Power Roger Charles Jeremy | 11/05/2012 | 07/07/2021 |
Apoderado | Kelly John Michael | 30/04/2015 | 07/07/2021 |
Apoderado | Jane Onslow Elizabeth | 30/04/2015 | 07/07/2021 |
Apoderado | Insley James Cristopher Paul | 11/09/2018 | 07/07/2021 |
Apo.Manc. | Hoogervorst John David | 09/01/2017 | 07/07/2021 |
R.L.C.Perma. | Green Richard William | 11/09/2018 | 07/07/2021 |
Apoderado | Green Richard William | 11/09/2018 | 07/07/2021 |
Apo.Manc. | Fontanillas Richard Daniel David | 11/05/2012 | 07/07/2021 |
Apo.Manc. | Brunekreef Alexander | 09/01/2017 | 07/07/2021 |
Apoderado | Vickers David Irving | 30/04/2015 | 11/09/2018 |
R.L.C.Perma. | Jennison Gary Antony | 09/01/2017 | 11/09/2018 |
Apo.Manc. | Walker Charles Victor | 30/04/2015 | 09/01/2017 |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington | 30/04/2015 | 09/01/2017 |
Representan | Huda Khizerdul | 30/04/2015 | 09/01/2017 |
Apo.Manc. | Huda Khizerdul | 30/04/2015 | 09/01/2017 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por London General Insurance Company LTD.
07
Jul 2021
Con fecha 07/07/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 12000 , F 212, S 8, H M 188774, I/A 19
07
Jul 2021
Acordado el cierre de la sucursal por acuerdo del órgano de administración de la sociedad matriz de la misma, de fecha 17 de mayo de 2.021.
Datos registrales: T 12000 , F 212, S 8, H M 188774, I/A 19
07
Jul 2021
Con fecha 07/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Walker Victor Charles |
Apoderado | Wagner Edward Harris |
Apo.Manc. | Soesman Ingo Martin Alexander |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington |
Apoderado | Shanks Geoffrey David Lorimer |
Apoderado | Kelly John Michael |
Apoderado | Jane Onslow Elizabeth |
Apoderado | Insley James Cristopher Paul |
Apo.Manc. | Hoogervorst John David |
Apoderado | Green Richard William |
Apo.Manc. | Fontanillas Richard Daniel David |
Apo.Manc. | Brunekreef Alexander |
Datos registrales: T 12000 , F 212, S 8, H M 188774, I/A 19
07
Jul 2021
Con fecha 07/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Green Richard William |
Datos registrales: T 12000 , F 212, S 8, H M 188774, I/A 19
22
Ene 2021
TOMA CONSTANCIA DE DIMISION Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD MATRIZ. (ART.302 RRM).
Datos registrales: T 12000 , F 211, S 8, H M 188774, I/A 18
11
Sep 2018
Con fecha 11/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Insley James Cristopher Paul |
Apoderado | Green Richard William |
Datos registrales: T 12000 , F 210, S 8, H M 188774, I/A 17
11
Sep 2018
Con fecha 11/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vickers David Irving |
Datos registrales: T 12000 , F 210, S 8, H M 188774, I/A 17
11
Sep 2018
Con fecha 11/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Jennison Gary Antony |
Datos registrales: T 12000 , F 210, S 8, H M 188774, I/A 17
09
Ene 2017
Con fecha 09/01/2017, la sociedad cambia su domicilio social a C/ JOSE CELESTINO MUTIS, NUMERO 4, 2C (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES).
Datos registrales: T 12000 , F 208, S 8, H M 188774, I/A 16
09
Ene 2017
Con fecha 09/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Wagner Edward Harris |
Apo.Manc. | Soesman Ingo Martin Alexander |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington |
Apoderado | Shanks Geoffrey David Lorimer |
R.L.C.Perma. | Jennison Gary Antony |
Apo.Manc. | Hoogervorst John David |
Apo.Manc. | Brunekreef Alexander |
Datos registrales: T 12000 , F 208, S 8, H M 188774, I/A 16
09
Ene 2017
Con fecha 09/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Walker Charles Victor |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington |
Apo.Manc. | Huda Khizerdul |
Apo.Manc. | Fontanelles Ricard Daniel David |
Datos registrales: T 12000 , F 208, S 8, H M 188774, I/A 16
09
Ene 2017
Con fecha 09/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Huda Khizerdul |
Datos registrales: T 12000 , F 208, S 8, H M 188774, I/A 16
30
Abr 2015
Con fecha 30/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Walker Charles Victor |
Apo.Manc. | Smith Martin Barrington |
Apo.Manc. | Huda Khizerdul |
Apo.Manc. | Fontanelles Ricard Daniel David |
Datos registrales: T 12000 , F 207, S 8, H M 188774, I/A 15
30
Abr 2015
Con fecha 30/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vickers David Irving |
Apoderado | Kelly John Michael |
Apoderado | Jane Onslow Elizabeth |
Representan | Huda Khizerdul |
Datos registrales: T 12000 , F 205, S 8, H M 188774, I/A 14
30
Abr 2015
Con fecha 30/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Witt Geoffrey Alan |
Apoderado | Rodriguez Sobrino Edmundo |
Apo.Manc. | Powell Roger Charles Jeremy |
Apo.Manc. | Leach David Andrew |
Apo.Manc. | Dalmau Salgas Jorge |
Datos registrales: T 12000 , F 205, S 8, H M 188774, I/A 14
11
May 2012
SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 13 EL NOMBRAMIENTO COMO APODERADO DE DON ROGER CHARLES JEREMY POWER, CUANDO LO CORRECTO ES DON ROGER CHARLES JEREMY POWELL.
Datos registrales: T 12000 , F 161, S 8, H M 188774, I/A 13
11
May 2012
Con fecha 11/05/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Witt Geoffrey Alan |
Apo.Manc. | Walker Victor Charles |
Apo.Manc. | Power Roger Charles Jeremy |
Apo.Manc. | Leach David Andrew |
Apo.Manc. | Fontanillas Richard Daniel David |
Apo.Manc. | Dalmau Salgas Jorge |
Datos registrales: T 12000 , F 161, S 8, H M 188774, I/A 13
11
May 2012
Con fecha 11/05/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Yus Respaldiza Javier |
Apoderado | Witt Geoffrey Alan |
Apoderado | Wilkinson Chris |
Apoderado | Walker Charles Victor |
Apoderado | Stodhart Andrew James |
Apoderado | Schauenberg Trevor |
Apoderado | Rua Patiño Maria Cruz |
Apoderado | Powell Roger Charles Jeromy |
Apoderado | Powell Roger Charles Jeremy |
Apoderado | Miers Paul |
Apoderado | Mas Murcia Angel |
Apoderado | Lsg Insurance Solutions SL |
Apoderado | Levy Geoff |
Apoderado | Kenny Ian Steven |
Apoderado | Jarman Martin |
Apoderado | Insley James |
Apoderado | Hill Chris |
Apoderado | Hennessy Stephen Edward |
Apoderado | Fontanillas Richard Daniel David |
Apoderado | Estevez Luaña Rita |
Apoderado | Dalmau Salgas Jorge |
Apoderado | Cowdery Clive |
Apoderado | Bradfield Nicholas Alan |
Apoderado | Bertlin Susan Margaret |
Datos registrales: T 12000 , F 161, S 8, H M 188774, I/A 13
20
Sep 2010
Con fecha 20/09/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lsg Insurance Solutions SL |
Datos registrales: T 12000 , F 160, S 8, H M 188774, I/A 12
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-133-28 | Madrid | 14/07/2021 |
BORME-A-2021-19-28 | Madrid | 29/01/2021 |
BORME-A-2018-181-28 | Madrid | 19/09/2018 |
BORME-A-2017-11-28 | Madrid | 17/01/2017 |
BORME-A-2015-87-28 | Madrid | 11/05/2015 |
BORME-A-2012-97-28 | Madrid | 24/05/2012 |
BORME-A-2010-188-28 | Madrid | 29/09/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades