Última actualización: 28 de Diciembre de 2015
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 8 años, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A45340015 |
Denominación anterior | Lm Glasfiber Eolica SA |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Anabel Segura 11 - Centro De Negocios Albatros, (Alcobendas). |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Suarez Tramon Alberto | 01/03/2013 | 28/12/2015 |
Apo.Sol. | Ruiz Marin Marta | 01/03/2013 | 28/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 11/06/2010 | 28/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 18/03/2014 | 28/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 01/06/2012 | 28/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 20/03/2014 | 28/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 25/11/2011 | 28/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 30/10/2009 | 28/12/2015 |
Apo.Manc. | Lazaro Alonso Antonio | 28/05/2013 | 28/12/2015 |
Apo.Manc. | Lazaro Alonso Antonio | 05/01/2009 | 28/12/2015 |
Consejero | Hoffer Soren | 13/01/2010 | 28/12/2015 |
Apo.Manc. | De Mingo Gonzalez Susana | 28/05/2013 | 28/12/2015 |
Apoderado | Cerro Prieto Ignacio | 24/11/2010 | 28/12/2015 |
Apo.Manc. | Burghard Erik | 28/05/2013 | 28/12/2015 |
Consejero | Bevan Richard Andrew | 06/08/2014 | 28/12/2015 |
Consejero | Balbuena Gomez Miguel Angel | 17/03/2014 | 28/12/2015 |
Consejero | Balbuena Gomez Miguel Angel | 24/11/2010 | 28/12/2015 |
Apo.Sol. | Balbuena Gomez Miguel Angel | 28/05/2013 | 28/12/2015 |
Apo.Manc. | Balbuena Gomez Miguel Angel | 05/11/2009 | 28/12/2015 |
Apo.Manc. | Balbuena Gomez Miguel Angel | 23/11/2009 | 28/12/2015 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Lm Wind Power Blades (Castellon) SA.
28
Dic 2015
Con fecha 28/12/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 40
28
Dic 2015
Con fecha 28/12/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 40
28
Dic 2015
Cancelados los asientos de la sociedad y cerrada la hoja registral.
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 40
03
Sep 2015
Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM.
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 39M
27
Jul 2015
Con fecha 27/07/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Balbuena Gomez Miguel Angel |
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 39
16
Mar 2015
Con fecha 16/03/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Muller Rene |
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 38
03
Nov 2014
Con fecha 03/11/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 32096 , F 2, S 8, H M 419347, I/A 37
06
Ago 2014
Con fecha 06/08/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Bevan Richard Andrew |
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 36
06
Ago 2014
Con fecha 06/08/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Nielsen Frank V |
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 36
11
Abr 2014
Con fecha 11/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Hoffer Soren |
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 35
20
Mar 2014
Con fecha 20/03/2014, la sociedad cambia su domicilio social a C/ ANABEL SEGURA 11 - CENTRO DE NEGOCIOS ALBATROS, (ALCOBENDAS).
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 34
20
Mar 2014
Con fecha 20/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 34
19
Mar 2014
Cambiada la denominación del socio único "Eolica de Palas S.A." a la nueva denominación "LM Wind Power Blades S.A.".
Datos registrales: T 32096 , F 1, S 8, H M 419347, I/A 33
18
Mar 2014
Con fecha 18/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 26197 , F 134, S 8, H M 419347, I/A 32
17
Mar 2014
Con fecha 17/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Nielsen Frank V |
Consejero | Balbuena Gomez Miguel Angel |
Datos registrales: T 26197 , F 133, S 8, H M 419347, I/A 31
17
Mar 2014
Con fecha 17/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Llaneza Alonso Graciela |
VsecrNoConsj | Cerro Prieto Ignacio |
Datos registrales: T 26197 , F 133, S 8, H M 419347, I/A 31
17
Mar 2014
Con fecha 17/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Montoro Cobles Patricia |
VsecrNoConsj | Martin Antolin Nicolas |
Vsecr2.NC | Cerro Prieto Ignacio |
Datos registrales: T 26197 , F 133, S 8, H M 419347, I/A 31
28
May 2013
Con fecha 28/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Muller Rene |
Apo.Manc. | Lazaro Alonso Antonio |
Apo.Manc. | Grau Navarro Jose Luis |
Apo.Manc. | De Mingo Gonzalez Susana |
Apo.Manc. | Cerro Prieto Ignacio |
Apo.Manc. | Burghard Erik |
Apo.Manc. | Balbuena Gomez Miguel Angel |
Datos registrales: T 26197 , F 132, S 8, H M 419347, I/A 30
23
Abr 2013
Con fecha 23/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Riesgo Martinez Florentino |
Apo.Manc. | Martinez Abasolo Maria Luisa |
Apo.Manc. | Martinez Abasolo Luisa |
Apo.Manc. | Lopez Garcia Sergio |
Apo.Sol. | Knudsen Soren F |
Apoderado | Berenguer Tormo Alejandro |
Datos registrales: T 26197 , F 131, S 8, H M 419347, I/A 29
01
Mar 2013
Con fecha 01/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Tejero Sarrion Eduardo |
Apo.Sol. | Suarez Tramon Alberto |
Apo.Sol. | Ruiz Marin Marta |
Vsecr2.NC | Cerro Prieto Ignacio |
Datos registrales: T 26197 , F 131, S 8, H M 419347, I/A 28
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2016-5-28 | Madrid | 11/01/2016 | |
BORME-A-2015-175-28 | Madrid | 14/09/2015 | |
BORME-A-2015-146-28 | Madrid | 04/08/2015 | |
BORME-A-2015-57-28 | Madrid | 25/03/2015 | |
BORME-A-2014-216-28 | Madrid | 12/11/2014 | |
BORME-A-2014-153-28 | Madrid | 13/08/2014 | |
BORME-A-2014-77-28 | Madrid | 23/04/2014 | |
BORME-A-2014-61-28 | Madrid | 28/03/2014 | |
BORME-A-2014-60-28 | Madrid | 27/03/2014 | |
BORME-A-2014-59-28 | Madrid | 26/03/2014 | |
BORME-A-2014-57-28 | Madrid | 24/03/2014 | |
BORME-A-2013-103-28 | Madrid | 04/06/2013 | |
BORME-A-2013-82-28 | Madrid | 03/05/2013 | |
BORME-A-2013-50-28 | Madrid | 13/03/2013 | |
BORME-A-2012-119-28 | Madrid | 25/06/2012 | |
BORME-A-2012-116-28 | Madrid | 20/06/2012 | |
BORME-A-2012-111-28 | Madrid | 13/06/2012 | |
BORME-A-2011-233-28 | Madrid | 12/12/2011 | |
BORME-A-2010-233-28 | Madrid | 07/12/2010 | |
BORME-A-2010-117-28 | Madrid | 22/06/2010 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades