Última actualización: 21 de Diciembre de 2015
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 8 años, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B36453587 |
Provincia | Pontevedra |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Varela Conde Jose Antonio | 13/11/2009 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Torres Silva Carlos | 11/04/2014 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Sanchez Rodriguez Juan Carlos | 13/11/2009 | 21/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 01/09/2014 | 21/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 03/01/2013 | 21/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 13/08/2009 | 21/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/10/2011 | 21/12/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 13/11/2013 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Moreno De Cayeux Andres Juan | 15/10/2010 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Marcos Sanchez Vicente | 15/10/2010 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Madera Garcia Antonio | 18/10/2011 | 21/12/2015 |
Apoderado | Lazaro Martinez Jorge | 27/09/2012 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Hurtado Marjalizo Francisco Manuel | 03/12/2010 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Garcia Fernandez Julio | 13/11/2009 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Garcia Del Hoyo Jose | 31/01/2011 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Gallardo Codorro Victoriano | 27/09/2012 | 21/12/2015 |
Apoderado | Estevez Alvarez German | 27/04/2011 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Diez Alvarez Juan Jose | 31/01/2011 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | De Lucas Diez Mariano | 08/02/2012 | 21/12/2015 |
Apo.Man.Soli | Carmena Cuerva Aurora | 27/09/2012 | 21/12/2015 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por La Veneciana Iberiaglass SL.
21
Dic 2015
Con fecha 21/12/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 199, S 8, H PO 33954, I/A 77
21
Dic 2015
Con fecha 21/12/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 199, S 8, H PO 33954, I/A 77
28
May 2015
Con fecha 28/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Cabezas Prieto Alejandro |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 199, S 8, H PO 33954, I/A 76
12
Ene 2015
Con fecha 12/01/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias SAINT GOBAIN CRISTALERIA SOCIEDAD LIMITADA.
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 199, S 8, H PO 33954, I/A 75
02
Dic 2014
Con fecha 02/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Vilariño Taboada Alfonso |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO 33954, I/A 74
01
Sep 2014
Con fecha 01/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO 33954, I/A 73
15
May 2014
Con fecha 15/05/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Marcos Sanchez Francisco Manuel |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO 33954, I/A 72
13
May 2014
SE RECTIFICA la inscripción 69&, en el sentido de que existe en la escritura un error en el orden de los apellidos del apoderado designado, siendo el orden correcto GONZALEZ FONSECA, siendo por tanto el APODERADO designado en dicha inscripción DON JOSE RODRIGO GONZALEZ FONSECA.
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO 33954, I/A 71
21
Abr 2014
Con fecha 21/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Garcia Corcoles Jorge |
Apo.Man.Soli | Crespo Gutierrez Anibal |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 198, S 8, H PO 33954, I/A 69
11
Abr 2014
Con fecha 11/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Fonseca Gonzalez Jose Rodrigo |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 197, S 8, H PO 33954, I/A 69
11
Abr 2014
Con fecha 11/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Torres Silva Carlos |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 196, S 8, H PO 33954, I/A 68
12
Mar 2014
Con fecha 12/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Mier Suarez Gonzalo |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 67
18
Dic 2013
Con fecha 18/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Garrabe Navarro Antonio |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 66
18
Dic 2013
Con fecha 18/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Carabantes Sanchez Santiago |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 66
18
Dic 2013
Con fecha 18/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Carabantes Sanchez Santiago |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 66
13
Nov 2013
Con fecha 13/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 65
28
Feb 2013
Con fecha 28/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Calabia Del Campo Ramon |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 64
03
Ene 2013
Con fecha 03/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 3826, L 3826, F 195, S 8, H PO 33954, I/A 63
22
Oct 2012
Con fecha 22/10/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Muñoz Ferrer Marta |
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 8, S 8, H PO 33954, I/A 62
27
Sep 2012
Con fecha 27/09/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Carmena Cuerva Aurora |
Datos registrales: T 3636, L 3636, F 6, S 8, H PO 33954, I/A 60
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2015-247-36 | Pontevedra | 29/12/2015 | |
BORME-A-2015-105-36 | Pontevedra | 08/06/2015 | |
BORME-A-2015-12-36 | Pontevedra | 20/01/2015 | |
BORME-A-2014-236-36 | Pontevedra | 11/12/2014 | |
BORME-A-2014-172-36 | Pontevedra | 10/09/2014 | |
BORME-A-2014-97-36 | Pontevedra | 26/05/2014 | |
BORME-A-2014-95-36 | Pontevedra | 22/05/2014 | |
BORME-A-2014-81-36 | Pontevedra | 29/04/2014 | |
BORME-A-2014-77-36 | Pontevedra | 23/04/2014 | |
BORME-A-2014-54-36 | Pontevedra | 19/03/2014 | |
BORME-A-2013-247-36 | Pontevedra | 27/12/2013 | |
BORME-A-2013-224-36 | Pontevedra | 22/11/2013 | |
BORME-A-2013-50-36 | Pontevedra | 13/03/2013 | |
BORME-A-2013-8-36 | Pontevedra | 14/01/2013 | |
BORME-A-2012-211-36 | Pontevedra | 02/11/2012 | |
BORME-A-2012-195-36 | Pontevedra | 09/10/2012 | |
BORME-A-2012-84-36 | Pontevedra | 04/05/2012 | |
BORME-A-2012-35-36 | Pontevedra | 20/02/2012 | |
BORME-A-2011-211-36 | Pontevedra | 07/11/2011 | |
BORME-A-2011-205-36 | Pontevedra | 27/10/2011 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades