Última actualización: 2 de Junio de 2011
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 12 años, 9 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A58827312 |
Provincia | Madrid |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Wooden Kevan John | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Wooden Kevan John | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Voltolina Frank A | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Rodriguez Caballero Manuel | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Montoya Blanco Alejandro | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Man.Soli | Mayorga Cendra Arturo Maria | 11/02/2009 | 02/06/2011 |
Consejero | Lowery Thomas Eugene | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Lowery Thomas Eugene | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Kurz Oliver | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Florez Leibar Enrique | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Fes Garcia Maria Del Pilar | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Man.Soli | Fes Garcia Maria Del Pilar | 11/02/2009 | 02/06/2011 |
Presidente | Fernandez De Bordons Javier | 18/06/2010 | 02/06/2011 |
Consejero | Fernandez De Bordons Javier | 18/06/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Fernandez De Bordons Javier | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Del Natale Mario | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | De Waele Jean-Philippe | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Carci Cervera Armando | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Brouet Olivier | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Apo.Manc. | Augustin Jeffrey G | 21/10/2010 | 02/06/2011 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Johnson Controls Security Systems SA.
02
Jun 2011
Con fecha 02/06/2011 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 21084 , F 94, S 8, H M 374168, I/A 12
02
Jun 2011
Con fecha 02/06/2011 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 21084 , F 94, S 8, H M 374168, I/A 12
21
Oct 2010
Con fecha 21/10/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Wooden Kevan John |
Apo.Manc. | Voltolina Frank A |
Apo.Manc. | Rodriguez Caballero Manuel |
Apo.Manc. | Montoya Blanco Alejandro |
Consejero | Lowery Thomas Eugene |
Apo.Manc. | Kurz Oliver |
Apo.Manc. | Florez Leibar Enrique |
Apo.Manc. | Fes Garcia Maria Del Pilar |
Apo.Manc. | Fernandez De Bordons Javier |
Apo.Manc. | Del Natale Mario |
Apo.Manc. | De Waele Jean-Philippe |
Apo.Manc. | Carci Cervera Armando |
Apo.Manc. | Brouet Olivier |
Apo.Manc. | Augustin Jeffrey G |
Datos registrales: T 21084 , F 92, S 8, H M 374168, I/A 11
21
Oct 2010
Con fecha 21/10/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Voltolina Frank A |
Apo.Man.Soli | Rodriguez Caballero Manuel |
Apo.Man.Soli | Pactrick Murphy John |
Apo.Man.Soli | Montoya Blanco Alejandro |
Apo.Manc. | Laroyla Varun |
Apo.Manc. | Kurz Oliver |
Apoderado | Florez Leibar Enrique |
Apoderado | Fes Garcia Maria Del Pilar |
Apo.Man.Soli | Fernandez De Bordons Javier |
Apo.Manc. | Del Natale Mario |
Apo.Manc. | De Waele Jean-Philippe |
Apo.Man.Soli | Culav Dragomir Gregory |
Apo.Man.Soli | Carci Cervera Armando |
Apo.Manc. | Brouet Olivier |
Apo.Manc. | Augustin Jeffrey G |
Datos registrales: T 21084 , F 92, S 8, H M 374168, I/A 11
21
Oct 2010
Con fecha 21/10/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Murphy John Patrick |
Consejero | Culav Dragomir Gregory |
Datos registrales: T 21084 , F 92, S 8, H M 374168, I/A 11
13
Jul 2010
Con fecha 13/07/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 21084 , F 92, S 8, H M 374168, I/A 10
18
Jun 2010
LA INSTALACION, EL MANEJO, LA REPARACION, LA ATENCION Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS, CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD, ASI COMO LA PRESTACION DE CUALESQUIERA SERVICIOS ACCESORIOS O COMPLEMENTARIOS A LAS ANTERIORES ACTIVIDADES.-
Datos registrales: T 21084 , F 91, S 8, H M 374168, I/A 9
18
Jun 2010
Con fecha 18/06/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Fernandez De Bordons Javier |
Datos registrales: T 21084 , F 91, S 8, H M 374168, I/A 9
18
Mar 2010
Con fecha 18/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Florez Leibar Enrique |
Apoderado | Fes Garcia Maria Del Pilar |
Datos registrales: T 21084 , F 89, S 8, H M 374168, I/A 8
11
Feb 2009
Con fecha 11/02/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Voltolina Frank A |
Apo.Man.Soli | Rodriguez Caballero Manuel |
Apo.Man.Soli | Pactrick Murphy John |
Apo.Man.Soli | Montoya Blanco Alejandro |
Apo.Man.Soli | Mayorga Cendra Arturo Maria |
Apo.Manc. | Laroyla Varun |
Apo.Manc. | Kurz Oliver |
Apo.Man.Soli | Fes Garcia Maria Del Pilar |
Apo.Man.Soli | Fernandez De Bordons Javier |
Apo.Manc. | Del Natale Mario |
Apo.Manc. | De Waele Jean-Philippe |
Apo.Man.Soli | Culav Dragomir Gregory |
Apo.Man.Soli | Carci Cervera Armando |
Apo.Manc. | Brouet Olivier |
Apo.Manc. | Augustin Jeffrey G |
Datos registrales: T 21084 , F 87, S 8, H M 374168, I/A 7
11
Feb 2009
Con fecha 11/02/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rodriguez Caballero Manuel |
Apoderado | Parquet Philippe G J |
Apoderado | Laermans Roger J L |
Apo.Manc. | Juarez Lopez Rufino |
Apoderado | Hidalgo Rodriguez Maria Del Mar |
Apoderado | Fes Garcia Maria Del Pilar |
Apoderado | Fernandez De Bordons Javier |
Datos registrales: T 21084 , F 87, S 8, H M 374168, I/A 7
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2011-112-28 | Madrid | 13/06/2011 |
BORME-A-2010-211-28 | Madrid | 03/11/2010 |
BORME-A-2010-140-28 | Madrid | 23/07/2010 |
BORME-A-2010-122-28 | Madrid | 29/06/2010 |
BORME-A-2010-61-28 | Madrid | 31/03/2010 |
BORME-A-2009-35-28 | Madrid | 20/02/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades