Última actualización: 30 de Agosto de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 2 años, 7 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B87293411 |
Provincia | Madrid |
Fecha de constitución | 12 de Junio de 2015 (hace 8 años, 9 meses) |
Domicilio | C/ Pinar 7 5º - Izquierda (Madrid) |
Objeto social | La sociedad tiene por objeto la adquisicion y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. |
Capital social | 3.000,0 euros |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Viciene Julija | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Apoderado | Salvador Alamar Lucia | 24/01/2020 | 30/08/2021 |
Representan | Rosales Rodriguez Juan | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 04/02/2016 | 30/08/2021 |
Apo.Manc. | Poliuskevicius Tautvydas | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Vicesecret. | Peña Abogados Y Asesores Tributarios SL | 24/01/2020 | 30/08/2021 |
Liquidador | Peña Abogados Y Asesores Tributarios SL | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
Apo.Man.Soli | Perez-Pellon Valentin-Gamazo Julia | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Apo.Man.Soli | Pastrana Gomez Elena | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Apo.Manc. | Pancerevas Vitalis | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Apo.Man.Soli | Ortega Sanchez Ruben | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Apo.Manc. | Malciauskaite Dovile | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Apo.Manc. | Lang Paul | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Consejero | Gomez Diez Isabel | 04/09/2015 | 30/08/2021 |
Apo.Man.Soli | Gomez Diez Isabel | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Presidente | Ford Ian Christopher Jason | 23/11/2015 | 30/08/2021 |
Apoderado | Ford Ian Christopher Jason | 08/11/2019 | 30/08/2021 |
Apoderado | Ford Ian Christopher Jason | 23/11/2015 | 30/08/2021 |
Apoderado | Ford Ian Christopher Jason | 23/11/2015 | 30/08/2021 |
Apo.Manc. | Budvytyte Milda | 05/04/2019 | 30/08/2021 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Inversiones Molloy SL.
30
Ago 2021
Con fecha 30/08/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 33556 , F 218, S 8, H M 603979, I/A 15
30
Ago 2021
Con fecha 30/08/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 33556 , F 218, S 8, H M 603979, I/A 15
30
Ago 2021
Con fecha 30/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Rosales Rodriguez Juan |
Liquidador | Peña Abogados Y Asesores Tributarios SL |
Datos registrales: T 33556 , F 218, S 8, H M 603979, I/A 15
30
Ago 2021
Con fecha 30/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Viciene Julija |
Apo.Man.Soli | Valcarcel Sanchez Paula |
Apo.Manc. | Simaityte Justina |
Apoderado | Salvador Alamar Lucia |
Apo.Man.Soli | Saez Serrano Sara |
Apo.Manc. | Poliuskevicius Tautvydas |
Apoderado | Pires Dos Santos Francisco Ipo |
Apo.Manc. | Petraviciute Ineta |
Apo.Man.Soli | Perez-Pellon Valentin-Gamazo Julia |
Apo.Manc. | Patel Vikash |
Apo.Man.Soli | Pastrana Gomez Elena |
Apo.Manc. | Pancerevas Vitalis |
Apo.Man.Soli | Ortega Sanchez Ruben |
Apoderado | Melvin Gamir Mia Maria Teresa |
Apo.Sol. | Medina Gonzalez Pablo |
Apo.Manc. | Maniusyte Gaudvile |
Apo.Manc. | Malciauskaite Dovile |
Apo.Manc. | Lang Paul |
Apo.Man.Soli | Gomez Diez Isabel |
Apoderado | Ford Ian Christopher Jason |
Apo.Manc. | Fedotovas Arturas |
Apo.Sol. | Escribano Iglesias Pablo |
Apo.Manc. | Budvytyte Milda |
Apoderado | Baillie Sean Albert Lamont |
Datos registrales: T 33556 , F 218, S 8, H M 603979, I/A 15
30
Ago 2021
Con fecha 30/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Rosales Rodriguez Juan |
Vicesecret. | Peña Abogados Y Asesores Tributarios SL |
Consejero | Gomez Diez Isabel |
Consejero | Ford Ian Christopher Jason |
Datos registrales: T 33556 , F 218, S 8, H M 603979, I/A 15
18
May 2021
Reducción de capital
Datos registrales: T 33556 , F 218, S 8, H M 603979, I/A 14
24
Ene 2020
Con fecha 24/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Salvador Alamar Lucia |
Representan | Rosales Rodriguez Juan |
Consejero | Peña Abogados Y Asesores Tributarios SL |
Datos registrales: T 33556 , F 217, S 8, H M 603979, I/A 13
24
Ene 2020
Con fecha 24/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Castaño Castro Concepcion |
Datos registrales: T 33556 , F 217, S 8, H M 603979, I/A 13
24
Ene 2020
Con fecha 24/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicesecret. | Castaño Castro Concepcion |
Datos registrales: T 33556 , F 217, S 8, H M 603979, I/A 13
08
Nov 2019
Con fecha 08/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Pires Dos Santos Francisco Ipo |
Apoderado | Ford Ian Christopher Jason |
Apoderado | Castaño Castro Concepcion |
Apoderado | Baillie Sean Albert Lamont |
Datos registrales: T 33556 , F 215, S 8, H M 603979, I/A 12
08
Nov 2019
Con fecha 08/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | O'Reilly David Patrick |
Apo.Sol. | Melvin Gamir Mia Maria Teresa |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Hernandez Paloma |
Datos registrales: T 33556 , F 215, S 8, H M 603979, I/A 12
08
Nov 2019
Con fecha 08/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicesecret. | Gonzalez Hernandez Paloma |
Datos registrales: T 33556 , F 215, S 8, H M 603979, I/A 12
06
May 2019
Con fecha 06/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Medina Gonzalez Pablo |
Apo.Sol. | Escribano Iglesias Pablo |
Datos registrales: T 33556 , F 215, S 8, H M 603979, I/A 11
05
Abr 2019
Con fecha 05/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Viciene Julija |
Apo.Man.Soli | Valcarcel Sanchez Paula |
Apo.Manc. | Simaityte Justina |
Apo.Man.Soli | Saez Serrano Sara |
Apo.Manc. | Poliuskevicius Tautvydas |
Apo.Manc. | Petraviciute Ineta |
Apo.Man.Soli | Perez-Pellon Valentin-Gamazo Julia |
Apo.Manc. | Patel Vikash |
Apo.Man.Soli | Pastrana Gomez Elena |
Apo.Manc. | Pancerevas Vitalis |
Apo.Man.Soli | Ortega Sanchez Ruben |
Apo.Manc. | O'Reilly David Patrick |
Apo.Sol. | Melvin Gamir Mia Maria Teresa |
Apo.Manc. | Maniusyte Gaudvile |
Apo.Manc. | Malciauskaite Dovile |
Apo.Manc. | Lang Paul |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Hernandez Paloma |
Apo.Man.Soli | Gomez Diez Isabel |
Apo.Manc. | Fedotovas Arturas |
Apo.Manc. | Budvytyte Milda |
Datos registrales: T 33556 , F 127, S 8, H M 603979, I/A 10
05
Abr 2019
Con fecha 05/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Viciene Julija |
Apoderado | Saez Serrano Sara |
Apoderado | Petraviciute Ineta |
Apoderado | Perez-Pellon Valentin-Gamazo Julia |
Apoderado | Pastrana Gomez Elena |
Apoderado | Maniusyte Gaudvile |
Apoderado | Gonzalez Hernandez Paloma |
Apoderado | Gomez Diez Isabel |
Apoderado | Budvytyte Milda |
Datos registrales: T 33556 , F 127, S 8, H M 603979, I/A 10
14
Sep 2018
SE SUBSANA LA ESCRITURA ORIGEN DE LA INSCRIPCION 7, EN EL SENTIDO DE HACER CONSTAR QUE SE TRNSCRIBIO INCORRECTAMENTE EL NOMBRE DE UNA DE LAS APODERADAS EN EL ACUERDO TERCERO, APARTADO D) SIENDO EL CORRECTO DOÑA JULIJA VICIENE Y NO DOÑA AUSTEJA SOSTAKAITE.
Datos registrales: T 33556 , F 127, S 8, H M 603979, I/A 9
22
May 2018
Con fecha 22/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Melvin Gamir Mia Maria Teresa |
Datos registrales: T 33556 , F 126, S 8, H M 603979, I/A 8
22
May 2018
Con fecha 22/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Carrascal Alonso Aurora |
Datos registrales: T 33556 , F 126, S 8, H M 603979, I/A 8
31
Ene 2018
Con fecha 31/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sostakaite Austeja |
Apoderado | Saez Serrano Sara |
Apoderado | Petraviciute Ineta |
Apoderado | Perez-Pellon Valentin-Gamazo Julia |
Apoderado | Pastrana Gomez Elena |
Apoderado | Maniusyte Gaudvile |
Apoderado | Budvytyte Milda |
Datos registrales: T 33556 , F 126, S 8, H M 603979, I/A 7
31
Ene 2018
Con fecha 31/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Hernandez Hernandez Raquel |
Datos registrales: T 33556 , F 126, S 8, H M 603979, I/A 7
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-171-28 | Madrid | 06/09/2021 |
BORME-A-2021-97-28 | Madrid | 25/05/2021 |
BORME-A-2020-21-28 | Madrid | 31/01/2020 |
BORME-A-2019-220-28 | Madrid | 15/11/2019 |
BORME-A-2019-89-28 | Madrid | 13/05/2019 |
BORME-A-2019-72-28 | Madrid | 12/04/2019 |
BORME-A-2018-184-28 | Madrid | 24/09/2018 |
BORME-A-2018-101-28 | Madrid | 29/05/2018 |
BORME-A-2018-28-28 | Madrid | 08/02/2018 |
BORME-A-2016-28-28 | Madrid | 11/02/2016 |
BORME-A-2015-230-28 | Madrid | 02/12/2015 |
BORME-A-2015-178-28 | Madrid | 17/09/2015 |
BORME-A-2015-175-28 | Madrid | 14/09/2015 |
BORME-A-2015-115-28 | Madrid | 22/06/2015 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades