Última actualización: 8 de Marzo de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 6 años, 2 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B63296107 |
Denominación anterior | Hera Ener G SL |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 5.928.876,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Torrente Rodriguez Francisco Miguel | 27/10/2017 | 08/03/2018 |
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier | 17/05/2016 | 08/03/2018 |
APOD.SOL/MAN | Niñe Reigosa Marcelino | 10/06/2016 | 08/03/2018 |
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan | 27/04/2016 | 08/03/2018 |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL | 27/04/2016 | 08/03/2018 |
APOD.MANCOMU | Griño Tomas Miguel Jose | 30/03/2016 | 29/11/2016 |
APOD.MANCOMU | Gallego Rubio Jorge | 30/03/2016 | 29/11/2016 |
ADM.SOLIDAR. | Lopez Bosch Pablo Solesio | 19/10/2011 | 27/04/2016 |
ADM.SOLIDAR. | Gallego Rubio Jorge | 19/10/2011 | 27/04/2016 |
APODERAD.SOL | Griño Tomas Miguel Jose | 03/06/2014 | 16/02/2016 |
DTOR.FINANC. | Abellan Marichalar Enrique | Desconocido | 16/02/2016 |
APODERADO | Polo Gomez Luis | 05/06/2009 | 22/11/2011 |
DTOR.GENERAL | Hugh Kerr Richmond | Desconocido | 28/10/2011 |
CONSEJERO | Perez Del Molino Martinez Jose Maria | Desconocido | 19/10/2011 |
PRESIDENTE | Martinez Ferreira Rafael | 02/03/2011 | 19/10/2011 |
CONSEJERO | Martinez Ferreira Rafael | 02/03/2011 | 19/10/2011 |
VICEPRESIDEN | Hugh Kerr Richmond | 02/03/2011 | 19/10/2011 |
CONSEJERO | Hugh Kerr Richmond | Desconocido | 19/10/2011 |
SECR.NO CONS | Griño Tomas Miguel Jose | 03/04/2009 | 19/10/2011 |
CONSEJERO | Derek John Duffill | 08/03/2010 | 19/10/2011 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Hera Gas SL.
08
Mar 2018
Con fecha 08/03/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 45281 , F 193, S 8, H B 270627, I/A 28
08
Mar 2018
Con fecha 08/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Torrente Rodriguez Francisco Miguel |
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier |
APOD.SOL/MAN | Niñe Reigosa Marcelino |
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL |
Datos registrales: T 45281 , F 193, S 8, H B 270627, I/A 28
27
Oct 2017
Con fecha 27/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Torrente Rodriguez Francisco Miguel |
Datos registrales: T 45281 , F 193, S 8, H B 270627, I/A 27
29
Nov 2016
Con fecha 29/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Griño Tomas Miguel Jose |
APOD.MANCOMU | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 45281 , F 193, S 8, H B 270627, I/A 26
10
Jun 2016
Con fecha 10/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Niñe Reigosa Marcelino |
Datos registrales: T 45281 , F 192, S 8, H B 270627, I/A 25
17
May 2016
Con fecha 17/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier |
Datos registrales: T 45281 , F 191, S 8, H B 270627, I/A 24
27
Abr 2016
Con fecha 27/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL |
Datos registrales: T 45281 , F 191, S 8, H B 270627, I/A 23
27
Abr 2016
Con fecha 27/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.SOLIDAR. | Lopez Bosch Pablo Solesio |
ADM.SOLIDAR. | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 45281 , F 191, S 8, H B 270627, I/A 23
30
Mar 2016
Con fecha 30/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Griño Tomas Miguel Jose |
APOD.MANCOMU | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 41263 , F 188, S 8, H B 270627, I/A 22
16
Feb 2016
Con fecha 16/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Griño Tomas Miguel Jose |
Datos registrales: T 41263 , F 188, S 8, H B 270627, I/A 21
16
Feb 2016
Con fecha 16/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
DTOR.FINANC. | Abellan Marichalar Enrique |
Datos registrales: T 41263 , F 188, S 8, H B 270627, I/A 20
03
Jun 2014
Con fecha 03/06/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Griño Tomas Miguel Jose |
Datos registrales: T 41263 , F 187, S 8, H B 270627, I/A 19
24
Feb 2012
Con fecha 24/02/2012, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 5.925.870,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 197134.73% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 5.928.876,0€.
Datos registrales: T 41263 , F 185, S 8, H B 270627, I/A 18
09
Dic 2011
DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:"HERA HOLDING HABITAT ECOLOGIA Y RESTAURACION AMBIENTAL SL".
Datos registrales: T 41263 , F 185, S 8, H B 270627, I/A 17
22
Nov 2011
Con fecha 22/11/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Polo Gomez Luis |
Datos registrales: T 41263 , F 185, S 8, H B 270627, I/A 16
10
Nov 2011
Con fecha 10/11/2011, la sociedad cambia su denominación social a HERA GAS SL
Datos registrales: T 41263 , F 185, S 8, H B 270627, I/A 15
28
Oct 2011
Con fecha 28/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
DTOR.GENERAL | Hugh Kerr Richmond |
Datos registrales: T 41263 , F 185, S 8, H B 270627, I/A 14
19
Oct 2011
Con fecha 19/10/2011, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTS.6.3,9.3,11,13:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.
Datos registrales: T 41263 , F 182, S 8, H B 270627, I/A 13
19
Oct 2011
Con fecha 19/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.SOLIDAR. | Lopez Bosch Pablo Solesio |
ADM.SOLIDAR. | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 41263 , F 182, S 8, H B 270627, I/A 13
19
Oct 2011
Con fecha 19/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Perez Del Molino Martinez Jose Maria |
CONSEJERO | Martinez Ferreira Rafael |
CONSEJERO | Hugh Kerr Richmond |
SECR.NO CONS | Griño Tomas Miguel Jose |
CONSEJERO | Derek John Duffill |
Datos registrales: T 41263 , F 182, S 8, H B 270627, I/A 13
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2018-54-08 | Barcelona | 16/03/2018 |
BORME-A-2017-212-08 | Barcelona | 07/11/2017 |
BORME-A-2016-232-08 | Barcelona | 07/12/2016 |
BORME-A-2016-115-08 | Barcelona | 17/06/2016 |
BORME-A-2016-98-08 | Barcelona | 25/05/2016 |
BORME-A-2016-86-08 | Barcelona | 06/05/2016 |
BORME-A-2016-66-08 | Barcelona | 07/04/2016 |
BORME-A-2016-38-08 | Barcelona | 25/02/2016 |
BORME-A-2016-37-08 | Barcelona | 24/02/2016 |
BORME-A-2014-108-08 | Barcelona | 10/06/2014 |
BORME-A-2012-46-08 | Barcelona | 06/03/2012 |
BORME-A-2011-240-08 | Barcelona | 21/12/2011 |
BORME-A-2011-230-08 | Barcelona | 05/12/2011 |
BORME-A-2011-221-08 | Barcelona | 22/11/2011 |
BORME-A-2011-215-08 | Barcelona | 14/11/2011 |
BORME-A-2011-207-08 | Barcelona | 31/10/2011 |
BORME-A-2011-51-08 | Barcelona | 15/03/2011 |
BORME-A-2010-53-08 | Barcelona | 18/03/2010 |
BORME-A-2009-113-08 | Barcelona | 18/06/2009 |
BORME-A-2009-73-08 | Barcelona | 20/04/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades