Última actualización: 7 de Febrero de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 2 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B64118722 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Rb Catalunya Num.98 P.7 Pta.2 (Barcelona). |
Capital social | 13.899.000,0 euros |
Motivo de la disolución | Judicial. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM.CONCURS. | Zarco Puente Carlos | 16/11/2015 | 07/02/2019 |
APODERADO | Soler Palau Jorge | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
APODERADO | Riera Canchal Joaquin | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
APODERADO | Plana Farin Alejandro | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
APODERADO | Perez Rovira Jorge | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
APODERADO | Molinario Valls Julio | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
APODERADO | Lopez Serentill Esther | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
APODERADO | Larramona Mora Daniel | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
APODERADO | Fenoy Palomas Ramon | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
APODERADO | Castan Ranch Ricardo | 05/08/2011 | 07/02/2019 |
REPR.143 RRM | Vila Tarrago Josep | 26/02/2014 | 16/11/2015 |
REPR.143 RRM | Texido Halter Cesar | 05/11/2013 | 16/11/2015 |
REPR.143 RRM | Tarrega Roberto Francisco Jose | 26/02/2014 | 16/11/2015 |
CONSEJERO | Promotora Catalunya Mediterranea SA | 05/08/2011 | 16/11/2015 |
REPR.143 RRM | Ortola Fayos Jose | 25/07/2012 | 16/11/2015 |
CONSEJERO | Medina Ruiz Francisco Javier | 05/11/2013 | 16/11/2015 |
PRESIDENTE | Lopez Domenech Fernando | Desconocido | 16/11/2015 |
CONSEJERO | Harmonia 45 SL | 05/11/2013 | 16/11/2015 |
CONSEJERO | Bosch Pujol Pere | Desconocido | 16/11/2015 |
CONSEJERO | Activos Macorp SL | 05/08/2011 | 16/11/2015 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Harmonia Pla De Ponent SL.
07
Feb 2019
Con fecha 07/02/2019 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 43293 , F 4, S 8, H B 325312, I/A 35
07
Feb 2019
JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 912/2013, AUTO FIRME DE FECHA 13/12/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43293 , F 4, S 8, H B 325312, I/A 35
07
Feb 2019
Con fecha 07/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Zarco Puente Carlos |
Datos registrales: T 43293 , F 4, S 8, H B 325312, I/A 35
16
Nov 2015
Con fecha 16/11/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Judicial.
Datos registrales: T 43293 , F 4, S 8, H B 325312, I/A 34
16
Nov 2015
JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 912/2013,RESOLUCIONES FIRMES,DE FECHA 01/10/2014:APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION;Y DE 18/02/2015:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43293 , F 4, S 8, H B 325312, I/A 34
16
Nov 2015
Con fecha 16/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Vila Tarrago Josep |
REPR.143 RRM | Texido Halter Cesar |
REPR.143 RRM | Tarrega Roberto Francisco Jose |
SECR.NO CONS | Riera Canchal Joaquim |
CONSEJERO | Promotora Catalunya Mediterranea SA |
REPR.143 RRM | Ortola Fayos Jose |
CONSEJERO | Medina Ruiz Francisco Javier |
CONSEJERO | Lopez Serentill Esther |
CONSEJERO | Lopez Domenech Fernando |
CONSEJERO | Lopez Bonet Ignacio De Loyola |
CONSEJERO | Harmonia 45 SL |
CONSEJERO | Encina Los Monteros SL |
CONSEJERO | Bosch Pujol Pere |
CONSEJERO | Activos Macorp SL |
Datos registrales: T 43293 , F 4, S 8, H B 325312, I/A 34
16
Nov 2015
JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 912/2013, AUTO FIRME DE FECHA 25/11/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43293 , F 3, S 8, H B 325312, I/A 33
16
Nov 2015
Con fecha 16/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Zarco Puente Carlos |
Datos registrales: T 43293 , F 3, S 8, H B 325312, I/A 33
26
Feb 2014
Con fecha 26/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Vila Tarrago Josep |
Datos registrales: T 43293 , F 3, S 8, H B 325312, I/A 32
26
Feb 2014
Con fecha 26/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger |
Datos registrales: T 43293 , F 3, S 8, H B 325312, I/A 32
26
Feb 2014
Con fecha 26/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Tarrega Roberto Francisco Jose |
Datos registrales: T 43293 , F 3, S 8, H B 325312, I/A 31
26
Feb 2014
Con fecha 26/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
Datos registrales: T 43293 , F 3, S 8, H B 325312, I/A 31
05
Nov 2013
Con fecha 05/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Texido Halter Cesar |
CONSEJERO | Medina Ruiz Francisco Javier |
CONSEJERO | Lopez Bonet Ignacio De Loyola |
CONSEJERO | Harmonia 45 SL |
VICEPRESIDEN | Bosch Pujol Pere |
Datos registrales: T 43293 , F 2, S 8, H B 325312, I/A 30
05
Nov 2013
Con fecha 05/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VICEPRESIDEN | Xercavins Lluch Jose Maria |
CONSEJERO | Aguilera Ballester Xavier |
Datos registrales: T 43293 , F 2, S 8, H B 325312, I/A 30
17
Oct 2013
Con fecha 17/10/2013, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 120.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 0.87% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 13.899.000,0€.
Datos registrales: T 43293 , F 2, S 8, H B 325312, I/A 29
06
Ago 2013
Con fecha 06/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Molinario Valls Julio |
Datos registrales: T 43293 , F 1, S 8, H B 325312, I/A 28
23
Jul 2013
Con fecha 23/07/2013, la sociedad cambia su domicilio social a RB CATALUNYA Num.98 P.7 PTA.2 (BARCELONA).
Datos registrales: T 43293 , F 1, S 8, H B 325312, I/A 27
18
Feb 2013
Con fecha 18/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger |
Datos registrales: T 43293 , F 1, S 8, H B 325312, I/A 26
18
Feb 2013
Con fecha 18/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Gallart Sulla Eduard |
Datos registrales: T 43293 , F 1, S 8, H B 325312, I/A 26
25
Jul 2012
Con fecha 25/07/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Molinario Valls Julio |
CONSEJERO | Aguilera Ballester Xavier |
Datos registrales: T 43293 , F 1, S 8, H B 325312, I/A 25
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2019-31-08 | Barcelona | 14/02/2019 |
BORME-A-2015-223-08 | Barcelona | 23/11/2015 |
BORME-A-2014-45-08 | Barcelona | 06/03/2014 |
BORME-A-2013-216-08 | Barcelona | 12/11/2013 |
BORME-A-2013-204-08 | Barcelona | 24/10/2013 |
BORME-A-2013-153-08 | Barcelona | 13/08/2013 |
BORME-A-2013-144-08 | Barcelona | 31/07/2013 |
BORME-A-2013-37-08 | Barcelona | 22/02/2013 |
BORME-A-2012-150-08 | Barcelona | 07/08/2012 |
BORME-A-2011-157-08 | Barcelona | 18/08/2011 |
BORME-A-2011-117-08 | Barcelona | 20/06/2011 |
BORME-A-2010-133-08 | Barcelona | 14/07/2010 |
BORME-A-2010-32-08 | Barcelona | 17/02/2010 |
BORME-A-2009-118-08 | Barcelona | 25/06/2009 |
BORME-A-2009-103-08 | Barcelona | 03/06/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades