Última actualización: 11 de Abril de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 11 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B85378362 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Paseo De La Castellana 259 B (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Whittaker Paul Frederick Garry | 13/02/2017 | 11/04/2018 |
Cons.Del.Sol | Whittaker Paul Frederick Garry | 13/02/2017 | 11/04/2018 |
Apo.Sol. | Whittaker Paul Frederick Garry | 13/02/2017 | 11/04/2018 |
Consejero | Verrion Robert Edward | 03/01/2011 | 11/04/2018 |
Con.Delegado | Verrion Robert Edward | 24/11/2015 | 11/04/2018 |
Apoderado | Verrion Robert Edward | 24/11/2015 | 11/04/2018 |
Apo.Sol. | Verrion Robert Edward | 30/06/2011 | 11/04/2018 |
Apo.Sol. | Pricewaterhousecoopers Compliance Services SL | 30/06/2011 | 11/04/2018 |
Liquidador | Petrie Adam | 11/04/2018 | 11/04/2018 |
Consejero | Petrie Adam | 16/07/2014 | 11/04/2018 |
VsecrNoConsj | Molina Lopez Maria De Los Milagros | 29/06/2011 | 11/04/2018 |
SecreNoConsj | Lavilla Pons Jacobo | 15/12/2017 | 11/04/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 24/11/2015 | 11/04/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 04/03/2009 | 11/04/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 30/01/2014 | 11/04/2018 |
Presidente | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier | 16/07/2014 | 11/04/2018 |
Consejero | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier | 16/07/2014 | 11/04/2018 |
Con.Delegado | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier | 24/11/2015 | 11/04/2018 |
Apoderado | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier | 24/11/2015 | 11/04/2018 |
Apo.Man.Soli | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier | 16/07/2014 | 11/04/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Global Matafion SL.
11
Abr 2018
Con fecha 11/04/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 28981 , F 57, S 8, H M 460743, I/A 34
11
Abr 2018
Con fecha 11/04/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 28981 , F 57, S 8, H M 460743, I/A 34
11
Abr 2018
Con fecha 11/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Petrie Adam |
Datos registrales: T 28981 , F 57, S 8, H M 460743, I/A 34
11
Abr 2018
Con fecha 11/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Whittaker Paul Frederick Garry |
Con.Delegado | Verrion Robert Edward |
Consejero | Petrie Adam |
VsecrNoConsj | Molina Lopez Maria De Los Milagros |
SecreNoConsj | Lavilla Pons Jacobo |
Presidente | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier |
Datos registrales: T 28981 , F 57, S 8, H M 460743, I/A 34
15
Dic 2017
Con fecha 15/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Lavilla Pons Jacobo |
Datos registrales: T 28981 , F 57, S 8, H M 460743, I/A 33
15
Dic 2017
Con fecha 15/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Millan Cruz Maria Del Carmen |
Datos registrales: T 28981 , F 57, S 8, H M 460743, I/A 33
13
Jul 2017
Con fecha 13/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes cancelaciones de oficio de nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Global Matafion SL |
Datos registrales: T 28006 , F 115, S 8, H M 53046, I/A 1170
17
May 2017
Con fecha 17/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Ellis Simon |
Datos registrales: T 28981 , F 57, S 8, H M 460743, I/A 32
04
Abr 2017
Con fecha 04/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Whittaker Paul Frederick Garry |
Consejero | Global Matafion SL |
Datos registrales: T 28006 , F 107, S 8, H M 53046, I/A 1155
13
Feb 2017
Con fecha 13/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Whittaker Paul Frederick Garry |
Datos registrales: T 28981 , F 56, S 8, H M 460743, I/A 31
13
Feb 2017
Con fecha 13/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Whittaker Paul Frederick Garry |
Datos registrales: T 28981 , F 56, S 8, H M 460743, I/A 30
13
Feb 2017
Con fecha 13/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Sol | Whittaker Paul Frederick Garry |
Datos registrales: T 28981 , F 55, S 8, H M 460743, I/A 29
13
Feb 2017
Con fecha 13/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Whittaker Paul Frederick Garry |
Datos registrales: T 28981 , F 55, S 8, H M 460743, I/A 28
12
Ene 2016
Con fecha 12/01/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 7. TRANSMISION DE PARTICIPACIONES Y CONSTITUCION DE DERECHOS REALES SOBRE LOS MISMOS.- .
Datos registrales: T 28981 , F 55, S 8, H M 460743, I/A 27
24
Nov 2015
Con fecha 24/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Verrion Robert Edward |
Apoderado | Petrie Adam |
Apoderado | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier |
Datos registrales: T 28981 , F 54, S 8, H M 460743, I/A 26
24
Nov 2015
Con fecha 24/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Verrion Robert Edward |
Con.Delegado | Petrie Adam |
Con.Delegado | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier |
Datos registrales: T 28981 , F 54, S 8, H M 460743, I/A 25
24
Nov 2015
Con fecha 24/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 28981 , F 54, S 8, H M 460743, I/A 24
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Verrion Robert Edward |
Apoderado | Petrie Adam |
Apoderado | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier |
Datos registrales: T 28981 , F 54, S 8, H M 460743, I/A 23
08
Jun 2015
Con fecha 08/06/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias AMP CAPITAL INVESTORS (CLH NO 1) SARL.
Datos registrales: T 28981 , F 53, S 8, H M 460743, I/A 22
30
Ene 2015
Con fecha 30/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Verrion Robert Edward |
Apoderado | Petrie Adam |
Apoderado | Diaz De Bustamante Y Terminel Francisco Javier |
Datos registrales: T 28981 , F 53, S 8, H M 460743, I/A 21
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2018-76-28 | Madrid | 19/04/2018 |
BORME-A-2017-244-28 | Madrid | 27/12/2017 |
BORME-A-2017-138-28 | Madrid | 21/07/2017 |
BORME-A-2017-97-28 | Madrid | 25/05/2017 |
BORME-A-2017-71-28 | Madrid | 12/04/2017 |
BORME-A-2017-35-28 | Madrid | 20/02/2017 |
BORME-A-2016-12-28 | Madrid | 20/01/2016 |
BORME-A-2015-232-28 | Madrid | 04/12/2015 |
BORME-A-2015-199-28 | Madrid | 19/10/2015 |
BORME-A-2015-112-28 | Madrid | 17/06/2015 |
BORME-A-2015-27-28 | Madrid | 10/02/2015 |
BORME-A-2014-139-28 | Madrid | 24/07/2014 |
BORME-A-2014-26-28 | Madrid | 07/02/2014 |
BORME-A-2012-80-28 | Madrid | 26/04/2012 |
BORME-A-2011-228-28 | Madrid | 01/12/2011 |
BORME-A-2011-132-28 | Madrid | 12/07/2011 |
BORME-A-2011-131-28 | Madrid | 11/07/2011 |
BORME-A-2011-10-28 | Madrid | 17/01/2011 |
BORME-A-2009-50-28 | Madrid | 13/03/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades