Última actualización: 19 de Diciembre de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B87249041 |
Provincia | Valencia |
Fecha de constitución | 6 de Abril de 2015 (hace 9 años) |
Domicilio | C/ Belgica 19 - Poligono Industrial Els Olivarons (Sollana). |
Objeto social | 1.- la organización y participación como soc io o accionista en sociedades y entidades dedicadas (i) al asesoramiento técnico y económico a terceros en la adquisición, arrendamiento y operación de aeronaves de cualquier tipo, mediante la realización de los estudios y gestiones pertinentes (ii). |
Capital social | 1.505.719,0 euros |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 29/12/2020 | 19/12/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/11/2021 | 19/12/2022 |
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 29/12/2020 | 19/12/2022 |
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/11/2021 | 19/12/2022 |
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 18/09/2020 | 19/12/2022 |
Presidente | Mariategui Valdes Alvaro-Rafael | 12/02/2020 | 19/12/2022 |
Consejero | Mariategui Valdes Alvaro-Rafael | 12/02/2020 | 19/12/2022 |
Apoderado | Mariategui Valdes Alvaro-Rafael | 12/02/2020 | 19/12/2022 |
Representan | Luna Millan Juan Elias | 09/03/2016 | 19/12/2022 |
Consejero | Luna Millan Abel | 09/03/2016 | 19/12/2022 |
LiqManc | Luho Inversiones SL | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
LiqManc | Luho Inversiones SL | Desconocido | 19/12/2022 |
Consejero | Luho Inversiones SL | 09/03/2016 | 19/12/2022 |
Apoderado | Gorostiza Manzano Gerardo | 09/07/2021 | 19/12/2022 |
Consejero | Garnica Arocena Ramon | 12/02/2020 | 19/12/2022 |
LiqManc | Fondo Nazca Iii F.C.R. De Regimen Simplificado | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
LiqManc | Fondo Nazca Iii F.C.R. De Regimen Simplificado | Desconocido | 19/12/2022 |
Consejero | Corredor Perez Tomas | 29/08/2016 | 19/12/2022 |
SecreNoConsj | Azor Lafarga Ana-Isabel | 09/03/2016 | 19/12/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 09/01/2017 | 25/03/2022 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Global Gazel SL.
19
Dic 2022
Con fecha 19/12/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19
19
Dic 2022
Con fecha 19/12/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19
19
Dic 2022
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados. Designado D. Juan Elias Luna Millán como persona física representante de "LUHO INVERSIONES, SL", la cual ha sido nombrada liquidadora mancomunada de "GLOBAL GAZEL SL". Designado D. Ramón Garnica Arocena, como persona física representante de "FONDO NAZCA III, FONDO DE CAPITAL RIESGO (EN LIQUIDACION)", que ha sido nombrada liquidadora mancomunada de "GLOBAL GAZEL SL".
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19
19
Dic 2022
Con fecha 19/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LiqManc | Luho Inversiones SL |
LiqManc | Fondo Nazca Iii F.C.R. De Regimen Simplificado |
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19
19
Dic 2022
Con fecha 19/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mariategui Valdes Alvaro-Rafael |
Consejero | Luna Millan Abel |
LiqManc | Luho Inversiones SL |
Consejero | Garnica Arocena Ramon |
LiqManc | Fondo Nazca Iii F.C.R. De Regimen Simplificado |
Consejero | Corredor Perez Tomas |
SecreNoConsj | Azor Lafarga Ana-Isabel |
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 19
25
Mar 2022
Con fecha 25/03/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 18
24
Nov 2021
Con fecha 24/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 10191, L 7473, F 139, S 8, H V 171652, I/A 17
09
Jul 2021
Con fecha 09/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gorostiza Manzano Gerardo |
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 16
09
Jul 2021
Con fecha 09/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez De Pablos Mario |
Apo.Man.Soli | Gorostiza Manzano Gerardo |
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 16
29
Dic 2020
Con fecha 29/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 15
18
Sep 2020
Con fecha 18/09/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 14
18
Sep 2020
Rectificada la inscripción 5ª por cuanto se omitio por error el nombramiento de auditor para el grupo consolidado a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L." para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 13
18
Sep 2020
Con fecha 18/09/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 10149, L 7431, F 24, S 8, H V 171652, I/A 13
19
Feb 2020
Con fecha 19/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez De Pablos Mario |
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 136, S 8, H V 171652, I/A 12
19
Feb 2020
Con fecha 19/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Perez Beato Bello Celia |
Apoderado | Corredor Perez Tomas |
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 136, S 8, H V 171652, I/A 12
12
Feb 2020
Se ratifica el nombramiento de Doña Ana Isabel Azor Lafarga como secretaria no consejera del consejo.
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 135, S 8, H V 171652, I/A 11
12
Feb 2020
Con fecha 12/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Mariategui Valdes Alvaro-Rafael |
Consejero | Garnica Arocena Ramon |
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 135, S 8, H V 171652, I/A 11
12
Feb 2020
Con fecha 12/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Perez Beato Bello Celia |
Presidente | Carbo Fernandez Carlos |
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 135, S 8, H V 171652, I/A 11
28
Feb 2019
Con fecha 28/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Gorostiza Manzano Gerardo |
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 133, S 8, H V 171652, I/A 10
28
Feb 2019
Con fecha 28/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gonzalez Barquero Covadonga |
Datos registrales: T 10148, L 7430, F 133, S 8, H V 171652, I/A 10
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2022-244-46 | Valencia | 27/12/2022 | |
BORME-A-2022-64-46 | Valencia | 01/04/2022 | |
BORME-A-2021-230-46 | Valencia | 01/12/2021 | |
BORME-A-2021-135-46 | Valencia | 16/07/2021 | |
BORME-A-2021-3-46 | Valencia | 07/01/2021 | |
BORME-A-2020-187-46 | Valencia | 25/09/2020 | |
BORME-A-2020-39-46 | Valencia | 26/02/2020 | |
BORME-A-2020-34-46 | Valencia | 19/02/2020 | |
BORME-A-2019-46-46 | Valencia | 07/03/2019 | |
BORME-A-2018-61-46 | Valencia | 27/03/2018 | |
BORME-A-2017-78-46 | Valencia | 25/04/2017 | |
BORME-A-2017-41-46 | Valencia | 28/02/2017 | |
BORME-A-2017-10-46 | Valencia | 16/01/2017 | |
BORME-A-2016-169-46 | Valencia | 05/09/2016 | |
BORME-A-2016-145-46 | Valencia | 01/08/2016 | |
BORME-A-2016-134-46 | Valencia | 14/07/2016 | |
BORME-A-2016-54-28 | Madrid | 18/03/2016 | |
BORME-A-2016-53-28 | Madrid | 17/03/2016 | |
BORME-A-2016-17-28 | Madrid | 27/01/2016 | |
BORME-A-2015-147-28 | Madrid | 05/08/2015 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades