Última actualización: 22 de Diciembre de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B60689692 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Av Via Augusta,15 Bl. 1,4 5,Sant Cugat Business (Sant Cugat Del Valles). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.ART265 | Jpg Gestauditing SLP | 22/12/2021 | Actualidad |
AUDIT.ART265 | Jpg Gestauditing SLP | 30/07/2021 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Krister Gullstrom | 15/02/2021 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Helena Haglund | 15/02/2021 | Actualidad |
AUDIT.ART265 | Consultoria En Gestion Innovadora SL | 07/10/2019 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Capelleras Segura Jordi | 21/05/2019 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Karl Krister Gullstrom | 28/04/2014 | Actualidad |
APODERADO | Jacek Roztoczynski | 03/04/2013 | Actualidad |
APODERADO | Ewa Joanna Polakowska | 03/04/2013 | Actualidad |
APODERADO | Enrich Corbacho Francesc | 10/04/2012 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Fernandez Fernandez Rodolfo | 19/01/2012 | Actualidad |
Auditor | Price Waterhousecoopers Auditores SL | 09/11/2010 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | Krister Gullstrom | 21/05/2019 | 04/11/2020 |
CONSEJERO | Krister Gullstrom | 21/05/2019 | 04/11/2020 |
CONSEJERO | Helena Vikstrom | 21/05/2019 | 04/11/2020 |
CONSEJERO | Francesc Enrich Corbacho | 21/05/2019 | 04/11/2020 |
SECR.NO CONS | Capelleras Segura Jordi | 05/03/2018 | 04/11/2020 |
CONSEJERO | Leendert Amersfoort | 27/11/2013 | 30/01/2019 |
PRESIDENTE | Kjell Aake Thomas Gustafsson | 27/11/2013 | 30/01/2019 |
CONSEJERO | Kjell Aake Thomas Gustafsson | 27/11/2013 | 30/01/2019 |
CONSEJERO | Enrich Corbacho Francesc | 27/11/2013 | 30/01/2019 |
SECR.NO CONS | Fernandez Cuellas Fernandez Rodolfo Alvaro | Desconocido | 05/03/2018 |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 11/12/2013 | 13/01/2017 |
CONSEJERO | Leendert Amersfoort | Desconocido | 27/11/2013 |
CONS. DELEG. | Leendert Amersfoort | Desconocido | 27/11/2013 |
PRESIDENTE | Fredrik Von Oelreich | Desconocido | 27/11/2013 |
CONSEJERO | Fredrik Von Oelreich | Desconocido | 27/11/2013 |
VICEPRESIDEN | Enrich Corbacho Francesc | Desconocido | 27/11/2013 |
CONSEJERO | Enrich Corbacho Francesc | Desconocido | 27/11/2013 |
APODERADO | Neville James Liddle | Desconocido | 07/08/2012 |
APODERADO | Dot Company Miguel | Desconocido | 07/08/2012 |
APODERADO | Bans Torres Juan | Desconocido | 07/08/2012 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Duni Iberica SL.
22
Dic 2021
Con fecha 22/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.ART265 | Jpg Gestauditing SLP |
Datos registrales: T 43347 , F 75, S 8, H B 123410, I/A 53
30
Jul 2021
Con fecha 30/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.ART265 | Jpg Gestauditing SLP |
Datos registrales: T 43347 , F 75, S 8, H B 123410, I/A 52
15
Feb 2021
Con fecha 15/02/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 11,12,11,13,15,17 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.
Datos registrales: T 43347 , F 74, S 8, H B 123410, I/A 51
15
Feb 2021
Con fecha 15/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Krister Gullstrom |
ADM.CONJUNTO | Helena Haglund |
Datos registrales: T 43347 , F 74, S 8, H B 123410, I/A 51
04
Nov 2020
Con fecha 04/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Krister Gullstrom |
CONSEJERO | Helena Vikstrom |
SECR.NO CONS | Capelleras Segura Jordi |
Datos registrales: T 43347 , F 74, S 8, H B 123410, I/A 50
04
Nov 2020
Con fecha 04/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Francesc Enrich Corbacho |
Datos registrales: T 43347 , F 74, S 8, H B 123410, I/A 49
07
Oct 2019
Con fecha 07/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.ART265 | Consultoria En Gestion Innovadora SL |
Datos registrales: T 43347 , F 73, S 8, H B 123410, I/A 48
21
May 2019
Con fecha 21/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Krister Gullstrom |
CONSEJERO | Helena Vikstrom |
CONSEJERO | Francesc Enrich Corbacho |
SECR.NO CONS | Capelleras Segura Jordi |
Datos registrales: T 43347 , F 73, S 8, H B 123410, I/A 47
30
Ene 2019
Con fecha 30/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes cancelaciones de oficio de nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Leendert Amersfoort |
PRESIDENTE | Kjell Aake Thomas Gustafsson |
CONSEJERO | Enrich Corbacho Francesc |
Datos registrales: T 43347 , F 71, S 8, H B 123410, I/A 42 N
05
Mar 2018
Con fecha 05/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Capelleras Segura Jordi |
Datos registrales: T 43347 , F 73, S 8, H B 123410, I/A 46
05
Mar 2018
Con fecha 05/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Fernandez Cuellas Fernandez Rodolfo Alvaro |
Datos registrales: T 43347 , F 73, S 8, H B 123410, I/A 46
13
Ene 2017
CONSTANCIA DEL CAMBIO DEL PRIMER APELLIDO DEL SECRETARIO NO CONSEJERO, FIGURANDO EN ADELANTE COMO DON RODOLFO- ALVARO FERNANDEZ-CUELLAS FERNANDEZ.
Datos registrales: T 43347 , F 72, S 8, H B 123410, I/A 45
13
Ene 2017
Con fecha 13/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 43347 , F 72, S 8, H B 123410, I/A 45
28
Abr 2014
Con fecha 28/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Karl Krister Gullstrom |
Datos registrales: T 43347 , F 72, S 8, H B 123410, I/A 44
11
Dic 2013
Con fecha 11/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 43347 , F 72, S 8, H B 123410, I/A 43
27
Nov 2013
Con fecha 27/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Leendert Amersfoort |
CONSEJERO | Kjell Aake Thomas Gustafsson |
CONSEJERO | Enrich Corbacho Francesc |
Datos registrales: T 43347 , F 71, S 8, H B 123410, I/A 42
27
Nov 2013
Con fecha 27/11/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Leendert Amersfoort |
CONSEJERO | Fredrik Von Oelreich |
VICEPRESIDEN | Enrich Corbacho Francesc |
Datos registrales: T 43347 , F 71, S 8, H B 123410, I/A 42
03
Abr 2013
Con fecha 03/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Ewa Joanna Polakowska |
Datos registrales: T 43347 , F 71, S 8, H B 123410, I/A 41
03
Abr 2013
Con fecha 03/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Jacek Roztoczynski |
Datos registrales: T 43347 , F 71, S 8, H B 123410, I/A 40
07
Ago 2012
Con fecha 07/08/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Trujillo Casallas Dionisio |
APODERADO | Neville James Liddle |
APODERADO | Morron Estrade Aureli |
APODERADO | Fontana Sola Carlos |
APODERADO | Dot Company Miguel |
APODERADO | Bans Torres Juan |
Datos registrales: T 42783 , F 173, S 8, H B 123410, I/A 39
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-248-08 | Barcelona | 29/12/2021 |
BORME-A-2021-151-08 | Barcelona | 09/08/2021 |
BORME-A-2021-36-08 | Barcelona | 23/02/2021 |
BORME-A-2020-221-08 | Barcelona | 17/11/2020 |
BORME-A-2019-197-08 | Barcelona | 14/10/2019 |
BORME-A-2019-100-08 | Barcelona | 29/05/2019 |
BORME-A-2019-26-08 | Barcelona | 07/02/2019 |
BORME-A-2018-51-08 | Barcelona | 13/03/2018 |
BORME-A-2017-15-08 | Barcelona | 23/01/2017 |
BORME-A-2014-87-08 | Barcelona | 09/05/2014 |
BORME-A-2013-241-08 | Barcelona | 18/12/2013 |
BORME-A-2013-232-08 | Barcelona | 04/12/2013 |
BORME-A-2013-67-08 | Barcelona | 10/04/2013 |
BORME-A-2012-159-08 | Barcelona | 21/08/2012 |
BORME-A-2012-75-08 | Barcelona | 19/04/2012 |
BORME-A-2012-22-08 | Barcelona | 01/02/2012 |
BORME-A-2011-217-08 | Barcelona | 16/11/2011 |
BORME-A-2010-221-43 | Tarragona | 18/11/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades