Última actualización: 12 de Diciembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A08185738 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Calendula 93, - Edificio D, Miniparc Iii, El So (Alcobendas). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 12/12/2023 | Actualidad |
Presidente | Christensen Torben Jessen | 02/08/2023 | Actualidad |
Consejero | Christensen Torben Jessen | 02/08/2023 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 25/10/2022 | Actualidad |
Consejero | Danfoss International A/S | 25/10/2022 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 30/11/2021 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 18/05/2021 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/02/2020 | Actualidad |
Consejero | Stahlschmidt Anders | 28/01/2020 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/01/2020 | Actualidad |
Presidente | Christensen Torben Jessen | 23/01/2020 | Actualidad |
Consejero | Christensen Torben Jessen | 23/01/2020 | Actualidad |
Representan | Stahlschmidt Anders | 21/01/2020 | Actualidad |
Consejero | Danfoss International A/S | 21/01/2020 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 05/06/2018 | Actualidad |
Apoderado | Ubieto Aquilue Ernesto | 03/05/2017 | Actualidad |
Apoderado | Nuñez Navarro Manuel | 03/05/2017 | Actualidad |
Apoderado | Jimenez Sanchez Belen | 03/05/2017 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 09/05/2016 | Actualidad |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 14/03/2014 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Presidente | Christensen Kim Kirk | 07/04/2015 | 23/01/2020 |
Consejero | Christensen Kim Kirk | 07/04/2015 | 23/01/2020 |
Apoderado | Ubieto Aquilue Ernesto | Desconocido | 03/05/2017 |
Apoderado | Ubieto Aquilue Ernesto | Desconocido | 03/05/2017 |
Apo.Sol. | Ubieto Aquilue Ernesto | 08/03/2011 | 03/05/2017 |
Apo.Sol. | Ubieto Aquilue Ernesto | 08/03/2011 | 03/05/2017 |
Apo.Manc. | Ubieto Aquilue Ernesto | 14/01/2015 | 03/05/2017 |
Apo.Man.Soli | Ubieto Aquilue Ernesto | Desconocido | 03/05/2017 |
Apo.Man.Soli | Jimenez Sanchez Belen | 14/01/2015 | 03/05/2017 |
Consejero | Gad Jens Gaarde | 23/05/2016 | 03/05/2017 |
Apoderado | Fernandez Martinez Emilio | Desconocido | 03/05/2017 |
Apoderado | Fernandez Martinez Emilio | Desconocido | 03/05/2017 |
Apoderado | Fernandez Martinez Emilio | 18/02/2010 | 03/05/2017 |
Apo.Sol. | Fernandez Martinez Emilio | 08/03/2011 | 03/05/2017 |
Apo.Sol. | Fernandez Martinez Emilio | 08/03/2011 | 03/05/2017 |
Apo.Manc. | Fernandez Martinez Emilio | 14/01/2015 | 03/05/2017 |
Apo.Man.Soli | Fernandez Martinez Emilio | 31/10/2012 | 03/05/2017 |
Consejero | Simson Peter | 11/02/2014 | 23/05/2016 |
Presidente | Staerk Kjeld | 03/05/2011 | 07/04/2015 |
Consejero | Staerk Kjeld | 03/05/2011 | 07/04/2015 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Danfoss SA.
12
Dic 2023
Con fecha 12/12/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30121 , F 211, S 8, H M 39347, I/A 107
02
Ago 2023
Con fecha 02/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Christensen Torben Jessen |
Datos registrales: T 30121 , F 211, S 8, H M 39347, I/A 106
25
Oct 2022
Con fecha 25/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Danfoss International A/S |
Datos registrales: T 30121 , F 210, S 8, H M 39347, I/A 105
25
Oct 2022
Con fecha 25/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30121 , F 210, S 8, H M 39347, I/A 104
30
Nov 2021
Con fecha 30/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30121 , F 210, S 8, H M 39347, I/A 103
18
May 2021
Con fecha 18/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30121 , F 210, S 8, H M 39347, I/A 102
02
Jul 2020
Con fecha 02/07/2020, la sociedad cambia su domicilio social a C/ CALENDULA 93, - EDIFICIO D, MINIPARC III, EL SO (ALCOBENDAS).
Datos registrales: T 30121 , F 210, S 8, H M 39347, I/A 101
24
Feb 2020
Con fecha 24/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30121 , F 209, S 8, H M 39347, I/A 100
28
Ene 2020
Con fecha 28/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Stahlschmidt Anders |
Datos registrales: T 30121 , F 209, S 8, H M 39347, I/A 99
27
Ene 2020
Con fecha 27/01/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias DANFOSS INTERNATIONAL A/S.
Datos registrales: T 30121 , F 209, S 8, H M 39347, I/A 98
24
Ene 2020
Con fecha 24/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30121 , F 209, S 8, H M 39347, I/A 97
23
Ene 2020
Con fecha 23/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Christensen Torben Jessen |
Datos registrales: T 30121 , F 208, S 8, H M 39347, I/A 96
23
Ene 2020
Con fecha 23/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Christensen Kim Kirk |
Datos registrales: T 30121 , F 208, S 8, H M 39347, I/A 96
21
Ene 2020
Con fecha 21/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Stahlschmidt Anders |
Consejero | Danfoss International A/S |
Datos registrales: T 30121 , F 208, S 8, H M 39347, I/A 95
05
Jun 2018
Con fecha 05/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30121 , F 208, S 8, H M 39347, I/A 94
19
May 2017
Sociedades absorbidas: VACON DRIVES IBERICA SA.
Datos registrales: T 30121 , F 205, S 8, H M 39347, I/A 93
03
May 2017
Con fecha 03/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Ubieto Aquilue Ernesto |
Apoderado | Nuñez Navarro Manuel |
Apoderado | Jimenez Sanchez Belen |
Datos registrales: T 30121 , F 203, S 8, H M 39347, I/A 92
03
May 2017
Con fecha 03/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Ubieto Aquilue Ernesto |
Apo.Man.Soli | Jimenez Sanchez Belen |
Apo.Manc. | Fernandez Martinez Emilio |
Datos registrales: T 30121 , F 203, S 8, H M 39347, I/A 92
03
May 2017
Con fecha 03/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Gad Jens Gaarde |
Datos registrales: T 30121 , F 203, S 8, H M 39347, I/A 92
23
May 2016
Con fecha 23/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Gad Jens Gaarde |
Datos registrales: T 30121 , F 202, S 8, H M 39347, I/A 91
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-239-28 | Madrid | 19/12/2023 | |
BORME-A-2023-151-28 | Madrid | 09/08/2023 | |
BORME-A-2022-209-28 | Madrid | 02/11/2022 | |
BORME-A-2021-234-28 | Madrid | 09/12/2021 | |
BORME-A-2021-97-28 | Madrid | 25/05/2021 | |
BORME-A-2020-131-28 | Madrid | 09/07/2020 | |
BORME-A-2020-42-28 | Madrid | 02/03/2020 | |
BORME-A-2020-23-28 | Madrid | 04/02/2020 | |
BORME-A-2020-22-28 | Madrid | 03/02/2020 | |
BORME-A-2020-21-28 | Madrid | 31/01/2020 | |
BORME-A-2020-20-28 | Madrid | 30/01/2020 | |
BORME-A-2020-18-28 | Madrid | 28/01/2020 | |
BORME-A-2018-112-28 | Madrid | 13/06/2018 | |
BORME-A-2017-99-28 | Madrid | 29/05/2017 | |
BORME-A-2017-89-28 | Madrid | 12/05/2017 | |
BORME-A-2017-86-28 | Madrid | 09/05/2017 | |
BORME-A-2016-102-28 | Madrid | 31/05/2016 | |
BORME-A-2016-93-28 | Madrid | 18/05/2016 | |
BORME-A-2015-73-28 | Madrid | 20/04/2015 | |
BORME-A-2015-14-28 | Madrid | 22/01/2015 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades