Última actualización: 21 de Julio de 2017
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 6 años, 9 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A14228324 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Cl Sant Quirze, 4-18 (Sabadell). |
Capital social | 38.280.578,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Villodres Nebot David | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APODERAD.SOL | Ruiz-Rico Nieto Jose Antonio | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Royo Uño Raimon | 15/04/2016 | 21/07/2017 |
APODERAD.SOL | Monterde Molina Nuria | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Mendoza Olalla Mariano Miguel | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Martinez Martinez Francisco | 15/04/2016 | 21/07/2017 |
APODERAD.SOL | Macias Amador Jose Carlos | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Lopez Silvente Francisco Jose | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Lopez Gallego Antonio | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Gomez Cambronero De La Maza Rafael | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Gimeno Coma Xavier | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Gilabert Fernandez Jordi | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
Cons.Del.Sol | Gescat Llevant SL | 30/07/2010 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Franch Vilella Joan | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Duran Herrera Carlos | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
Apo.Man.Soli | Castella Morraja Josep Maria | 30/07/2010 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Carbonell Maojo Ricard | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Capdevila Rotano Luis Pastor | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
APOD.SOL/MAN | Boldu Selles Xavier | 08/05/2015 | 21/07/2017 |
REPR.143 RRM | Aguado Rodriguez Esteban | 21/07/2017 | 21/07/2017 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Corporacion Betica Inmobiliaria SA.
21
Jul 2017
Con fecha 21/07/2017 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 45427 , F 225, S 8, H B 401054, I/A 42
21
Jul 2017
Con fecha 21/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
REPR.143 RRM | Aguado Rodriguez Esteban |
Datos registrales: T 45427 , F 225, S 8, H B 401054, I/A 42
21
Jul 2017
Con fecha 21/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Puigdesens Sañe Jose |
LIQUIDADOR | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
ADM.CONJUNTO | Castilla Bayod Lorenzo |
REPR.143 RRM | Aguado Rodriguez Esteban |
Datos registrales: T 45427 , F 225, S 8, H B 401054, I/A 42
17
Feb 2017
Con fecha 17/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Puigdesens Sañe Jose |
ADM.CONJUNTO | Castilla Bayod Lorenzo |
Datos registrales: T 45427 , F 225, S 8, H B 401054, I/A 41
17
Feb 2017
Con fecha 17/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Royo Uño Raimon |
ADM.CONJUNTO | Fina Casanova Josep Jaume |
Datos registrales: T 45427 , F 225, S 8, H B 401054, I/A 41
26
Oct 2016
Con fecha 26/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Hernandez Melero Estefania |
Datos registrales: T 45427 , F 225, S 8, H B 401054, I/A 40
26
Oct 2016
Con fecha 26/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Puigdesens Sañe Josep |
Datos registrales: T 45427 , F 223, S 8, H B 401054, I/A 39
26
Oct 2016
Con fecha 26/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Castilla Bayod Lorenzo-Jose |
Datos registrales: T 45427 , F 221, S 8, H B 401054, I/A 38
23
Ago 2016
Con fecha 23/08/2016, la sociedad cambia su domicilio social a CL SANT QUIRZE, 4-18 (SABADELL).
Datos registrales: T 44792 , F 140, S 8, H B 401054, I/A 37
28
Jun 2016
Con fecha 28/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Vilela Rodrigo Veronica |
APOD.SOL/MAN | Vila Tarrago Josep |
APOD.SOL/MAN | Vert Miro Iban |
APOD.SOL/MAN | Tarrega Roberto Francisco Jose |
APOD.SOL/MAN | Riera Canchal Joaquim |
APOD.SOL/MAN | Parejo Vico Enric |
APOD.SOL/MAN | Panicello Prime Josep Maria |
APOD.SOL/MAN | Ortiz De Galisteo Lara Lidia |
APOD.SOL/MAN | Llorente Martinez Pascual |
APOD.SOL/MAN | Jeniu Blanes Joan Francesc |
APOD.SOL/MAN | Guerrero Rodriguez Juan Carlos |
APOD.SOL/MAN | Gimenez Ferre Pere |
APOD.SOL/MAN | Beltran Reverter Ana |
Datos registrales: T 44792 , F 140, S 8, H B 401054, I/A 36
15
Abr 2016
Con fecha 15/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Royo Uño Raimon |
APOD.SOL/MAN | Riveiro Lopez Niño Alfonso |
APODERAD.SOL | Pons Domingo Cinta |
APODERAD.SOL | Parejo Vico Enric |
APODERAD.SOL | Ortiz De Galisteo Lara Lidia |
APODERAD.SOL | Merchan Bravo Josep Anton |
APOD.SOL/MAN | Martinez Martinez Francisco |
APODERAD.SOL | Huguet Berengue Albert |
APODERAD.SOL | Gimenez Ferre Pere |
APOD.SOL/MAN | Fina Casanova Josep Jaume |
Datos registrales: T 44792 , F 137, S 8, H B 401054, I/A 35
08
Abr 2016
Con fecha 08/04/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7,8,9 Y 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.
Datos registrales: T 44792 , F 136, S 8, H B 401054, I/A 34
08
Abr 2016
Con fecha 08/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Royo Uño Raimon |
ADM.CONJUNTO | Fina Casanova Josep Jaume |
Datos registrales: T 44792 , F 136, S 8, H B 401054, I/A 34
08
Abr 2016
Con fecha 08/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Vila Tarrago Josep |
REPR.143 RRM | Tarrega Roberto Francisco Jose |
CONSEJERO | Saticem Immobiliaria SL |
REPR.143 RRM | Riera Canchal Joaquim |
CONSEJERO | Inpau SA |
PRESIDENTE | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
Datos registrales: T 44792 , F 136, S 8, H B 401054, I/A 34
08
May 2015
Con fecha 08/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Datos registrales: T 42132 , F 49, S 8, H B 401054, I/A 33
08
May 2015
Con fecha 08/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 42132 , F 49, S 8, H B 401054, I/A 33
16
Ene 2015
Con fecha 16/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Vilela Rodrigo Veronica |
APOD.SOL/MAN | Vila Tarrago Josep |
APOD.SOL/MAN | Vert Miro Iban |
APOD.SOL/MAN | Tarrega Roberto Francisco Jose |
APOD.SOL/MAN | Riera Canchal Joaquim |
APOD.SOL/MAN | Parejo Vico Enric |
APOD.SOL/MAN | Panicello Prime Josep Maria |
APOD.SOL/MAN | Ortiz De Galisteo Lara Lidia |
APOD.SOL/MAN | Llorente Martinez Pascual |
APOD.SOL/MAN | Jeniu Blanes Joan Francesc |
APOD.SOL/MAN | Guerrero Rodriguez Juan Carlos |
APOD.SOL/MAN | Gimenez Ferre Pere |
APOD.SOL/MAN | Beltran Reverter Ana |
Datos registrales: T 42132 , F 45, S 8, H B 401054, I/A 32
19
Sep 2014
Con fecha 19/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Vila Tarrago Josep |
REPR.143 RRM | Tarrega Roberto Francisco Jose |
REPR.143 RRM | Riera Canchal Joaquim |
SECRETARIO | Inpau SA |
Datos registrales: T 42132 , F 44, S 8, H B 401054, I/A 31
19
Sep 2014
Con fecha 19/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
SECR.NO CONS | Lopez Gallego Antonio |
REPR.143 RRM | Larramona Mora Daniel |
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger |
Datos registrales: T 42132 , F 44, S 8, H B 401054, I/A 31
10
May 2013
Con fecha 10/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Plana Farin Alejandro |
APODERADO | Ortiz Torinos Ainara |
APODERADO | Juriasti Balenciaga Maria Jesus |
APODERADO | Fenoy Palomas Ramon |
APODERADO | Comella Carnice Adria |
APODERADO | Bueno Lorenzo Sergio |
Datos registrales: T 42132 , F 44, S 8, H B 401054, I/A 30
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2017-144-08 | Barcelona | 31/07/2017 |
BORME-A-2017-40-08 | Barcelona | 27/02/2017 |
BORME-A-2016-211-08 | Barcelona | 04/11/2016 |
BORME-A-2016-167-08 | Barcelona | 01/09/2016 |
BORME-A-2016-129-08 | Barcelona | 07/07/2016 |
BORME-A-2016-78-08 | Barcelona | 25/04/2016 |
BORME-A-2016-73-08 | Barcelona | 18/04/2016 |
BORME-A-2015-93-08 | Barcelona | 20/05/2015 |
BORME-A-2015-15-08 | Barcelona | 23/01/2015 |
BORME-A-2014-187-08 | Barcelona | 01/10/2014 |
BORME-A-2013-92-08 | Barcelona | 20/05/2013 |
BORME-A-2013-40-08 | Barcelona | 27/02/2013 |
BORME-A-2012-135-08 | Barcelona | 17/07/2012 |
BORME-A-2012-131-08 | Barcelona | 11/07/2012 |
BORME-A-2012-70-08 | Barcelona | 12/04/2012 |
BORME-A-2011-25-08 | Barcelona | 07/02/2011 |
BORME-A-2011-3-08 | Barcelona | 05/01/2011 |
BORME-A-2010-198-08 | Barcelona | 14/10/2010 |
BORME-A-2010-152-14 | Córdoba | 10/08/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades