Última actualización: 2 de Noviembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B79203451 |
Denominación anterior | Corning Cable Systems SL |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Gabriel Garcia Marquez 4 - 1ª Planta (Rozas De Madrid (Las)). |
Capital social | 1.000.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 02/11/2023 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 06/07/2023 | Actualidad |
Secretario | Pindado Rodriguez Oscar | 06/07/2023 | Actualidad |
Consejero | Pindado Rodriguez Oscar | 06/07/2023 | Actualidad |
Presidente | Lopes Gouveia Roberto | 06/07/2023 | Actualidad |
Consejero | Lopes Gouveia Roberto | 06/07/2023 | Actualidad |
Consejero | Huillet Philippe Michel | 06/07/2023 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 05/07/2023 | Actualidad |
Consejero | Leonard Timothy Daniel | 02/03/2021 | Actualidad |
Apoderado | Vida Robert | 27/11/2020 | Actualidad |
Apoderado | Szabo Zsuzsanna | 27/11/2020 | Actualidad |
Apoderado | Signlovics Zsofia | 27/11/2020 | Actualidad |
Apoderado | Lopes Gouveia Roberto | 27/11/2020 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 26/11/2020 | Actualidad |
Presidente | Lopes Gouveia Roberto | 26/11/2020 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 15/11/2019 | Actualidad |
Presidente | Trebels Stefan Bert Josef Gunter | 18/01/2019 | Actualidad |
Consejero | Trebels Stefan Bert Josef Gunter | 18/01/2019 | Actualidad |
Secretario | Pindado Rodriguez Oscar | 18/01/2019 | Actualidad |
Consejero | Pindado Rodriguez Oscar | 18/01/2019 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Leonard Timothy Daniel | 10/01/2017 | 06/07/2023 |
Consejero | Kutylowski Przemyslaw | 27/11/2020 | 02/03/2021 |
Apoderado | Vegh Kristof | 19/12/2016 | 27/11/2020 |
Consejero | Trebels Stefan Bert Josef Gunter | 12/01/2015 | 27/11/2020 |
Apoderado | Trebels Stefan Bert Josef Gunter | 07/12/2016 | 27/11/2020 |
Apo.Manc. | Trebels Stefan Bert Josef Gunter | 06/09/2011 | 27/11/2020 |
Apo.Manc. | Trbovic Gillian | 17/12/2013 | 27/11/2020 |
Apo.Manc. | Szucs Attila | 24/10/2017 | 27/11/2020 |
Apoderado | Szabo Klaudia | 19/12/2016 | 27/11/2020 |
Apoderado | Mehlhorn Maxi | 11/01/2013 | 27/11/2020 |
Apoderado | Hamer Chris | 11/01/2013 | 27/11/2020 |
Presidente | Trebels Stefan Bert Josef Gunter | 07/12/2016 | 26/11/2020 |
Apoderado | Montoya Tolon Ana | 11/01/2013 | 26/11/2020 |
Apoderado | Garcia Petisco Rocio | 11/01/2013 | 26/11/2020 |
Apoderado | Carreño Alvarez Irene | 11/01/2013 | 26/11/2020 |
Apo.Manc. | Singlovics Zsofia | 17/12/2013 | 24/10/2017 |
Apoderado | Mihalszky Zsolt | 04/02/2015 | 24/10/2017 |
Apo.Manc. | Elvinsson Bengt | 06/09/2011 | 24/10/2017 |
Consejero | Elvinsson Bengt | 12/01/2015 | 26/09/2017 |
Consejero | Echahamian Claude | 11/01/2013 | 11/02/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Corning Optical Communications SL.
02
Nov 2023
Con fecha 02/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 36235 , F 186, S 8, H M 19502, I/A 168
06
Jul 2023
Con fecha 06/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Pindado Rodriguez Oscar |
Datos registrales: T 36235 , F 186, S 8, H M 19502, I/A 167
06
Jul 2023
Con fecha 06/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Lopes Gouveia Roberto |
Datos registrales: T 36235 , F 185, S 8, H M 19502, I/A 166
06
Jul 2023
Con fecha 06/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Huillet Philippe Michel |
Datos registrales: T 36235 , F 185, S 8, H M 19502, I/A 165
06
Jul 2023
Con fecha 06/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Leonard Timothy Daniel |
Datos registrales: T 36235 , F 185, S 8, H M 19502, I/A 165
06
Jul 2023
Con fecha 06/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 36235 , F 185, S 8, H M 19502, I/A 164
05
Jul 2023
Con fecha 05/07/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 36235 , F 185, S 8, H M 19502, I/A 163
28
Sep 2021
DON JORGE RIUS GARRETA RENUNCIA AL PODER CONFERIDO A SU FAVOR EN LA INSCRIPCION 134ª DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 36235 , F 184, S 8, H M 19502, I/A 162
21
Sep 2021
DOÑA MARIA EUGENIA RUBIO RODRIGUEZ VIGIL RENUNCIA AL PODER QUE LE FUE CONFERIDO MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 134ª.
Datos registrales: T 36235 , F 184, S 8, H M 19502, I/A 161
02
Mar 2021
Con fecha 02/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Leonard Timothy Daniel |
Datos registrales: T 36235 , F 184, S 8, H M 19502, I/A 160
02
Mar 2021
Con fecha 02/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Kutylowski Przemyslaw |
Datos registrales: T 36235 , F 184, S 8, H M 19502, I/A 160
27
Nov 2020
Con fecha 27/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Kutylowski Przemyslaw |
Datos registrales: T 36235 , F 184, S 8, H M 19502, I/A 159
27
Nov 2020
Con fecha 27/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Trebels Stefan Bert Josef Gunter |
Datos registrales: T 36235 , F 184, S 8, H M 19502, I/A 159
27
Nov 2020
Con fecha 27/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vida Robert |
Apoderado | Szabo Zsuzsanna |
Apoderado | Signlovics Zsofia |
Apoderado | Lopes Gouveia Roberto |
Datos registrales: T 36235 , F 183, S 8, H M 19502, I/A 158
27
Nov 2020
Con fecha 27/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vegh Kristof |
Apo.Manc. | Trebels Stefan Bert Josef Gunter |
Apo.Manc. | Trbovic Gillian |
Apo.Manc. | Szucs Attila |
Apoderado | Szabo Klaudia |
Apoderado | Mehlhorn Maxi |
Apoderado | Hamer Chris |
Datos registrales: T 36235 , F 183, S 8, H M 19502, I/A 158
26
Nov 2020
Con fecha 26/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Lopes Gouveia Roberto |
Datos registrales: T 36235 , F 182, S 8, H M 19502, I/A 157
26
Nov 2020
Con fecha 26/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Montoya Tolon Ana |
Apoderado | Garcia Petisco Rocio |
Apoderado | Carreño Alvarez Irene |
Datos registrales: T 36235 , F 182, S 8, H M 19502, I/A 157
26
Nov 2020
Con fecha 26/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Trebels Stefan Bert Josef Gunter |
Datos registrales: T 36235 , F 182, S 8, H M 19502, I/A 157
26
Nov 2020
Con fecha 26/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 36235 , F 182, S 8, H M 19502, I/A 156
18
Nov 2019
Con fecha 18/11/2019, la sociedad cambia su domicilio social a C/ GABRIEL GARCIA MARQUEZ 4 - 1ª PLANTA (ROZAS DE MADRID (LAS)).
Datos registrales: T 36235 , F 182, S 8, H M 19502, I/A 155
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-214-28 | Madrid | 10/11/2023 | |
BORME-A-2023-132-28 | Madrid | 13/07/2023 | |
BORME-A-2023-131-28 | Madrid | 12/07/2023 | |
BORME-A-2021-192-28 | Madrid | 05/10/2021 | |
BORME-A-2021-187-28 | Madrid | 28/09/2021 | |
BORME-A-2021-46-28 | Madrid | 09/03/2021 | |
BORME-A-2020-234-28 | Madrid | 04/12/2020 | |
BORME-A-2020-233-28 | Madrid | 03/12/2020 | |
BORME-A-2019-226-28 | Madrid | 25/11/2019 | |
BORME-A-2019-225-28 | Madrid | 22/11/2019 | |
BORME-A-2019-18-28 | Madrid | 28/01/2019 | |
BORME-A-2018-86-28 | Madrid | 07/05/2018 | |
BORME-A-2018-60-28 | Madrid | 26/03/2018 | |
BORME-A-2017-209-28 | Madrid | 02/11/2017 | |
BORME-A-2017-190-28 | Madrid | 04/10/2017 | |
BORME-A-2017-12-28 | Madrid | 18/01/2017 | |
BORME-A-2016-244-28 | Madrid | 27/12/2016 | |
BORME-A-2016-237-28 | Madrid | 15/12/2016 | |
BORME-A-2016-34-28 | Madrid | 19/02/2016 | |
BORME-A-2016-9-28 | Madrid | 15/01/2016 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades