Última actualización: 28 de Noviembre de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 4 años, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A08309114 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Gobelas 29 (Madrid). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Vega Gallego Maria Dolores | 25/02/2015 | 28/11/2019 |
Apoderado | Suarez Gonzalez Isidro | 13/06/2014 | 28/11/2019 |
Apo.Man.Soli | Suarez Gonzalez Isidro | 16/05/2012 | 28/11/2019 |
Apoderado | Sanchez Diaz Maria Belen | 13/06/2014 | 28/11/2019 |
Apo.Sol. | Salazar Roman Antonio Miguel | 05/03/2015 | 28/11/2019 |
Apo.Manc. | Salazar Roman Antonio Miguel | 05/03/2015 | 28/11/2019 |
Apo.Sol. | Perez Sancho Juan Ramon | 23/09/2016 | 28/11/2019 |
Apo.Sol. | Murciano Rosado Manuel Jesus | 23/09/2016 | 28/11/2019 |
Apo.Manc. | Murciano Rosado Manuel Jesus | 05/03/2015 | 28/11/2019 |
Apoderado | Mimbrero Gonzalez Marisa | 16/04/2010 | 28/11/2019 |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 15/01/2018 | 28/11/2019 |
Apoderado | Del Valle Iñiguez Begoña | 13/06/2014 | 28/11/2019 |
Apoderado | De La Hoz Nombela Francisco | 13/06/2014 | 28/11/2019 |
Adm. Unico | Daval Control SL | 21/05/2018 | 28/11/2019 |
Apoderado | Bilbao Rey Jose Luis | 13/06/2014 | 28/11/2019 |
Apoderado | Arroyo Souto Manuel | 13/06/2014 | 28/11/2019 |
Apo.Sol. | Arroyo Souto Manuel | 04/03/2019 | 28/11/2019 |
Apo.Sol. | Alvarez Rodriguez Marcelino | 12/05/2015 | 28/11/2019 |
Apo.Sol. | Alvarez Rodriguez Marcelino | 23/09/2016 | 28/11/2019 |
Representan | Alvarez Mezquiriz Maria Jose | 13/06/2013 | 28/11/2019 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Codelco Mercantil SA.
28
Nov 2019
Con fecha 28/11/2019 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 32007 , F 225, S 8, H M 381079, I/A 81
05
Nov 2019
A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 231 DEL RRM Y EN RELACION A LA SOCIEDAD " CODELCO MERCANTIL SA " , SE HACE CONSTAR LA INEXISTENCIA DE OBSTACULO REGISTRAL PARA LA INSCRIPCION DE LA ABSORCION DE LA MISMA POR LA ENTIDAD DOMICILIADA EN BILBAO DENOMINADA "EULEN SA ".-
Datos registrales: T 32007 , F 225, S 8, H M 381079, I/A 80M
04
Abr 2019
Con fecha 04/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 32007 , F 225, S 8, H M 381079, I/A 80
04
Mar 2019
Con fecha 04/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Arroyo Souto Manuel |
Datos registrales: T 32007 , F 224, S 8, H M 381079, I/A 79
31
Oct 2018
Con fecha 31/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Collar Soteres Elena |
Datos registrales: T 32007 , F 224, S 8, H M 381079, I/A 78
27
Jun 2018
Con fecha 27/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Martinez Sanchez Salvador |
Datos registrales: T 32007 , F 223, S 8, H M 381079, I/A 77
21
May 2018
Con fecha 21/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Daval Control SL |
Representan | Alvarez Mezquiriz Maria Jose |
Datos registrales: T 32007 , F 223, S 8, H M 381079, I/A 76
23
Feb 2018
Con fecha 23/02/2018, la sociedad cambia su domicilio social a C/ GOBELAS 29 (MADRID).
Datos registrales: T 32007 , F 223, S 8, H M 381079, I/A 75
15
Ene 2018
Con fecha 15/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 32007 , F 223, S 8, H M 381079, I/A 74
05
Ene 2018
Con fecha 05/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Cavero Catalan Oscar |
Datos registrales: T 32007 , F 222, S 8, H M 381079, I/A 73
05
Ene 2018
Queda revocado el poder conferido a DON JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ que causó la inscripción 1ª en la hoja social del Registro Mercantil de Madrid.
Datos registrales: T 32007 , F 222, S 8, H M 381079, I/A 72
23
Ene 2017
Con fecha 23/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 32007 , F 221, S 8, H M 381079, I/A 71
29
Sep 2016
Con fecha 29/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Alonso Fernandez Ismael |
Datos registrales: T 32007 , F 221, S 8, H M 381079, I/A 70
23
Sep 2016
Con fecha 23/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Salazar Roman Antonio Miguel |
Apo.Sol. | Perez Sancho Juan Ramon |
Apo.Sol. | Murciano Rosado Manuel Jesus |
Apo.Sol. | Garcia Martin Juan |
Apo.Sol. | Alvarez Rodriguez Marcelino |
Datos registrales: T 32007 , F 221, S 8, H M 381079, I/A 69
04
Mar 2016
Con fecha 04/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Alvarez Mezquiriz Maria Jose |
Datos registrales: T 32007 , F 220, S 8, H M 381079, I/A 68
04
Mar 2016
Con fecha 04/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Carrero Antin Santiago |
Datos registrales: T 32007 , F 220, S 8, H M 381079, I/A 67
03
Mar 2016
Con fecha 03/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Alvarez Mezquiriz Jesus David |
Datos registrales: T 32007 , F 220, S 8, H M 381079, I/A 66
09
Feb 2016
Con fecha 09/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 32007 , F 220, S 8, H M 381079, I/A 65
03
Nov 2015
DON PEDRO PARES RON RENUNCIA A LOS PODERES QUE LE FUERON CONFERIDOS MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 45& DE LA HOJA ABIERTA A LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA.
Datos registrales: T 32007 , F 220, S 8, H M 381079, I/A 64
27
Ago 2015
Con fecha 27/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Yañez Sebastian Mabel-Monica |
Datos registrales: T 32007 , F 218, S 8, H M 381079, I/A 63
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2019-234-28 | Madrid | 05/12/2019 | |
BORME-A-2019-217-28 | Madrid | 12/11/2019 | |
BORME-A-2019-71-28 | Madrid | 11/04/2019 | |
BORME-A-2019-48-28 | Madrid | 11/03/2019 | |
BORME-A-2018-215-28 | Madrid | 08/11/2018 | |
BORME-A-2018-127-28 | Madrid | 04/07/2018 | |
BORME-A-2018-100-28 | Madrid | 28/05/2018 | |
BORME-A-2018-48-28 | Madrid | 08/03/2018 | |
BORME-A-2018-17-28 | Madrid | 24/01/2018 | |
BORME-A-2018-10-28 | Madrid | 15/01/2018 | |
BORME-A-2017-21-28 | Madrid | 31/01/2017 | |
BORME-A-2016-193-28 | Madrid | 07/10/2016 | |
BORME-A-2016-188-28 | Madrid | 30/09/2016 | |
BORME-A-2016-50-28 | Madrid | 14/03/2016 | |
BORME-A-2016-48-28 | Madrid | 10/03/2016 | |
BORME-A-2016-33-28 | Madrid | 18/02/2016 | |
BORME-A-2015-216-28 | Madrid | 12/11/2015 | |
BORME-A-2015-171-28 | Madrid | 08/09/2015 | |
BORME-A-2015-149-28 | Madrid | 07/08/2015 | |
BORME-A-2015-139-28 | Madrid | 24/07/2015 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades