Última actualización: 27 de Febrero de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 1 mes |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B62760913 |
Provincia | Barcelona |
Motivo de la disolución | Judicial. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERADO | Sanclimens Genesca Josep Maria | 30/11/2009 | 27/02/2019 |
ADM.CONCURS. | Roig Farran Trinidad | 12/02/2014 | 27/02/2019 |
APODERADO | Plana Farin Alejandro | 26/07/2012 | 27/02/2019 |
APODERADO | Perez Rovira Jorge | 26/07/2012 | 27/02/2019 |
PRESIDENTE | Sanclimens Genesca Jose Maria | Desconocido | 01/12/2015 |
CONSEJERO | Sanclimens Genesca Jose Maria | Desconocido | 01/12/2015 |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge | 26/07/2012 | 01/12/2015 |
SECR.NO CONS | Lopez Gallego Antonio | 26/07/2012 | 01/12/2015 |
CONSEJERO | Copcisa SA | 26/07/2012 | 01/12/2015 |
CONSEJERO | Catalunyacaixa Immobiliaria SA | 26/07/2012 | 01/12/2015 |
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger | 18/02/2013 | 01/12/2015 |
REPR.143 RRM | Carbonell Marcet Benito | 26/07/2012 | 01/12/2015 |
CONSEJERO | Activos Macorp SL | 26/07/2012 | 01/12/2015 |
REPR.143 RRM | Gallart Sulla Eduard | 26/07/2012 | 18/02/2013 |
SECR.NO CONS | Riveiro Lopez Niño Alfonso | 30/11/2009 | 26/07/2012 |
CONSEJERO | Reyner Serra Josep | 30/11/2009 | 26/07/2012 |
CONSEJERO | Carbonell Marcet Benito | Desconocido | 26/07/2012 |
APODERADO | Bordas Bernat Luis | 30/11/2009 | 26/07/2012 |
CONSEJERO | Bordas Bernat Lluis | Desconocido | 26/07/2012 |
APODERADO | Balaña Parra Jordi | 30/11/2009 | 26/07/2012 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Capasatus SL.
27
Feb 2019
Con fecha 27/02/2019 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 43293 , F 175, S 8, H B 244851, I/A 13
27
Feb 2019
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 680/2013, AUTO FIRME DE FECHA 14/12/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43293 , F 175, S 8, H B 244851, I/A 13
27
Feb 2019
Con fecha 27/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Roig Farran Trinidad |
Datos registrales: T 43293 , F 175, S 8, H B 244851, I/A 13
15
Feb 2016
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 680/2013, AUTO FIRME DE FECHA 15/01/2016, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43293 , F 175, S 8, H B 244851, I/A 12
01
Dic 2015
Con fecha 01/12/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Judicial.
Datos registrales: T 43293 , F 173, S 8, H B 244851, I/A 11
01
Dic 2015
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 680/2013, RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 27/04/2015 Y 13/07/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43293 , F 173, S 8, H B 244851, I/A 11
01
Dic 2015
Con fecha 01/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
PRESIDENTE | Sanclimens Genesca Jose Maria |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
SECR.NO CONS | Lopez Gallego Antonio |
CONSEJERO | Copcisa SA |
CONSEJERO | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger |
REPR.143 RRM | Carbonell Marcet Benito |
CONSEJERO | Activos Macorp SL |
Datos registrales: T 43293 , F 173, S 8, H B 244851, I/A 11
12
Feb 2014
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 680/2013, AUTO FIRME DE FECHA 05/11/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43293 , F 172, S 8, H B 244851, I/A 10
12
Feb 2014
Con fecha 12/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Roig Farran Trinidad |
Datos registrales: T 43293 , F 172, S 8, H B 244851, I/A 10
18
Feb 2013
Con fecha 18/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger |
Datos registrales: T 43293 , F 171, S 8, H B 244851, I/A 9
18
Feb 2013
Con fecha 18/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Gallart Sulla Eduard |
Datos registrales: T 43293 , F 171, S 8, H B 244851, I/A 9
26
Jul 2012
Con fecha 26/07/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Plana Farin Alejandro |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
SECR.NO CONS | Lopez Gallego Antonio |
REPR.143 RRM | Gallart Sulla Eduard |
CONSEJERO | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
CONSEJERO | Activos Macorp SL |
Datos registrales: T 43293 , F 171, S 8, H B 244851, I/A 8
26
Jul 2012
Con fecha 26/07/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Riveiro Lopez Niño Alfonso |
CONSEJERO | Reyner Serra Josep |
APODERADO | Bordas Bernat Luis |
CONSEJERO | Bordas Bernat Lluis |
APODERADO | Balaña Parra Jordi |
Datos registrales: T 43293 , F 171, S 8, H B 244851, I/A 8
26
Jul 2012
Con fecha 26/07/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Copcisa SA |
REPR.143 RRM | Carbonell Marcet Benito |
Datos registrales: T 34203 , F 42, S 8, H B 244851, I/A 7
26
Jul 2012
Con fecha 26/07/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Carbonell Marcet Benito |
Datos registrales: T 34203 , F 42, S 8, H B 244851, I/A 7
30
Nov 2009
Con fecha 30/11/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Riveiro Lopez Niño Alfonso |
CONSEJERO | Reyner Serra Josep |
Datos registrales: T 34203 , F 40, S 8, H B 244851, I/A 5
30
Nov 2009
Con fecha 30/11/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Navarro Climent Josep |
Datos registrales: T 34203 , F 40, S 8, H B 244851, I/A 5
30
Nov 2009
Con fecha 30/11/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Sanclimens Genesca Josep Maria |
APODERADO | Bordas Bernat Luis |
APODERADO | Balaña Parra Jordi |
Datos registrales: T 34203 , F 41, S 8, H B 244851, I/A 6
30
Nov 2009
Con fecha 30/11/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Sanclimens Genesca Jose Maria |
Datos registrales: T 34203 , F 41, S 8, H B 244851, I/A 6
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2019-45-08 | Barcelona | 06/03/2019 |
BORME-A-2016-35-08 | Barcelona | 22/02/2016 |
BORME-A-2015-236-08 | Barcelona | 11/12/2015 |
BORME-A-2014-35-08 | Barcelona | 20/02/2014 |
BORME-A-2013-39-08 | Barcelona | 26/02/2013 |
BORME-A-2012-151-08 | Barcelona | 08/08/2012 |
BORME-A-2012-150-08 | Barcelona | 07/08/2012 |
BORME-A-2009-236-08 | Barcelona | 11/12/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades