Última actualización: 28 de Junio de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 7 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B82697640 |
Denominación anterior | Sumig Europartes Iberica SL |
Provincia | Madrid |
Capital social | 4.800.000,0 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Mehnert Jascha Henrik | 02/08/2019 | 28/06/2023 |
Apoderado | Mehnert Jascha Henrik | 18/02/2020 | 28/06/2023 |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 19/10/2020 | 03/10/2022 |
Adm. Solid. | Pfeiffer Friedrich Michael | 20/09/2018 | 08/02/2021 |
Auditor | Bdo Auditores SLP | 28/12/2010 | 24/07/2020 |
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel | 29/10/2018 | 18/02/2020 |
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel | 02/08/2019 | 18/02/2020 |
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel | 02/08/2019 | 18/02/2020 |
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel | 23/02/2017 | 29/10/2018 |
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel | 06/02/2017 | 29/10/2018 |
Adm. Solid. | Sironi Massimo | 14/12/2017 | 20/09/2018 |
Apoderado | Lopez Chacon Pedro | 29/10/2018 | 20/09/2018 |
Apoderado | Galicia Aceituno Patricia | 20/11/2020 | 20/09/2018 |
Apoderado | Esser Susanna Angela | 24/01/2014 | 20/09/2018 |
Apoderado | Esser Susanna Angela | 29/10/2018 | 20/09/2018 |
Adm. Unico | Esser Susanna Angela | 15/12/2017 | 20/09/2018 |
Apoderado | Castrillo De Larreta Azelain Enrique | 24/11/2010 | 20/09/2018 |
Auditor | Bdo Auditores SLP | 21/10/2022 | 20/09/2018 |
Auditor | Bdo Auditores SLP | 11/06/2015 | 20/09/2018 |
Auditor | Bdo Auditores SLP | 29/10/2018 | 20/09/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Bpw Trapaco SL.
28
Jun 2023
Con fecha 28/06/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Mehnert Jascha Henrik |
Datos registrales: T 11656 , F 203, S 8, H M 183039, I/A 32
21
Oct 2022
Con fecha 21/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 11656 , F 202, S 8, H M 183039, I/A 31
03
Oct 2022
Con fecha 03/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 11656 , F 202, S 8, H M 183039, I/A 30
04
Ene 2022
Con fecha 04/01/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel |
Datos registrales: T 11656 , F 201, S 8, H M 183039, I/A 29
08
Feb 2021
Con fecha 08/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Solid. | Schell Markus |
Datos registrales: T 11656 , F 201, S 8, H M 183039, I/A 28
08
Feb 2021
Con fecha 08/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Solid. | Pfeiffer Friedrich Michael |
Datos registrales: T 11656 , F 201, S 8, H M 183039, I/A 28
20
Nov 2020
Con fecha 20/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Galicia Aceituno Patricia |
Datos registrales: T 11656 , F 201, S 8, H M 183039, I/A 27
19
Oct 2020
Con fecha 19/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 11656 , F 201, S 8, H M 183039, I/A 26
24
Jul 2020
Con fecha 24/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 11656 , F 200, S 8, H M 183039, I/A 25
18
Feb 2020
Con fecha 18/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Mehnert Jascha Henrik |
Datos registrales: T 11656 , F 200, S 8, H M 183039, I/A 24
18
Feb 2020
Con fecha 18/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel |
Datos registrales: T 11656 , F 200, S 8, H M 183039, I/A 24
02
Ago 2019
Con fecha 02/08/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel |
Apoderado | Mehnert Jascha Henrik |
Datos registrales: T 11656 , F 199, S 8, H M 183039, I/A 23
02
Ago 2019
Con fecha 02/08/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel |
Datos registrales: T 11656 , F 199, S 8, H M 183039, I/A 22
30
Oct 2018
Con fecha 30/10/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias BPW BERGISCHE ACHSEN KG.
Datos registrales: T 11656 , F 199, S 8, H M 183039, I/A 21
29
Oct 2018
Con fecha 29/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 11656 , F 199, S 8, H M 183039, I/A 20
29
Oct 2018
Con fecha 29/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel |
Datos registrales: T 11656 , F 198, S 8, H M 183039, I/A 19
29
Oct 2018
Con fecha 29/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tejeda Menendez Manuel Angel |
Datos registrales: T 11656 , F 198, S 8, H M 183039, I/A 19
29
Oct 2018
Con fecha 29/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Esser Susanna Angela |
Datos registrales: T 11656 , F 197, S 8, H M 183039, I/A 18
29
Oct 2018
Con fecha 29/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Lopez Chacon Pedro |
Datos registrales: T 11656 , F 196, S 8, H M 183039, I/A 17
20
Sep 2018
Sociedades absorbidas: BPW TRAPACO SL.
Datos registrales: T 11656 , F 122, S 8, H M 183039, I/A 16
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-126-28 | Madrid | 05/07/2023 | |
BORME-A-2022-207-28 | Madrid | 28/10/2022 | |
BORME-A-2022-194-28 | Madrid | 10/10/2022 | |
BORME-A-2022-7-28 | Madrid | 12/01/2022 | |
BORME-A-2021-30-28 | Madrid | 15/02/2021 | |
BORME-A-2020-229-28 | Madrid | 27/11/2020 | |
BORME-A-2020-207-28 | Madrid | 26/10/2020 | |
BORME-A-2020-147-28 | Madrid | 31/07/2020 | |
BORME-A-2020-38-28 | Madrid | 25/02/2020 | |
BORME-A-2019-152-28 | Madrid | 09/08/2019 | |
BORME-A-2018-214-28 | Madrid | 07/11/2018 | |
BORME-A-2018-213-28 | Madrid | 06/11/2018 | |
BORME-A-2018-189-28 | Madrid | 01/10/2018 | |
BORME-A-2017-242-28 | Madrid | 22/12/2017 | |
BORME-A-2017-109-28 | Madrid | 12/06/2017 | |
BORME-A-2017-46-28 | Madrid | 07/03/2017 | |
BORME-A-2017-30-28 | Madrid | 13/02/2017 | |
BORME-A-2017-29-28 | Madrid | 10/02/2017 | |
BORME-A-2017-28-28 | Madrid | 09/02/2017 | |
BORME-A-2016-243-28 | Madrid | 23/12/2016 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades