info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.

Información de la compañía
Situación Mercantil Activa
Forma jurídica Sociedad Anónima
NIF A80584642
Denominación anterior Bandai Namco Games Iberica SA
Provincia Madrid
Domicilio Via De Los Poblados Km 13 5 B1 (Madrid).
Capital social 60.000,0 euros
Cargos directivos
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Auditor Kpmg Auditores SL 17/02/2023 Actualidad
Auditor Kpmg Auditores SL 17/02/2022 Actualidad
Presidente Muller Arnaud 08/04/2021 Actualidad
Consejero Muller Arnaud 08/04/2021 Actualidad
Auditor Kpmg Auditores SL 22/03/2021 Actualidad
Presidente Muller Arnaud 22/01/2021 Actualidad
Consejero Jennifer Briere Aurore 22/01/2021 Actualidad
Secretario Garcia Ruiz Juan Miguel 22/01/2021 Actualidad
Consejero Akiyama Takashi 22/01/2021 Actualidad
Apoderado Pichon Olivier 30/12/2019 Actualidad
Apoderado Muller Arnaud 30/12/2019 Actualidad
Apoderado Madrid Albarran Jose Luis 30/12/2019 Actualidad
Apoderado Katashima Naoki 30/12/2019 Actualidad
Apoderado Gonzalez Lorca Alberto Carlos 30/12/2019 Actualidad
Apoderado Delanoy Cristophe 30/12/2019 Actualidad
Apoderado Colne Lionel 30/12/2019 Actualidad
Apoderado Briere Aurore Jennifer 30/12/2019 Actualidad
Apoderado Alves Isabel 30/12/2019 Actualidad
Auditor Kpmg Auditores SL 19/12/2019 Actualidad
Presidente Katashima Naoki 18/12/2019 Actualidad
Ver más
Mostrar cargos directivos no vigentes
Cargos directivos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Consejero Niki Yoshikuni 30/07/2019 22/01/2021
Presidente Katashima Naoki 13/03/2014 22/01/2021
Consejero Katashima Naoki 02/11/2009 22/01/2021
Apoderado Pichon Olivier 25/01/2012 30/12/2019
Apoderado Madrid Albarran Jose Luis 25/01/2012 30/12/2019
Apoderado Gonzalez Lorca Alberto Carlos 25/01/2012 30/12/2019
Apoderado Delanoy Cristophe 25/01/2012 30/12/2019
Apoderado Comte Olivier 25/01/2012 30/12/2019
Apoderado Colne Lionel 25/01/2012 30/12/2019
Apoderado Camus Cedric 25/01/2012 30/12/2019
Apoderado Armitano-Grivel Frederic Michel Bruno 25/01/2012 30/12/2019
Apoderado Alves Isabel 25/01/2012 30/12/2019
Consejero Masaaki Tusuji 27/05/2011 30/07/2019
Consejero Yanagihara Hideo 13/03/2014 01/07/2016
Presidente Takahara Shusuke 27/05/2011 13/03/2014
Consejero Takahara Shusuke 27/05/2011 13/03/2014
Apoderado Katashima Naoki 01/12/2009 25/01/2012
Apoderado Gonzalez Lorca Alberto Carlos 01/12/2009 25/01/2012
Apoderado Colne Lionel 01/12/2009 25/01/2012
Apoderado Chedeville Gregory 01/12/2009 25/01/2012
Ver más
Anuncios Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Bandai Namco Entertainment Iberica SA.

17

Feb 2023

Reelecciones

Con fecha 17/02/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Auditor Kpmg Auditores SL

PDF Anuncio nº 99689 de 2023

Datos registrales: T 39131 , F 116, S 8, H M 102439, I/A 98

17

Feb 2022

Reelecciones

Con fecha 17/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Auditor Kpmg Auditores SL

PDF Anuncio nº 83329 de 2022

Datos registrales: T 39131 , F 116, S 8, H M 102439, I/A 97

25

Ene 2022

Otros conceptos

CAMBIADA LA DENOMINACION DEL ACCIONISTA UNICO DE "NAMCO BANDAI GAMES EUROPE S.A.S" A "BANDAI NAMCO GAMES EUROPE S.A.S". CAMBIADA LA DENOMINACION DEL ACCIONSTA UNICO DE "BANDAI NAMCO GAMES EUROPE S.A.S", A "BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE S.A.S". CAMBIADA LA DENOMINACION DEL ACCIONISTA UNICO DE "BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPE S.A.S" A "BANDAI NAMCO EUROPE S.A.S".


PDF Anuncio nº 44918 de 2022

Datos registrales: T 39131 , F 116, S 8, H M 102439, I/A 96

15

Jun 2021

Cambio de domicilio social

Con fecha 15/06/2021, la sociedad cambia su domicilio social a VIA DE LOS POBLADOS Km 13 5 B1 (MADRID).


PDF Anuncio nº 303247 de 2021

Datos registrales: T 39131 , F 115, S 8, H M 102439, I/A 95

08

Abr 2021

Reelecciones

Con fecha 08/04/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Presidente Muller Arnaud

PDF Anuncio nº 171035 de 2021

Datos registrales: T 39131 , F 115, S 8, H M 102439, I/A 94

22

Mar 2021

Reelecciones

Con fecha 22/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Auditor Kpmg Auditores SL

PDF Anuncio nº 145442 de 2021

Datos registrales: T 39131 , F 115, S 8, H M 102439, I/A 93

22

Ene 2021

Reelecciones

Con fecha 22/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Secretario Garcia Ruiz Juan Miguel

PDF Anuncio nº 45331 de 2021

Datos registrales: T 39131 , F 114, S 8, H M 102439, I/A 92

22

Ene 2021

Nombramientos

Con fecha 22/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Presidente Muller Arnaud
Consejero Jennifer Briere Aurore
Consejero Akiyama Takashi

PDF Anuncio nº 45331 de 2021

Datos registrales: T 39131 , F 114, S 8, H M 102439, I/A 92

22

Ene 2021

Ceses/Dimisiones

Con fecha 22/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Niki Yoshikuni
Presidente Katashima Naoki

PDF Anuncio nº 45331 de 2021

Datos registrales: T 39131 , F 114, S 8, H M 102439, I/A 92

30

Dic 2019

Nombramientos

Con fecha 30/12/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Pichon Olivier
Apoderado Muller Arnaud
Apoderado Madrid Albarran Jose Luis
Apoderado Katashima Naoki
Apoderado Gonzalez Lorca Alberto Carlos
Apoderado Delanoy Cristophe
Apoderado Colne Lionel
Apoderado Briere Aurore Jennifer
Apoderado Alves Isabel

PDF Anuncio nº 8538 de 2020

Datos registrales: T 39131 , F 113, S 8, H M 102439, I/A 91

30

Dic 2019

Revocaciones

Con fecha 30/12/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Pichon Olivier
Apoderado Madrid Albarran Jose Luis
Apoderado Gonzalez Lorca Alberto Carlos
Apoderado Delanoy Cristophe
Apoderado Comte Olivier
Apoderado Colne Lionel
Apoderado Camus Cedric
Apoderado Armitano-Grivel Frederic Michel Bruno
Apoderado Alves Isabel

PDF Anuncio nº 8538 de 2020

Datos registrales: T 39131 , F 113, S 8, H M 102439, I/A 91

19

Dic 2019

Reelecciones

Con fecha 19/12/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Auditor Kpmg Auditores SL

PDF Anuncio nº 540903 de 2019

Datos registrales: T 39131 , F 113, S 8, H M 102439, I/A 90

18

Dic 2019

Reelecciones

Con fecha 18/12/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Katashima Naoki

PDF Anuncio nº 538623 de 2019

Datos registrales: T 39131 , F 113, S 8, H M 102439, I/A 89

30

Jul 2019

Nombramientos

Con fecha 30/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Niki Yoshikuni

PDF Anuncio nº 343636 de 2019

Datos registrales: T 20739 , F 34, S 8, H M 102439, I/A 88

30

Jul 2019

Ceses/Dimisiones

Con fecha 30/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Masaaki Tusuji

PDF Anuncio nº 343636 de 2019

Datos registrales: T 20739 , F 34, S 8, H M 102439, I/A 88

14

Nov 2018

Reelecciones

Con fecha 14/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Auditor Kpmg Auditores SL

PDF Anuncio nº 464181 de 2018

Datos registrales: T 20739 , F 34, S 8, H M 102439, I/A 87

19

Sep 2018

Reelecciones

Con fecha 19/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Secretario Garcia Ruiz Juan Miguel

PDF Anuncio nº 390012 de 2018

Datos registrales: T 20739 , F 34, S 8, H M 102439, I/A 86

21

Dic 2017

Reelecciones

Con fecha 21/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Auditor Kpmg Auditores SL

PDF Anuncio nº 1725 de 2018

Datos registrales: T 20739 , F 34, S 8, H M 102439, I/A 85

01

Jul 2016

Nombramientos

Con fecha 01/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Muller Arnaud

PDF Anuncio nº 289096 de 2016

Datos registrales: T 20739 , F 33, S 8, H M 102439, I/A 84

01

Jul 2016

Ceses/Dimisiones

Con fecha 01/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Yanagihara Hideo

PDF Anuncio nº 289096 de 2016

Datos registrales: T 20739 , F 33, S 8, H M 102439, I/A 84

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2023-39-28 Madrid 24/02/2023
PDF BORME-A-2022-38-28 Madrid 24/02/2022
PDF BORME-A-2022-21-28 Madrid 01/02/2022
PDF BORME-A-2021-117-28 Madrid 22/06/2021
PDF BORME-A-2021-70-28 Madrid 15/04/2021
PDF BORME-A-2021-59-28 Madrid 29/03/2021
PDF BORME-A-2021-19-28 Madrid 29/01/2021
PDF BORME-A-2020-6-28 Madrid 10/01/2020
PDF BORME-A-2019-247-28 Madrid 27/12/2019
PDF BORME-A-2019-246-28 Madrid 26/12/2019
PDF BORME-A-2019-149-28 Madrid 06/08/2019
PDF BORME-A-2018-223-28 Madrid 21/11/2018
PDF BORME-A-2018-186-28 Madrid 26/09/2018
PDF BORME-A-2018-1-28 Madrid 02/01/2018
PDF BORME-A-2016-131-28 Madrid 11/07/2016
PDF BORME-A-2015-42-28 Madrid 03/03/2015
PDF BORME-A-2015-7-28 Madrid 13/01/2015
PDF BORME-A-2014-249-28 Madrid 31/12/2014
PDF BORME-A-2014-64-28 Madrid 02/04/2014
PDF BORME-A-2014-56-28 Madrid 21/03/2014
Ver más

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret