Última actualización: 20 de Octubre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 6 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A08586323 |
Denominación anterior | F Closa Alegret SA |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 1.220.000,0 euros |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REP.ADM.CONC | Sarrate Pou Joaquim | 31/10/2016 | 20/10/2020 |
ADM.CONCURS. | Pluta Abogados GMBH | 31/10/2016 | 20/10/2020 |
APODERAD.SOL | Lopez Gonzalez Antonio Jesus | 01/03/2016 | 20/10/2020 |
AUDIT.CUENT. | Horwath Plm Auditores SL | 14/05/2015 | 20/10/2020 |
AUDIT.CUENT. | Euroaudit SL | 14/01/2010 | 20/10/2020 |
AUDIT.CUENT. | Euroaudit SL | 29/09/2011 | 20/10/2020 |
APODERADO | Closa Soldevila Maria Esperanza | 16/06/2010 | 20/10/2020 |
APODERAD.SOL | Closa Soldevila Maria Angeles | 13/12/2013 | 20/10/2020 |
LIQUIDADOR | Lopez Gonzalez Antonio Jesus | 28/07/2016 | 31/10/2016 |
CONSEJERO | Lopez Gonzalez Antonio Jesus | 01/03/2016 | 28/07/2016 |
PRESIDENTE | Closa Solves Francisco | 01/03/2016 | 28/07/2016 |
CONSEJERO | Closa Solves Francisco | 01/03/2016 | 28/07/2016 |
SECRETARIO | Castellar Almirall Ignacio | 01/03/2016 | 28/07/2016 |
CONSEJERO | Castellar Almirall Ignacio | 01/03/2016 | 28/07/2016 |
CONSEJERO | Lopez Gonzalez Antonio Jesus | 16/06/2010 | 01/03/2016 |
CONS. DELEG. | Lopez Gonzalez Antonio Jesus | 16/06/2010 | 01/03/2016 |
PRESIDENTE | Closa Solves Francisco | 22/07/2013 | 01/03/2016 |
CONSEJERO | Closa Solves Francisco | 22/07/2013 | 01/03/2016 |
SECRETARIO | Castellar Almirall Ignacio | Desconocido | 01/03/2016 |
CONSEJERO | Castellar Almirall Ignacio | 16/06/2010 | 01/03/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Atilmo Serv SA.
20
Oct 2020
Con fecha 20/10/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 44115 , F 98, S 8, H B 38790, I/A 59
20
Oct 2020
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 602/2016, AUTO FIRME DE FECHA 31/07/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO.
Datos registrales: T 44115 , F 98, S 8, H B 38790, I/A 59
20
Oct 2020
Con fecha 20/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REP.ADM.CONC | Sarrate Pou Joaquim |
ADM.CONCURS. | Pluta Abogados GMBH |
Datos registrales: T 44115 , F 98, S 8, H B 38790, I/A 59
31
Oct 2016
JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 602/2016, AUTO FIRME DE FECHA 01/09/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION.
Datos registrales: T 44115 , F 97, S 8, H B 38790, I/A 58
31
Oct 2016
Con fecha 31/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REP.ADM.CONC | Sarrate Pou Joaquim |
ADM.CONCURS. | Pluta Abogados GMBH |
Datos registrales: T 44115 , F 97, S 8, H B 38790, I/A 58
31
Oct 2016
Con fecha 31/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Lopez Gonzalez Antonio Jesus |
Datos registrales: T 44115 , F 97, S 8, H B 38790, I/A 58
28
Jul 2016
Con fecha 28/07/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 44115 , F 97, S 8, H B 38790, I/A 57
28
Jul 2016
Con fecha 28/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Lopez Gonzalez Antonio Jesus |
Datos registrales: T 44115 , F 97, S 8, H B 38790, I/A 57
28
Jul 2016
Con fecha 28/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Lopez Gonzalez Antonio Jesus |
PRESIDENTE | Closa Solves Francisco |
CONSEJERO | Castellar Almirall Ignacio |
Datos registrales: T 44115 , F 97, S 8, H B 38790, I/A 57
20
Jul 2016
Con fecha 20/07/2016, la sociedad cambia su denominación social a ATILMO SERV SA
Datos registrales: T 44115 , F 96, S 8, H B 38790, I/A 56
21
Abr 2016
Reducción de capital
Datos registrales: T 44115 , F 96, S 8, H B 38790, I/A 55
01
Mar 2016
Con fecha 01/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Lopez Gonzalez Antonio Jesus |
Datos registrales: T 44115 , F 94, S 8, H B 38790, I/A 54
01
Mar 2016
Con fecha 01/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Lopez Gonzalez Antonio Jesus |
PRESIDENTE | Closa Solves Francisco |
SECRETARIO | Castellar Almirall Ignacio |
Datos registrales: T 44115 , F 94, S 8, H B 38790, I/A 53
01
Mar 2016
Con fecha 01/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Lopez Gonzalez Antonio Jesus |
CONSEJERO | Closa Solves Francisco |
SECRETARIO | Castellar Almirall Ignacio |
Datos registrales: T 44115 , F 94, S 8, H B 38790, I/A 53
25
Nov 2015
Con fecha 25/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Miquel Mollevi Alejandro |
CONSEJERO | Inverresidenciales 2005 SL |
PRESIDENTE | F Closa Alegret SA |
REPR.143 RRM | Closa Solves Francisco |
SECR.NO CONS | Castellar Almirall Ignacio |
Datos registrales: T 40819 , F 7, S 8, H B 304155, I/A 18
20
May 2015
Con fecha 20/05/2015, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 2.350.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 38.52% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 6.100.000,0€.
Datos registrales: T 44115 , F 93, S 8, H B 38790, I/A 52
14
May 2015
Con fecha 14/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Horwath Plm Auditores SL |
Datos registrales: T 44115 , F 93, S 8, H B 38790, I/A 51
30
Oct 2014
Con fecha 30/10/2014, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 1.750.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 46.67% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 3.750.000,0€.
Datos registrales: T 44115 , F 92, S 8, H B 38790, I/A 50
07
Oct 2014
Con fecha 07/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Pascuas Medel Joaquin |
CONSEJERO | Otinix SL |
CONSEJERO | Ofitec Barcelona Residencial SL |
REPR.143 RRM | Molins Lopez Rodo Ana Maria |
REPR.143 RRM | Miquel Mollevi Alejandro |
PRESIDENTE | F Closa Alegret SA |
REPR.143 RRM | Closa Solves Francisco |
SECR.NO CONS | Castellar Almirall Ignacio |
CONSEJERO | Cartera De Inversiones Cm SA |
Datos registrales: T 37809 , F 137, S 8, H B 296418, I/A 10
13
Dic 2013
Con fecha 13/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Closa Soldevila Maria Angeles |
Datos registrales: T 41958 , F 160, S 8, H B 38790, I/A 49
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2020-208-08 | Barcelona | 27/10/2020 | |
BORME-A-2016-214-08 | Barcelona | 10/11/2016 | |
BORME-A-2016-148-08 | Barcelona | 04/08/2016 | |
BORME-A-2016-144-08 | Barcelona | 29/07/2016 | |
BORME-A-2016-82-08 | Barcelona | 29/04/2016 | |
BORME-A-2016-47-08 | Barcelona | 09/03/2016 | |
BORME-A-2015-230-08 | Barcelona | 02/12/2015 | |
BORME-A-2015-99-08 | Barcelona | 28/05/2015 | |
BORME-A-2015-95-08 | Barcelona | 22/05/2015 | |
BORME-A-2014-213-08 | Barcelona | 06/11/2014 | |
BORME-A-2014-196-08 | Barcelona | 14/10/2014 | |
BORME-A-2013-243-08 | Barcelona | 20/12/2013 | |
BORME-A-2013-168-08 | Barcelona | 04/09/2013 | |
BORME-A-2013-145-08 | Barcelona | 01/08/2013 | |
BORME-A-2013-142-08 | Barcelona | 29/07/2013 | |
BORME-A-2013-95-08 | Barcelona | 23/05/2013 | |
BORME-A-2012-84-08 | Barcelona | 04/05/2012 | |
BORME-A-2011-194-08 | Barcelona | 11/10/2011 | |
BORME-A-2010-190-08 | Barcelona | 01/10/2010 | |
BORME-A-2010-122-08 | Barcelona | 29/06/2010 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades