Última actualización: 5 de Enero de 2012
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 12 años, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B85357036 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Paseo De Recoletos 37 4& (Madrid). |
Objeto social | La compraventa al por mayor y menor, importacion, exportacion, distribucion, representacion y promocion, por cuenta propia o ajen, de productos quimicos en general. |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Verdaguer De Lorenzo Jose | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Apoderado | Steiner Silvia | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Apo.Manc. | Pignolet David Walter | 22/02/2011 | 05/01/2012 |
Apoderado | Otaegui Ochoa Eva | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Cons.Del.Sol | Oehen Jurg | 27/01/2011 | 05/01/2012 |
Apo.Manc. | Oehen Jurg | 22/02/2011 | 05/01/2012 |
Apoderado | Mateu Garcia Josep | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Consejero | Mahatme Sandesh | 27/01/2011 | 05/01/2012 |
Cons.Del.Sol | Mahatme Sandesh | 27/01/2011 | 05/01/2012 |
Apo.Sol. | Mahatme Sandesh | 22/02/2011 | 05/01/2012 |
Apo.Sol. | Fox Mark Wilson | 27/09/2010 | 05/01/2012 |
Apoderado | Fogelman Mitchell Keith | 27/09/2010 | 05/01/2012 |
Apoderado | Colorado Arroyo Cristobal | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Presidente | Cavanaugh Thomas Michael | 27/01/2011 | 05/01/2012 |
Cons.Del.Sol | Cavanaugh Thomas Michael | 27/01/2011 | 05/01/2012 |
Apoderado | Cavanaugh Thomas Michael | 25/11/2010 | 05/01/2012 |
Apoderado | Calero Guardado Ignacio | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Apo.Manc. | Bressette Douglas Glenn | 22/02/2011 | 05/01/2012 |
Apoderado | Aroca Laguna David | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Apo.Manc. | Amos David Nicolas | 22/02/2011 | 05/01/2012 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Abraxis Bioscience Spain SL.
05
Ene 2012
Con fecha 05/01/2012 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 20
05
Ene 2012
Con fecha 05/01/2012 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 20
05
Ene 2012
Con fecha 05/01/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Van Hoek Andre Laurent Elisabeth Maria |
Consejero | Oehen Jurg |
Cons.Del.Sol | Mahatme Sandesh |
Presidente | Cavanaugh Thomas Michael |
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 20
17
Nov 2011
Con fecha 17/11/2011 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias CELGENE SL.
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 19
30
Jun 2011
ANOTADO EL PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION DE LAS SOCIEDADES: CELGENE SL, COMO ABSORBENTE, INSCRITA EN EL TOMO 21670, FOLIO 206, SECCION 8&, HOJA M-385890. Y ABRAXIS BIOSCIENCE SPAIN SL, COMO ABSORBIDA,INSCRITA EN EL TOMO 25312, FOLIO 168, SECCION 8&, HOJA M-455827.
Datos registrales: T 25312 , F 168, S 8, H M 455827, I/A 1-M
11
May 2011
Con fecha 11/05/2011, la sociedad cambia su domicilio social a PASEO DE RECOLETOS 37 4& (MADRID).
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 18
11
May 2011
Con fecha 11/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Garcia Medinilla Cristina |
Datos registrales: T 25312 , F 179, S 8, H M 455827, I/A 17
22
Feb 2011
Con fecha 22/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Ramos Alves Sandra Maria |
Apo.Manc. | Pignolet David Walter |
Apo.Manc. | Oehen Jurg |
Apo.Manc. | Moletteri Patrick Thomas |
Apo.Sol. | Mahatme Sandesh |
Apo.Manc. | Bressette Douglas Glenn |
Apo.Manc. | Amos David Nicolas |
Datos registrales: T 25312 , F 178, S 8, H M 455827, I/A 16
01
Feb 2011
Con fecha 01/02/2011, la sociedad cambia su domicilio social a PASEO DE LA CASTELLANA 92 - 1º PLANTA (MADRID).
Datos registrales: T 25312 , F 178, S 8, H M 455827, I/A 15
27
Ene 2011
Con fecha 27/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Sol | Van Hoek Andre Laurent Elisabeth Maria |
Secretario | Oehen Jurg |
Cons.Del.Sol | Mahatme Sandesh |
Cons.Del.Sol | Cavanaugh Thomas Michael |
Datos registrales: T 25312 , F 178, S 8, H M 455827, I/A 14
27
Ene 2011
Con fecha 27/01/2011, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración.
Datos registrales: T 25312 , F 177, S 8, H M 455827, I/A 13
27
Ene 2011
Con fecha 27/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Van Hoek Andre Laurent Elisabeth Maria |
Consejero | Oehen Jurg |
Consejero | Mahatme Sandesh |
Consejero | Cavanaugh Thomas Michael |
Datos registrales: T 25312 , F 177, S 8, H M 455827, I/A 13
27
Ene 2011
Con fecha 27/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Solid. | Wendel Bruce |
Adm. Solid. | Henry Gimonet Jean Francois |
Datos registrales: T 25312 , F 177, S 8, H M 455827, I/A 13
25
Nov 2010
Con fecha 25/11/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Cavanaugh Thomas Michael |
Datos registrales: T 25312 , F 176, S 8, H M 455827, I/A 12
27
Sep 2010
Con fecha 27/09/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Rodgers Richard Joseph |
Datos registrales: T 25312 , F 176, S 8, H M 455827, I/A 11
27
Sep 2010
Con fecha 27/09/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Fogelman Mitchell Keith |
Datos registrales: T 25312 , F 175, S 8, H M 455827, I/A 10
27
Sep 2010
Con fecha 27/09/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Moulder Leon Oliver |
Datos registrales: T 25312 , F 175, S 8, H M 455827, I/A 10
27
Sep 2010
Con fecha 27/09/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Rodgers Richard Joseph |
Apo.Sol. | Moulder Leon Oliver |
Apo.Sol. | Fox Mark Wilson |
Datos registrales: T 25312 , F 174, S 8, H M 455827, I/A 9
10
Ago 2009
Con fecha 10/08/2009, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios.
Datos registrales: T 25312 , F 174, S 8, H M 455827, I/A 8
10
Ago 2009
Con fecha 10/08/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Solid. | Wendel Bruce |
Adm. Solid. | Henry Gimonet Jean Francois |
Datos registrales: T 25312 , F 174, S 8, H M 455827, I/A 8
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2012-13-28 | Madrid | 19/01/2012 |
BORME-A-2011-225-28 | Madrid | 28/11/2011 |
BORME-A-2011-131-28 | Madrid | 11/07/2011 |
BORME-A-2011-97-28 | Madrid | 23/05/2011 |
BORME-A-2011-44-28 | Madrid | 04/03/2011 |
BORME-A-2011-29-28 | Madrid | 11/02/2011 |
BORME-A-2011-27-28 | Madrid | 09/02/2011 |
BORME-A-2010-234-28 | Madrid | 09/12/2010 |
BORME-A-2010-194-28 | Madrid | 07/10/2010 |
BORME-A-2009-161-28 | Madrid | 25/08/2009 |
BORME-A-2009-152-28 | Madrid | 12/08/2009 |
BORME-A-2009-127-28 | Madrid | 08/07/2009 |
BORME-A-2009-116-28 | Madrid | 23/06/2009 |
BORME-A-2009-107-28 | Madrid | 09/06/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades