Última actualización: 23 de Julio de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Disuelta desde hace 5 años, 8 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B62147715 |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 530.000,0 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.MANCOMU | Staci Jane Reardon | 10/04/2017 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Olivier Geeraerts | 10/04/2017 | Actualidad |
CONSEJERO | Heinrich Benedikt Lingnau Schneider | 10/04/2017 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Franck Pietrantoni | 10/04/2017 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Esquembre Clerigues Juan Jose | 10/04/2017 | Actualidad |
SECRETARIO | Christoph Jozef L Cluyse | 10/04/2017 | Actualidad |
CONSEJERO | Christoph Jozef L Cluyse | 10/04/2017 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Betty Lieve Francoise Arys | 10/04/2017 | Actualidad |
APOD.MANCOMU | Alexander Ronald Seng | 10/04/2017 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 31/07/2015 | Actualidad |
APODERAD.SOL | A Schulman INC | 21/05/2015 | Actualidad |
PRESIDENTE | Franck Pietrantoni | 12/07/2013 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 14/12/2012 | Actualidad |
CONSEJERO | Franck Pietrantoni | 14/12/2012 | Actualidad |
CONS. DELEG. | Franck Pietrantoni | 14/12/2012 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 14/08/2012 | Actualidad |
APODERADO | Torres Blanquez Miguel | 05/04/2012 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 27/10/2011 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 27/10/2011 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 05/08/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJERO | Oliver Thomas Neuss | 12/07/2013 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Jeffrey Michael Goggins | 07/05/2015 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Jeffrey Michael Goggins | 09/07/2015 | 10/04/2017 |
SECRETARIO | Isabel Casimiro | 06/10/2015 | 10/04/2017 |
CONSEJERO | Isabel Casimiro | 06/10/2015 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Heinrich Benedikt Lingnau Schneider | 09/07/2015 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Franck Pietrantoni | 07/05/2015 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Franck Pietrantoni | 09/07/2015 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Cisneros Pablo Angel Luis | 07/05/2015 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Betty Lieve Francoise Arys | 09/07/2015 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Betty Lieve Francoise Arys | 07/05/2015 | 10/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Anabella Da Silva | 09/07/2015 | 10/04/2017 |
SECRETARIO | Stefan Albert Mariette Van Borm | 12/07/2013 | 06/10/2015 |
CONSEJERO | Stefan Albert Mariette Van Borm | 12/07/2013 | 06/10/2015 |
APOD.MANCOMU | Stefan Albert Mariette Van Borm | 09/07/2015 | 06/10/2015 |
APOD.MANCOMU | Stefan Albert Mariette Van Borm | 07/05/2015 | 06/10/2015 |
APODERADO | Stefan Van Borm | 07/05/2012 | 09/07/2015 |
APODERADO | Laurent Barret | 07/05/2012 | 09/07/2015 |
APODERADO | Christoph Cluyse | 07/05/2012 | 09/07/2015 |
APODERADO | Bruno Andriamasoandro | 07/05/2012 | 09/07/2015 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por A Schulman Plastics SL.
23
Jul 2018
Con fecha 23/07/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 43166 , F 76, S 8, H B 204625, I/A 35
10
Abr 2017
Con fecha 10/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Staci Jane Reardon |
APOD.MANCOMU | Olivier Geeraerts |
CONSEJERO | Heinrich Benedikt Lingnau Schneider |
APOD.MANCOMU | Franck Pietrantoni |
APOD.MANCOMU | Esquembre Clerigues Juan Jose |
CONSEJERO | Christoph Jozef L Cluyse |
APOD.MANCOMU | Betty Lieve Francoise Arys |
APOD.MANCOMU | Alexander Ronald Seng |
Datos registrales: T 43166 , F 75, S 8, H B 204625, I/A 34
10
Abr 2017
Con fecha 10/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Oliver Thomas Neuss |
APOD.MANCOMU | Jeffrey Michael Goggins |
SECRETARIO | Isabel Casimiro |
APOD.MANCOMU | Heinrich Benedikt Lingnau Schneider |
APOD.MANCOMU | Franck Pietrantoni |
APOD.MANCOMU | Cisneros Pablo Angel Luis |
APOD.MANCOMU | Betty Lieve Francoise Arys |
APOD.MANCOMU | Anabella Da Silva |
Datos registrales: T 43166 , F 75, S 8, H B 204625, I/A 34
06
Oct 2015
Con fecha 06/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Isabel Casimiro |
Datos registrales: T 43166 , F 75, S 8, H B 204625, I/A 33
06
Oct 2015
Con fecha 06/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECRETARIO | Stefan Albert Mariette Van Borm |
Datos registrales: T 43166 , F 75, S 8, H B 204625, I/A 33
31
Jul 2015
Con fecha 31/07/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 43166 , F 75, S 8, H B 204625, I/A 32
09
Jul 2015
Con fecha 09/07/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Stefan Albert Mariette Van Borm |
APOD.MANCOMU | Jeffrey Michael Goggins |
APOD.MANCOMU | Heinrich Benedikt Lingnau Schneider |
APOD.MANCOMU | Franck Pietrantoni |
APOD.MANCOMU | Betty Lieve Francoise Arys |
APOD.MANCOMU | Anabella Da Silva |
Datos registrales: T 43166 , F 74, S 8, H B 204625, I/A 31
09
Jul 2015
Con fecha 09/07/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Stefan Van Borm |
APODERADO | Rodriguez Merelles Jose Manuel |
APODERADO | Petrus Speek |
APODERADO | Marcellinus Van Schaik |
APODERADO | Marc Rillaerts |
APODERADO | Laurent Barret |
APODERADO | Heinrich Lingnau Schneider |
APODERADO | Erwin Van Opstal |
APODERADO | Christoph De Jaeger |
APODERADO | Christoph Cluyse |
APODERADO | Bruno Andriamasoandro |
APODERADO | Betty Arijs |
Datos registrales: T 43166 , F 74, S 8, H B 204625, I/A 31
21
May 2015
Con fecha 21/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | A Schulman INC |
Datos registrales: T 43166 , F 74, S 8, H B 204625, I/A 30
07
May 2015
Con fecha 07/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Stefan Albert Mariette Van Borm |
APOD.MANCOMU | Jeffrey Michael Goggins |
APOD.MANCOMU | Franck Pietrantoni |
APOD.MANCOMU | Cisneros Pablo Angel Luis |
APOD.MANCOMU | Betty Lieve Francoise Arys |
Datos registrales: T 44364 , F 61, S 8, H B 204625, I/A 29
12
Jul 2013
Con fecha 12/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECRETARIO | Stefan Albert Mariette Van Borm |
CONSEJERO | Oliver Thomas Neuss |
PRESIDENTE | Franck Pietrantoni |
Datos registrales: T 43166 , F 73, S 8, H B 204625, I/A 28
12
Jul 2013
Con fecha 12/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECRETARIO | Laurent Barret |
CONSEJERO | Bernard Rzepka |
Datos registrales: T 43166 , F 73, S 8, H B 204625, I/A 28
14
Dic 2012
Con fecha 14/12/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 43166 , F 72, S 8, H B 204625, I/A 27
14
Dic 2012
CAMBIO DE SOCIO UNICO PASANDO A SER EL NUEVO SOCIO UNICO "ASCHULMAN HOLDINGS SARL".
Datos registrales: T 43166 , F 72, S 8, H B 204625, I/A 26
14
Dic 2012
Con fecha 14/12/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Franck Pietrantoni |
Datos registrales: T 43166 , F 72, S 8, H B 204625, I/A 26
14
Dic 2012
Con fecha 14/12/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Heinrich Lingnau Schneider |
Datos registrales: T 43166 , F 72, S 8, H B 204625, I/A 26
14
Ago 2012
Con fecha 14/08/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 43166 , F 71, S 8, H B 204625, I/A 25
07
May 2012
Con fecha 07/05/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Stefan Van Borm |
APODERADO | Rodriguez Merelles Jose Manuel |
APODERADO | Petrus Speek |
APODERADO | Marcellinus Van Schaik |
APODERADO | Marc Rillaerts |
APODERADO | Laurent Barret |
APODERADO | Heinrich Lingnau Schneider |
APODERADO | Erwin Van Opstal |
APODERADO | Christoph De Jaeger |
APODERADO | Christoph Cluyse |
APODERADO | Bruno Andriamasoandro |
APODERADO | Betty Arijs |
Datos registrales: T 43166 , F 71, S 8, H B 204625, I/A 24
05
Abr 2012
Con fecha 05/04/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Torres Blanquez Miguel |
Datos registrales: T 32259 , F 208, S 8, H B 204625, I/A 23
27
Oct 2011
Con fecha 27/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 32259 , F 207, S 8, H B 204625, I/A 19
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2018-148-08 | Barcelona | 02/08/2018 |
BORME-A-2017-74-08 | Barcelona | 19/04/2017 |
BORME-A-2015-197-08 | Barcelona | 15/10/2015 |
BORME-A-2015-150-08 | Barcelona | 10/08/2015 |
BORME-A-2015-133-08 | Barcelona | 16/07/2015 |
BORME-A-2015-100-08 | Barcelona | 29/05/2015 |
BORME-A-2015-91-08 | Barcelona | 18/05/2015 |
BORME-A-2013-137-08 | Barcelona | 22/07/2013 |
BORME-A-2012-247-08 | Barcelona | 27/12/2012 |
BORME-A-2012-246-08 | Barcelona | 26/12/2012 |
BORME-A-2012-164-08 | Barcelona | 28/08/2012 |
BORME-A-2012-93-08 | Barcelona | 18/05/2012 |
BORME-A-2012-77-08 | Barcelona | 23/04/2012 |
BORME-A-2011-213-08 | Barcelona | 10/11/2011 |
BORME-A-2010-76-08 | Barcelona | 23/04/2010 |
BORME-A-2009-168-08 | Barcelona | 03/09/2009 |
BORME-A-2009-155-08 | Barcelona | 17/08/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades