info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 0
Cargos no vigentes 17
Apariciones en BORME 19
Cargos directivos en empresas
Esta persona no tiene ningún cargo en la actualidad, o no hay datos disponibles.
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apoderado Meteore Alcala SL 29/09/2017 28/09/2023
Apoderado Union Investment Real Estate GMBH 18/10/2012 16/02/2022
Apoderado Union Investment Real Estate GMBH 30/01/2015 16/02/2022
Apoderado Cushman & Wakefield Spain LTD Desconocido 21/10/2020
Apoderado Cushman & Wakefield Spain LTD Desconocido 21/10/2020
Apo.Manc. Cushman & Wakefield Spain LTD 22/12/2015 21/10/2020
Apo.Man.Soli Cushman & Wakefield Spain LTD 20/12/2010 21/10/2020
Apoderado Ireef-Leganes Spain Propco SL 13/08/2013 12/07/2020
Apoderado Invesco Reef-Leganes Spain Propco 2 SL 13/08/2013 12/07/2020
Apoderado Meteore Alcala SL Desconocido 29/09/2017
Apoderado Ubs Real Estate GMBH 12/01/2011 12/11/2015
Apoderado Ubs Real Estate GMBH 03/03/2010 12/11/2015
Apoderado Ubs Real Estate GMBH 11/05/2009 12/11/2015
Apoderado Ubs Real Estate GMBH 29/09/2009 12/11/2015
Apo.Man.Soli Ubs Real Estate GMBH 13/01/2011 12/11/2015
Apo.Manc. Ubs Real Estate GMBH 15/06/2010 06/05/2014
Apoderado Ubs Real Estate GMBH Desconocido 25/03/2009
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Clarke Suzanne Gillian .

16

Feb 2022

Revocaciones

Con fecha 16/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Weisenseel Jorg
Apo.Manc. Stobbe Jorn Gustav Horst Wilhelm
Apoderado Stembert Selma
Apo.Manc. Steinbruck Soren
Apoderado Schaffus Ralf
Apo.Manc. Ruben Pascal
Apo.Manc. Perez Fernandez Fernando
Apo.Manc. Palenzuela Gomez Rafael
Apoderado Montebaur Michael
Apo.Manc. Michalski Anja
Apo.Manc. Merry Del Val Roca De Togores Rafael
Apoderado Kohler Daniel
Apoderado Kandzia Lutz
Apoderado Jordens Markus
Apo.Manc. Jimenez Mayo Mario
Apo.Manc. Holger Lutz
Apo.Manc. Hartlief Ingo
Apo.Manc. Gomez Escamez Alberto
Apoderado Glaser Claudia
Apo.Manc. Gerloff Matthias Rudolf
Apoderado Gehringer Gerhard Wilhelm
Apoderado Ehrlich Jorgen
Apoderado Dammann Anja
Apoderado Clarke Suzanne Gillian
Apo.Manc. Billand Frank
Este acto mercantil contiene 25 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 81985 de 2022

Datos registrales: T 33111 , F 8, S 8, H M 249434, I/A 66

21

Oct 2020

Revocaciones

Con fecha 21/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Clarke Suzanne Gillian
Apoderado Clarke Susana

PDF Anuncio nº 366914 de 2020

Datos registrales: T 37932 , F 218, S 8, H M 34794, I/A 57

29

Sep 2017

Nombramientos

Con fecha 29/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Rubio Rodriguez Vigil Maria Eugenia
Apoderado Mateu Villanueva Rafael
Apoderado Garcia Hiernaux Alberto
Apoderado Clarke Suzanne Gillian

PDF Anuncio nº 396959 de 2017

Datos registrales: T 19436 , F 221, S 8, H M 341015, I/A 30

29

Sep 2017

Revocaciones

Con fecha 29/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Montoya Tolon Ana
Apoderado Mongiat Benoit Benjamin Robert
Apoderado Loussouarn Jacqueline
Apoderado Henriquez De Luna Basagoiti Manuel
Apoderado Guerard Christian Jean Claude
Apoderado Cooke Mbe Roger Maxwell
Apoderado Cognet Claudine Marguerite Marie
Apoderado Clarke Suzanne Gillian
Apoderado Chomettat Martine
Apoderado Carreño Alvarez Irene

PDF Anuncio nº 396959 de 2017

Datos registrales: T 19436 , F 221, S 8, H M 341015, I/A 30

22

Dic 2015

Nombramientos

Con fecha 22/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Claverol Villaplana Francisco
Apo.Manc. Clarke Suzanne Gillian

PDF Anuncio nº 5004 de 2016

Datos registrales: T 20032 , F 172, S 8, H M 34794, I/A 36

12

Nov 2015

Revocaciones

Con fecha 12/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Worel Nathalie Helene
Apo.Manc. Strauss Nicole
Apo.Man.Soli Rueda Cuadrado Encarnacion
Apo.Man.Soli Rodriguez Juan Soraya
Apoderado Ratz Markus Johannes
Apoderado Merz Gabriele
Apoderado Mateu Villanueva Rafael
Apoderado Kohl Hans Alberto
Apoderado Kitsch-Klocker Ingo
Apo.Manc. Jochen Haupt Klaus Michael
Apoderado Herdt Denise
Apo.Man.Soli Esteban Corrales Ignacio
Apo.Man.Soli Claverol Villaplana Francisco
Apoderado Claverol Villaplana Francesc
Apoderado Clarke Suzanne Gillian
Apoderado Busto Lopez Beatriz
Apoderado Bernhofer Christine

PDF Anuncio nº 468904 de 2015

Datos registrales: T 26015 , F 120, S 8, H M 334005, I/A 34

30

Ene 2015

Nombramientos

Con fecha 30/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Domingo Villanueva Marta
Apoderado Clarke Suzanne Gillian
Apoderado Barrachina Masip Oriol

PDF Anuncio nº 54262 de 2015

Datos registrales: T 28673 , F 187, S 8, H M 249434, I/A 57

06

May 2014

Revocaciones

Con fecha 06/05/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Rodriguez Juan Soraya
Apo.Manc. Recic Paula
Apoderado Kostler Anna Dorothea
Apo.Manc. Claverol Villaplana Francisco
Apo.Manc. Clarke Suzanne Gillian
Apo.Manc. Balint Gabriela

PDF Anuncio nº 203093 de 2014

Datos registrales: T 26015 , F 118, S 8, H M 334005, I/A 31

13

Ago 2013

Nombramientos

Con fecha 13/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Yagnik Vinay
Apoderado Taft Alexander
Apoderado Spangler Herbert
Apoderado Simon Tobias
Apoderado Schmitz Simone
Apoderado Rofe Andrew
Apoderado Kronester Karl Heinz
Apoderado Hernandez Hernandez Raquel
Apoderado Gomez Gomez Noelia
Apoderado Gomez Diez Isabel
Apoderado Geniaux Marion
Apoderado Fernandez Miguez Maria Rosa
Apoderado Coste Fabrice
Apoderado Clarke Suzanne Gillian
Apoderado Brown Hannah
Apoderado Broadway Grant
Apoderado Bingham Paddy

PDF Anuncio nº 371377 de 2013

Datos registrales: T 26115 , F 81, S 8, H M 470730, I/A 7

13

Ago 2013

Nombramientos

Con fecha 13/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Yagnik Vinay
Apoderado Taft Alexander
Apoderado Spangler Herbert
Apoderado Simon Tobias
Apoderado Schmitz Simone
Apoderado Rofe Andrew
Apoderado Kronester Karl Heinz
Apoderado Hernandez Hernandez Raquel
Apoderado Gomez Gomez Noelia
Apoderado Gomez Diez Isabel
Apoderado Geniaux Marion
Apoderado Fernandez Minguez Rosa
Apoderado Coste Fabrice
Apoderado Clarke Suzanne Gillian
Apoderado Brown Hannah
Apoderado Broadway Grant
Apoderado Bingham Paddy

PDF Anuncio nº 371371 de 2013

Datos registrales: T 26035 , F 49, S 8, H M 469312, I/A 8

18

Oct 2012

Nombramientos

Con fecha 18/10/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Domingo Villanueva Marta
Apoderado Clarke Suzanne Gillian
Apoderado Barrachina Masip Oriol

PDF Anuncio nº 443960 de 2012

Datos registrales: T 28673 , F 180, S 8, H M 249434, I/A 47

13

Ene 2011

Nombramientos

Con fecha 13/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Rodriguez Juan Soraya
Apo.Man.Soli Mateu Villanueva Rafael
Apoderado Kitsch-Klocker Ingo
Apo.Man.Soli Claverol Villaplana Francisco
Apo.Man.Soli Clarke Suzanne Gillian

PDF Anuncio nº 30168 de 2011

Datos registrales: T 26015 , F 116, S 8, H M 334005, I/A 26

12

Ene 2011

Nombramientos

Con fecha 12/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Rodriguez Juan Soraya
Apoderado Mateu Villanueva Rafael
Apoderado Clarke Suzanne Gillian

PDF Anuncio nº 27031 de 2011

Datos registrales: T 26015 , F 114, S 8, H M 334005, I/A 25

20

Dic 2010

Nombramientos

Con fecha 20/12/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Gomez Lafuente Maria Dunia
Apo.Man.Soli Garrido Rodriguez Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Clarke Suzanne Gillian
Apo.Man.Soli Barrachina Massip Oriol

PDF Anuncio nº 486285 de 2010

Datos registrales: T 20032 , F 169, S 8, H M 34794, I/A 28

15

Jun 2010

Nombramientos

Con fecha 15/06/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Rodriguez Juan Soraya
Apo.Manc. Folek Joanna Barbara
Apo.Manc. Claverol Villaplana Francisco
Apo.Manc. Clarke Suzanne Gillian
Apo.Manc. Balint Gabriela

PDF Anuncio nº 251961 de 2010

Datos registrales: T 26015 , F 113, S 8, H M 334005, I/A 24

03

Mar 2010

Nombramientos

Con fecha 03/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Rodriguez Juan Soraya
Apoderado Claverol Villaplana Francisco
Apoderado Clarke Suzanne Gillian

PDF Anuncio nº 108059 de 2010

Datos registrales: T 26015 , F 111, S 8, H M 334005, I/A 22

29

Sep 2009

Nombramientos

Con fecha 29/09/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Rodriguez Juan Soraya
Apoderado Claverol Villaplana Francisco
Apoderado Clarke Suzanne Gillian

PDF Anuncio nº 425868 de 2009

Datos registrales: T 26015 , F 111, S 8, H M 334005, I/A 21

11

May 2009

Nombramientos

Con fecha 11/05/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Rodriguez Juan Soraya
Apoderado Claverol Villaplana Francesc
Apoderado Clarke Suzanne Gillian

PDF Anuncio nº 233644 de 2009

Datos registrales: T 26015 , F 110, S 8, H M 334005, I/A 20

25

Mar 2009

Revocaciones

Con fecha 25/03/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Rodriguez Juan Soraya
Apoderado Domingo Villanueva Marta
Apoderado Clarke Suzanne Gillian

PDF Anuncio nº 167971 de 2009

Datos registrales: T 26015 , F 110, S 8, H M 334005, I/A 19

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2022-37-28 Madrid 23/02/2022
PDF BORME-A-2020-209-28 Madrid 28/10/2020
PDF BORME-A-2017-192-28 Madrid 06/10/2017
PDF BORME-A-2016-3-28 Madrid 07/01/2016
PDF BORME-A-2015-221-28 Madrid 19/11/2015
PDF BORME-A-2015-25-28 Madrid 06/02/2015
PDF BORME-A-2014-90-28 Madrid 14/05/2014
PDF BORME-A-2013-158-28 Madrid 21/08/2013
PDF BORME-A-2012-209-28 Madrid 30/10/2012
PDF BORME-A-2011-16-28 Madrid 25/01/2011
PDF BORME-A-2011-15-28 Madrid 24/01/2011
PDF BORME-A-2010-249-28 Madrid 30/12/2010
PDF BORME-A-2010-119-28 Madrid 24/06/2010
PDF BORME-A-2010-50-28 Madrid 15/03/2010
PDF BORME-A-2009-194-28 Madrid 09/10/2009
PDF BORME-A-2009-95-28 Madrid 22/05/2009
PDF BORME-A-2009-65-28 Madrid 06/04/2009

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret