info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 0
Cargos no vigentes 8
Apariciones en BORME 14
Cargos directivos en empresas
Esta persona no tiene ningún cargo en la actualidad, o no hay datos disponibles.
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
APOD.MANCOMU Trivalor Xxi SL 05/10/2016 09/05/2018
APOD.SOL/MAN Trivalor Xxi SL 11/02/2016 20/04/2018
APOD.MANCOMU Trivalor Xxi SL 11/07/2016 20/04/2018
APOD.MANCOMU Mandarin Oriental Spain SL 27/01/2016 20/04/2018
APODERADO Trivalor Xxi SL 24/05/2013 27/01/2016
APODERADO Mandarin Oriental Spain SL 08/02/2011 27/01/2016
APODERADO Mandarin Oriental Spain SL 03/12/2010 27/01/2016
APODERADO Mandarin Oriental Spain SL 30/12/2009 08/09/2014
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Bayer Raich Maria Montserrat .

09

May 2018

Revocaciones

Con fecha 09/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Rochina Belenguer Sylvia
APOD.MANCOMU Philippe Alexandre Protto
APOD.MANCOMU Gregory Bruce Liddell
APOD.MANCOMU Christoph Joseph Wilhelm Mares
APOD.MANCOMU Bayer Raich Maria Montserrat
APOD.MANCOMU Andre Paul Raymond Devillers

PDF Anuncio nº 207254 de 2018

Datos registrales: T 45194 , F 15, S 8, H B 291774, I/A 26

20

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 20/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Rochina Belenguer Sylvia
APOD.MANCOMU Philippe Alexandre Protto
APOD.MANCOMU Gregory Bruce Liddell
APOD.MANCOMU Christoph Joseph Wilhelm Mares
APOD.MANCOMU Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 184656 de 2018

Datos registrales: T 42270 , F 7, S 8, H B 298113, I/A 27

20

Abr 2018

Revocaciones

Con fecha 20/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.SOL/MAN Sylvia Rochina Belenguer
APOD.SOL/MAN Philippe Alexandre Protto
APOD.MANCOMU Gregory Bruce Liddell
APOD.SOL/MAN Christoph Joseph Wilhelm Mares
APOD.SOL/MAN Bayer Raich Maria Montserrat
APOD.MANCOMU Andre Paul Raymond Devillers

PDF Anuncio nº 184655 de 2018

Datos registrales: T 45194 , F 14, S 8, H B 291774, I/A 25

05

Oct 2016

Nombramientos

Con fecha 05/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Rochina Belenguer Sylvia
APOD.MANCOMU Philippe Alexandre Protto
APOD.MANCOMU Gregory Bruce Liddell
APOD.MANCOMU Christoph Joseph Wilhelm Mares
APOD.MANCOMU Bayer Raich Maria Montserrat
APOD.MANCOMU Andre Paul Raymond Devillers

PDF Anuncio nº 414161 de 2016

Datos registrales: T 45194 , F 13, S 8, H B 291774, I/A 21

11

Jul 2016

Nombramientos

Con fecha 11/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Sylvia Rochina Belenguer
APOD.MANCOMU Philippe Alexandre Protto
APOD.MANCOMU Gregory Bruce Liddell
APOD.MANCOMU Christoph Joseph Wilhelm Mares
APOD.MANCOMU Bayer Raich Maria Montserrat
APOD.MANCOMU Andre Paul Raymond Devillers

PDF Anuncio nº 299575 de 2016

Datos registrales: T 45194 , F 12, S 8, H B 291774, I/A 20

11

Feb 2016

Nombramientos

Con fecha 11/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.SOL/MAN Sylvia Rochina Belenguer
APOD.SOL/MAN Philippe Alexandre Protto
APOD.SOL/MAN Gregory Bruce Liddell
APOD.SOL/MAN Christoph Joseph Wilhelm Mares
APOD.SOL/MAN Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 71153 de 2016

Datos registrales: T 42405 , F 215, S 8, H B 291774, I/A 17

27

Ene 2016

Nombramientos

Con fecha 27/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APOD.MANCOMU Rochina Belenguer Sylvia
APOD.MANCOMU Philippe Alexandre Protto
APOD.MANCOMU Gregory Bruce Liddell
APOD.MANCOMU Christoph Joseph Wilhelm Mares
APOD.MANCOMU Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 45883 de 2016

Datos registrales: T 42270 , F 5, S 8, H B 298113, I/A 25

27

Ene 2016

Revocaciones

Con fecha 27/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Rochina Belenguer Silvia
APODERAD.SOL Gregory Bruce Liddell
APODERADO Gerard Sintes
APODERADO Christoph Joseph Wilhelm Mares
APODERADO Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 45883 de 2016

Datos registrales: T 42270 , F 5, S 8, H B 298113, I/A 25

27

Ene 2016

Revocaciones

Con fecha 27/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Rochina Belenguer Sylvia
APODERADO Michel Checoury
APODERADO Gerard Sintes
APODERADO Christoph Joseph Wilhelm Mares
APODERADO Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 45882 de 2016

Datos registrales: T 42405 , F 215, S 8, H B 291774, I/A 16

08

Sep 2014

Revocaciones

Con fecha 08/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Vincent Studer
APODERADO Rochina Belenguer Silvia
APODERADO Michel Checoury
APODERADO Christoph Joseph Wilhelm Mares
APODERADO Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 366247 de 2014

Datos registrales: T 42270 , F 4, S 8, H B 298113, I/A 23

24

May 2013

Nombramientos

Con fecha 24/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Vincent Studer
APODERADO Rochina Belenguer Sylvia
APODERADO Michel Checoury
APODERADO Gerard Sintes
APODERADO Christoph Joseph Wilhelm Mares
APODERADO Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 252582 de 2013

Datos registrales: T 42405 , F 214, S 8, H B 291774, I/A 12

08

Feb 2011

Nombramientos

Con fecha 08/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Rochina Belenguer Silvia
APODERADO Michel Checoury
APODERADO Granda Gallego Ignacio
APODERADO Gerard Sintes
APODERADO Christoph Joseph Wilhelm Mares
APODERADO Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 73976 de 2011

Datos registrales: T 42270 , F 1, S 8, H B 298113, I/A 20

03

Dic 2010

Nombramientos

Con fecha 03/12/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Rolf David Salomon
APODERADO Rochina Belenguer Silvia
APODERADO Michel Checoury
APODERADO Gerard Sintes
APODERADO Christoph Joseph Wilhelm Mares
APODERADO Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 465921 de 2010

Datos registrales: T 40320 , F 90, S 8, H B 298113, I/A 18

30

Dic 2009

Nombramientos

Con fecha 30/12/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
APODERADO Rolf David Salomon
APODERADO Rochina Belenguer Silvia
APODERADO Michel Checoury
APODERADO Marco Vilar Luis
APODERADO Christoph Joseph Wilhelm Mares
APODERADO Bayer Raich Maria Montserrat

PDF Anuncio nº 12117 de 2010

Datos registrales: T 40320 , F 87, S 8, H B 298113, I/A 14

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2018-93-08 Barcelona 17/05/2018
PDF BORME-A-2018-82-08 Barcelona 27/04/2018
PDF BORME-A-2016-197-08 Barcelona 14/10/2016
PDF BORME-A-2016-137-08 Barcelona 19/07/2016
PDF BORME-A-2016-32-08 Barcelona 17/02/2016
PDF BORME-A-2016-22-08 Barcelona 03/02/2016
PDF BORME-A-2014-175-08 Barcelona 15/09/2014
PDF BORME-A-2013-102-08 Barcelona 03/06/2013
PDF BORME-A-2011-34-08 Barcelona 18/02/2011
PDF BORME-A-2010-241-08 Barcelona 20/12/2010
PDF BORME-A-2010-8-08 Barcelona 14/01/2010

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret