Última actualización: 4 de Abril de 2016
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 8 años |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A28185072 |
Provincia | Castellón |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Watanabe Shinobu | 26/07/2011 | 04/04/2016 |
Apoderado | Sanjuanbenito Bonal Jaime | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apo.Manc. | Sanjuanbenito Bonal Jaime | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apo.Man.Soli | Pujol Sanchez Jose Luis | 14/01/2016 | 04/04/2016 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 03/09/2010 | 04/04/2016 |
Apo.Man.Soli | Porras Torres Jeronimo | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apo.Sol. | Pires Serra Pedro Michael | 14/01/2016 | 04/04/2016 |
Consejero | Nango Saburo | 25/07/2013 | 04/04/2016 |
Apo.Man.Soli | Miñano Medrano Juan Luis | 14/01/2016 | 04/04/2016 |
Apo.Man.Soli | Mateu Jaimejuan Sergio | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apo.Sol. | Lara Fernandez Javier | 14/01/2016 | 04/04/2016 |
Apo.Man.Soli | Iglesias Nebreda Jose Ignacio | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apo.Man.Soli | Hormann Frank | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apoderado | Fullera Almela Jose Luis | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apoderado | Fortanet Iranzo Jose Alberto | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apo.Sol. | Del Mazo Cabeza Virginia | 14/01/2016 | 04/04/2016 |
Consejero | De Bievre Bruno | 26/07/2011 | 04/04/2016 |
Apo.Manc. | Costa Vaya Victor Ignacio | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apo.Man.Soli | Barroso Martin Jose-Luis | 22/09/2015 | 04/04/2016 |
Apo.Sol. | Artal Bañon Maria Del Rocio | 14/01/2016 | 04/04/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Ube Chemical Europe SA.
04
Abr 2016
Con fecha 04/04/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 771, L 338, F 142, S 8, H CS 9309, I/A 97
04
Abr 2016
Con fecha 04/04/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 771, L 338, F 142, S 8, H CS 9309, I/A 97
21
Mar 2016
Con fecha 21/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Fortanet Iranzo Jose Alberto |
Datos registrales: T 771, L 338, F 142, S 8, H CS 9309, I/A 96
14
Ene 2016
Con fecha 14/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Sansano Colomer Jose |
Apo.Sol. | Pires Serra Pedro Michael |
Apo.Sol. | Lara Fernandez Javier |
Apo.Sol. | Kruger Mark |
Apo.Sol. | Del Mazo Cabeza Virginia |
Apo.Sol. | Bucchioni Nicola |
Apo.Sol. | Artal Bañon Maria Del Rocio |
Datos registrales: T 771, L 338, F 141, S 8, H CS 9309, I/A 95
14
Ene 2016
Con fecha 14/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Pujol Sanchez Jose Luis |
Apo.Man.Soli | Miñano Medrano Juan Luis |
Apo.Man.Soli | Biosca Barba Jose Antonio |
Datos registrales: T 771, L 338, F 141, S 8, H CS 9309, I/A 94
14
Ene 2016
Con fecha 14/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Pujol Sanchez Jose Luis |
Apoderado | Biosca Barba Jose Antonio |
Datos registrales: T 771, L 338, F 140, S 8, H CS 9309, I/A 93
25
Nov 2015
Con fecha 25/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Fortanet Iranzo Jose Alberto |
Datos registrales: T 771, L 338, F 140, S 8, H CS 9309, I/A 92
02
Nov 2015
Con fecha 02/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Porras Torres Jeronimo |
Apo.Sol. | Morimoto Katsuji |
Apo.Man.Soli | Monferrer Tomas Tomas Javier |
Apo.Man.Soli | Loyarte Salazar Daniel |
Apo.Man.Soli | Konishi Mikako |
Apo.Sol. | De Bievre Bruno Elizabeth Paul |
Apo.Sol. | Barroso Martin Jose-Luis |
Datos registrales: T 771, L 338, F 140, S 8, H CS 9309, I/A 91
02
Nov 2015
Con fecha 02/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Olmeda Pinedo Ana Belen |
Apo.Man.Soli | Mateu Jaimejuan Sergio |
Datos registrales: T 771, L 338, F 140, S 8, H CS 9309, I/A 90
02
Nov 2015
Con fecha 02/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanjuanbenito Bonal Jaime |
Datos registrales: T 771, L 338, F 140, S 8, H CS 9309, I/A 89
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanjuanbenito Bonal Jaime |
Datos registrales: T 771, L 338, F 138, S 8, H CS 9309, I/A 88
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Fortanet Iranzo Jose Alberto |
Datos registrales: T 771, L 338, F 138, S 8, H CS 9309, I/A 87
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Costa Vaya Victor Ignacio |
Datos registrales: T 771, L 338, F 137, S 8, H CS 9309, I/A 86
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Pujol Sanchez Jose Luis |
Datos registrales: T 771, L 338, F 136, S 8, H CS 9309, I/A 85
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Biosca Barba Jose Antonio |
Datos registrales: T 771, L 338, F 136, S 8, H CS 9309, I/A 84
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Iglesias Nebreda Jose Ignacio |
Apo.Man.Soli | Hormann Frank |
Apo.Man.Soli | Barroso Martin Jose-Luis |
Datos registrales: T 771, L 338, F 136, S 8, H CS 9309, I/A 83
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Olmeda Pinedo Ana Belen |
Apo.Man.Soli | Monferrer Tomas Tomas Javier |
Apo.Man.Soli | Mateu Jaimejuan Sergio |
Apo.Man.Soli | Loyarte Salazar Daniel |
Apo.Man.Soli | Konishi Mikako |
Datos registrales: T 771, L 338, F 135, S 8, H CS 9309, I/A 82
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Fullera Almela Jose Luis |
Datos registrales: T 771, L 338, F 134, S 8, H CS 9309, I/A 81
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Porras Torres Jeronimo |
Apo.Man.Soli | Morimoto Katsuji |
Datos registrales: T 771, L 338, F 131, S 8, H CS 9309, I/A 80
24
Feb 2015
Con fecha 24/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Olmeda Pinedo Ana Belen |
Apoderado | Monferrer Tomas Tomas Javier |
Apo.Man.Soli | Mateu Jaimejuan Sergio |
Datos registrales: T 771, L 338, F 131, S 8, H CS 9309, I/A 78
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2016-68-12 | Castellón | 11/04/2016 | |
BORME-A-2016-64-12 | Castellón | 05/04/2016 | |
BORME-A-2016-17-12 | Castellón | 27/01/2016 | |
BORME-A-2016-16-12 | Castellón | 26/01/2016 | |
BORME-A-2015-230-12 | Castellón | 02/12/2015 | |
BORME-A-2015-218-12 | Castellón | 16/11/2015 | |
BORME-A-2015-186-12 | Castellón | 29/09/2015 | |
BORME-A-2015-44-12 | Castellón | 05/03/2015 | |
BORME-A-2015-42-12 | Castellón | 03/03/2015 | |
BORME-A-2014-230-12 | Castellón | 02/12/2014 | |
BORME-A-2014-202-12 | Castellón | 22/10/2014 | |
BORME-A-2014-201-12 | Castellón | 21/10/2014 | |
BORME-A-2014-141-12 | Castellón | 28/07/2014 | |
BORME-A-2014-90-12 | Castellón | 14/05/2014 | |
BORME-A-2014-43-12 | Castellón | 04/03/2014 | |
BORME-A-2014-33-12 | Castellón | 18/02/2014 | |
BORME-A-2013-144-12 | Castellón | 31/07/2013 | |
BORME-A-2013-88-12 | Castellón | 13/05/2013 | |
BORME-A-2012-223-12 | Castellón | 21/11/2012 | |
BORME-A-2012-207-12 | Castellón | 26/10/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades