Última actualización: 22 de Febrero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A78857448 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Camilo Jose Cela 7 (Torrejon De Ardoz). |
Capital social | 2.450.007,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 13/12/2021 | Actualidad |
Adm. Unico | Montelatici Marcela | 10/12/2021 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 02/12/2020 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 25/02/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Sanchez Mahon Juan Manuel | 12/09/2018 | Actualidad |
Apo.Manc. | Gervais De Lafond Jean Rene | 12/09/2018 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 19/06/2018 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 15/02/2018 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 24/10/2016 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 29/06/2015 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 28/07/2014 | Actualidad |
Apo.Sol. | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 03/08/2011 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 03/08/2011 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Gervais De Lafond Jean Rene | 22/10/2013 | 13/02/2024 |
Apoderado | Gerhild Straube Andrea | 22/10/2013 | 13/02/2024 |
Adm. Unico | Gross Reinhold Michael | 12/02/2018 | 10/12/2021 |
Apoderado | Kranch Detlef Christian | 22/10/2013 | 10/06/2021 |
Apoderado | Gervais De Lafond Jean Rene | 22/10/2013 | 10/06/2021 |
Apoderado | Gerhild Straube Andrea | 22/10/2013 | 10/06/2021 |
Apoderado | Bedon Terradez Luis | 22/10/2013 | 10/06/2021 |
Apo.Manc. | Kranich Detlef Christian | 25/10/2016 | 12/09/2018 |
Apo.Manc. | Gervais De Lafond Jean Rene | 25/10/2016 | 12/09/2018 |
Adm. Unico | Rubling Gerhard Willy | 29/06/2015 | 15/09/2017 |
Apoderado | Kranich Detlef Christian | 30/08/2010 | 25/10/2016 |
Apo.Manc. | Kranch Detlef Christian | 11/06/2014 | 25/10/2016 |
Apo.Manc. | Gervais De Lafond Jean Rene | 11/06/2014 | 25/10/2016 |
Adm. Unico | Kammuller Mathias Albrecht | 03/08/2011 | 29/06/2015 |
Apoderado | Bedon Terradez Luis | Desconocido | 22/10/2013 |
Consejero | Rubling Gerhard Willy | 30/08/2010 | 03/08/2011 |
SecreNoConsj | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 30/08/2010 | 03/08/2011 |
Cons.Del.Sol | Dieter Siegmund Klaus | Desconocido | 03/08/2011 |
Presidente | Bleher Jens Heiko | Desconocido | 03/08/2011 |
Con.Delegado | Bleher Jens Heiko | Desconocido | 03/08/2011 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Trumpf Maquinaria SA.
22
Feb 2024
Con fecha 22/02/2024, la sociedad cambia su domicilio social a C/ CAMILO JOSE CELA 7 (TORREJON DE ARDOZ).
Datos registrales: T 38134 , F 221, S 8, H M 84036, I/A 53
13
Feb 2024
Con fecha 13/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gervais De Lafond Jean Rene |
Apoderado | Gerhild Straube Andrea |
Datos registrales: T 38134 , F 221, S 8, H M 84036, I/A 52
13
Dic 2021
Con fecha 13/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 38134 , F 221, S 8, H M 84036, I/A 51
10
Dic 2021
Con fecha 10/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Montelatici Marcela |
Datos registrales: T 38134 , F 220, S 8, H M 84036, I/A 50
10
Dic 2021
Con fecha 10/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Gross Reinhold Michael |
Datos registrales: T 38134 , F 220, S 8, H M 84036, I/A 50
10
Jun 2021
Con fecha 10/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Kranch Detlef Christian |
Apoderado | Gervais De Lafond Jean Rene |
Apoderado | Gerhild Straube Andrea |
Apoderado | Bedon Terradez Luis |
Datos registrales: T 38134 , F 220, S 8, H M 84036, I/A 49
02
Dic 2020
Con fecha 02/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 38134 , F 220, S 8, H M 84036, I/A 48
25
Feb 2020
Con fecha 25/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 38134 , F 220, S 8, H M 84036, I/A 47
12
Sep 2018
Con fecha 12/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Sanchez Mahon Juan Manuel |
Apo.Manc. | Gervais De Lafond Jean Rene |
Datos registrales: T 25106 , F 207, S 8, H M 84036, I/A 46
12
Sep 2018
Con fecha 12/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Kranich Detlef Christian |
Apo.Manc. | Gervais De Lafond Jean Rene |
Datos registrales: T 25106 , F 207, S 8, H M 84036, I/A 46
19
Jun 2018
Con fecha 19/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 25106 , F 207, S 8, H M 84036, I/A 45
15
Feb 2018
Con fecha 15/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 25106 , F 207, S 8, H M 84036, I/A 44
12
Feb 2018
Con fecha 12/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Gross Reinhold Michael |
Datos registrales: T 25106 , F 206, S 8, H M 84036, I/A 43
15
Sep 2017
Con fecha 15/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Rubling Gerhard Willy |
Datos registrales: T 25106 , F 206, S 8, H M 84036, I/A 42
25
Oct 2016
Con fecha 25/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Kranich Detlef Christian |
Apo.Manc. | Gervais De Lafond Jean Rene |
Datos registrales: T 25106 , F 206, S 8, H M 84036, I/A 41
25
Oct 2016
Con fecha 25/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Kranich Detlef Christian |
Apo.Manc. | Kranch Detlef Christian |
Apo.Manc. | Gervais De Lafond Jean Rene |
Datos registrales: T 25106 , F 206, S 8, H M 84036, I/A 41
24
Oct 2016
Con fecha 24/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 25106 , F 205, S 8, H M 84036, I/A 40
29
Jun 2015
Con fecha 29/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 25106 , F 205, S 8, H M 84036, I/A 39
29
Jun 2015
Con fecha 29/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Rubling Gerhard Willy |
Datos registrales: T 25106 , F 205, S 8, H M 84036, I/A 39
29
Jun 2015
Con fecha 29/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Kammuller Mathias Albrecht |
Datos registrales: T 25106 , F 205, S 8, H M 84036, I/A 39
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-43-28 | Madrid | 29/02/2024 | |
BORME-A-2024-36-28 | Madrid | 20/02/2024 | |
BORME-A-2021-241-28 | Madrid | 20/12/2021 | |
BORME-A-2021-114-28 | Madrid | 17/06/2021 | |
BORME-A-2020-237-28 | Madrid | 11/12/2020 | |
BORME-A-2020-43-28 | Madrid | 03/03/2020 | |
BORME-A-2018-181-28 | Madrid | 19/09/2018 | |
BORME-A-2018-180-28 | Madrid | 18/09/2018 | |
BORME-A-2018-122-28 | Madrid | 27/06/2018 | |
BORME-A-2018-38-28 | Madrid | 22/02/2018 | |
BORME-A-2018-36-28 | Madrid | 20/02/2018 | |
BORME-A-2017-182-28 | Madrid | 22/09/2017 | |
BORME-A-2016-211-28 | Madrid | 04/11/2016 | |
BORME-A-2016-210-28 | Madrid | 03/11/2016 | |
BORME-A-2015-126-28 | Madrid | 07/07/2015 | |
BORME-A-2014-148-28 | Madrid | 06/08/2014 | |
BORME-A-2014-115-28 | Madrid | 20/06/2014 | |
BORME-A-2013-209-28 | Madrid | 31/10/2013 | |
BORME-A-2013-145-28 | Madrid | 01/08/2013 | |
BORME-A-2013-86-28 | Madrid | 09/05/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades