Última actualización: 16 de Mayo de 2013
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 10 años, 11 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | B08958381 |
Denominación anterior | Prysmian Cables Y Sistemas SL |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 15.000.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECRETARIO | Zorraquino Asunsolo Javier | 21/07/2010 | 16/05/2013 |
CONSEJERO | Zorraquino Asunsolo Javier | 21/07/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Zorraquino Asunsolo Javier | 29/09/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Torne Reverter Lluis | 29/09/2010 | 16/05/2013 |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 20/05/2011 | 16/05/2013 |
CONSEJERO | Pier Francesco Facchini | 21/07/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Nolla Magriña Francesc | 29/09/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Javier Eduardo Antista | 29/09/2010 | 16/05/2013 |
CONSEJERO | Giovanni Zancan | 21/07/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Ferran Fonts Joan | 29/09/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Cunille Shaadi Fernando | 04/05/2011 | 16/05/2013 |
CONSEJERO | Calvo Rovira Jordi | 21/07/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Calvo Rovira Jordi | 23/01/2013 | 16/05/2013 |
APODERADO | Bosch Guilamany Antoni | 29/09/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Batlle Ferrer Jose Maria | 04/10/2012 | 16/05/2013 |
CONSEJERO | Alessandro Benuzzi | 18/10/2011 | 16/05/2013 |
PRESIDENTE | Acin Jover Francesc Xavier | 23/01/2013 | 16/05/2013 |
CONSEJERO | Acin Jover Francesc Xavier | 21/07/2010 | 16/05/2013 |
APODERADO | Acin Jover Francesc Xavier | 23/04/2010 | 16/05/2013 |
AUDT.CTS.CON | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 20/05/2011 | 28/02/2013 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Prysmian Cables Y Sistemas SA.
16
May 2013
Con fecha 16/05/2013 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 42125 , F 195, S 8, H B 19427, I/A 209
28
Feb 2013
Con fecha 28/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDT.CTS.CON | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42125 , F 195, S 8, H B 19427, I/A 208
23
Ene 2013
Con fecha 23/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Calvo Rovira Jordi |
Datos registrales: T 42125 , F 193, S 8, H B 19427, I/A 207
23
Ene 2013
Con fecha 23/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
PRESIDENTE | Acin Jover Francesc Xavier |
Datos registrales: T 42125 , F 193, S 8, H B 19427, I/A 206
23
Ene 2013
Con fecha 23/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
DTOR.GENERAL | Cardona Torrandell Javier |
Datos registrales: T 42125 , F 193, S 8, H B 19427, I/A 206
28
Dic 2012
Con fecha 28/12/2012, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART. 21 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, INICIANDOSE EL DIA 1 DE ENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.
Datos registrales: T 42125 , F 192, S 8, H B 19427, I/A 205
04
Oct 2012
Con fecha 04/10/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Batlle Ferrer Jose Maria |
Datos registrales: T 42125 , F 189, S 8, H B 19427, I/A 204
04
Oct 2012
Con fecha 04/10/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Lopez Muñoz Carlos |
Datos registrales: T 42125 , F 189, S 8, H B 19427, I/A 203
25
Jul 2012
Con fecha 25/07/2012, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART.21 : FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL,INICIANDOSE EL DIA 1 DE JULIO Y FINALIZANDO EL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO.
Datos registrales: T 42125 , F 189, S 8, H B 19427, I/A 202
25
Jul 2012
CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO,NUEVO ACCIONISTA:"DRAKA HOLDING,N.V." Y POSTERIOR CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO,SIENDO EL NUEVO ACCIONISTA:"DRAKA HOLDING NV Y CIA,SOCIEDAD COLECTIVA".
Datos registrales: T 42125 , F 189, S 8, H B 19427, I/A 201
11
Ene 2012
EMISION DE DOS TITULOS MULTIPLES REPRESENTATIVOS DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL.
Datos registrales: T 42125 , F 187, S 8, H B 19427, I/A 200
11
Ene 2012
Con fecha 11/01/2012, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 1.000.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 6.67% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 15.000.000,0€.
Datos registrales: T 42125 , F 187, S 8, H B 19427, I/A 200
11
Ene 2012
DECLARACION DEL CARACTER DE UNIPERSONAL SIENDO EL ACCIONISTA UNICO:"PRYSMIAN CAVI E SISTEMI,SRL".
Datos registrales: T 42125 , F 187, S 8, H B 19427, I/A 199
18
Oct 2011
Con fecha 18/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Alessandro Benuzzi |
Datos registrales: T 42125 , F 187, S 8, H B 19427, I/A 198
20
May 2011
Con fecha 20/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDT.CTS.CON | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42125 , F 186, S 8, H B 19427, I/A 197
04
May 2011
Con fecha 04/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Cunille Shaadi Fernando |
Datos registrales: T 42125 , F 185, S 8, H B 19427, I/A 196
04
May 2011
Con fecha 04/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Cunille Shaadi Fernando |
Datos registrales: T 42125 , F 185, S 8, H B 19427, I/A 196
29
Sep 2010
Con fecha 29/09/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Nolla Magriña Francesc |
Datos registrales: T 42125 , F 178, S 8, H B 19427, I/A 193
29
Sep 2010
Con fecha 29/09/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Javier Eduardo Antista |
Datos registrales: T 42125 , F 172, S 8, H B 19427, I/A 191
29
Sep 2010
Con fecha 29/09/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Zorraquino Asunsolo Javier |
Datos registrales: T 39229 , F 173, S 8, H B 19427, I/A 188
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2013-98-08 | Barcelona | 28/05/2013 |
BORME-A-2013-47-08 | Barcelona | 08/03/2013 |
BORME-A-2013-22-08 | Barcelona | 01/02/2013 |
BORME-A-2013-4-08 | Barcelona | 08/01/2013 |
BORME-A-2012-200-08 | Barcelona | 17/10/2012 |
BORME-A-2012-148-08 | Barcelona | 03/08/2012 |
BORME-A-2012-16-08 | Barcelona | 24/01/2012 |
BORME-A-2011-205-08 | Barcelona | 27/10/2011 |
BORME-A-2011-104-08 | Barcelona | 01/06/2011 |
BORME-A-2011-94-08 | Barcelona | 18/05/2011 |
BORME-A-2010-196-08 | Barcelona | 11/10/2010 |
BORME-A-2010-146-08 | Barcelona | 02/08/2010 |
BORME-A-2010-84-08 | Barcelona | 05/05/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades