Última actualización: 29 de Enero de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 2 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B79823399 |
Provincia | Madrid |
Capital social | 56.818.053,19 euros |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Liquidador | Saraiva Ferrao Martins Paulo Jorge | 29/01/2019 | 29/01/2019 |
Apoderado | Saraiva Ferrao Martins Paulo Jorge | 17/11/2014 | 29/01/2019 |
Consejero | Rigamonti Umberto Silvio | 05/11/2012 | 29/01/2019 |
VsecrNoConsj | Pujol Pamies Alex | Desconocido | 29/01/2019 |
Apoderado | Puertas Carbonell David | 27/01/2011 | 29/01/2019 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 30/01/2014 | 29/01/2019 |
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 27/08/2010 | 29/01/2019 |
Consejero | Notard Xavier Emile N | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
Apoderado | Notard Xavier Emile N | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
Apoderado | Mariani Emilio Lorenzo | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
Apoderado | Jaspar Claire Marie Jose S | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
Apoderado | Janquart Pierre Francois Gerard | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
Apoderado | Escalada Sarabia Jaime | 23/12/2008 | 29/01/2019 |
Consejero | Dagommer Claire Marie Helene | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
Apoderado | Dagommer Claire Marie Helene | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
Apo.Sol. | Dagommer Claire Marie Helene | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
SecreNoConsj | Corbera Dale Ignacio | Desconocido | 29/01/2019 |
Apoderado | Burnotte Alexandre Charles V | 21/06/2017 | 29/01/2019 |
Apoderado | Alvarez Fleitas Daniel | 12/04/2011 | 29/01/2019 |
Apo.Man.Soli | Alvarez Fleitas Daniel | 23/07/2013 | 29/01/2019 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Ocv Reinforcements Alcala Spain SL.
29
Ene 2019
Con fecha 29/01/2019 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 25648 , F 189, S 8, H M 19497, I/A 158
29
Ene 2019
Con fecha 29/01/2019 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 25648 , F 189, S 8, H M 19497, I/A 158
29
Ene 2019
Con fecha 29/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Saraiva Ferrao Martins Paulo Jorge |
Datos registrales: T 25648 , F 189, S 8, H M 19497, I/A 158
29
Ene 2019
Con fecha 29/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Rigamonti Umberto Silvio |
VsecrNoConsj | Pujol Pamies Alex |
Consejero | Notard Xavier Emile N |
Consejero | Dagommer Claire Marie Helene |
SecreNoConsj | Corbera Dale Ignacio |
Datos registrales: T 25648 , F 189, S 8, H M 19497, I/A 158
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rigamonti Umberto Silvio |
Apoderado | Notard Xavier Emile N |
Apoderado | Meesseman Eline Patricia N |
Apoderado | Mariani Emilio Lorenzo |
Apoderado | Jaspar Claire Marie Jose S |
Apoderado | Janquart Pierre Francois Gerard |
Apoderado | Dagommer Claire Marie Helene |
Apoderado | Burnotte Alexandre Charles V |
Datos registrales: T 25648 , F 188, S 8, H M 19497, I/A 157
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rigamonti Umberto Silvio |
Apoderado | N. Notard Xavier Emile |
Apoderado | Meesseman Eline Patricia N |
Apoderado | Mariani Emilio Lorenzo |
Apoderado | Jaspar Claire Marie Jose S |
Apoderado | Janquart Pierre Francois Gerard |
Apoderado | Fraiture Hubert Pierre Joseph F |
Apoderado | Del Monaco Nicolas |
Apoderado | Dagommer Claire Marie Helene |
Apoderado | Burnotte Alexandre Charles V |
Datos registrales: T 25648 , F 188, S 8, H M 19497, I/A 157
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Rigamonti Umberto Silvio |
Apo.Sol. | Notard Xavier Emile N |
Apo.Sol. | Dagommer Claire Marie Helene |
Datos registrales: T 25648 , F 186, S 8, H M 19497, I/A 156
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rigamonti Umberto Silvio |
Apo.Sol. | Rigamonti Umberto |
Apoderado | Fraiture Hubert Pierre Joseph F |
Apoderado | Del Monaco Nicolas |
Datos registrales: T 25648 , F 186, S 8, H M 19497, I/A 156
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Notard Xavier Emile N |
Consejero | Dagommer Claire Marie Helene |
Datos registrales: T 25648 , F 185, S 8, H M 19497, I/A 155
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Fraiture Hubert Pierre Joseph F |
Consejero | Del Monaco Nicolas |
Datos registrales: T 25648 , F 185, S 8, H M 19497, I/A 155
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rigamonti Umberto Silvio |
Apoderado | N. Notard Xavier Emile |
Apoderado | Meesseman Eline Patricia N |
Apoderado | Mariani Emilio Lorenzo |
Apoderado | Jaspar Claire Marie Jose S |
Apoderado | Janquart Pierre Francois Gerard |
Apoderado | Fraiture Hubert Pierre Joseph F |
Apoderado | Del Monaco Nicolas |
Apoderado | Dagommer Claire Marie Helene |
Apoderado | Burnotte Alexandre Charles V |
Datos registrales: T 25648 , F 185, S 8, H M 19497, I/A 154
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Puertas Carbonell David |
Apo.Man.Soli | N. Notard Xavier Emile |
Apo.Man.Soli | Lorenzo Mariani Emilio |
Apo.Man.Soli | Jaspar Claire Marie Jose S |
Apo.Man.Soli | Fraiture Hubert Pierre Joseph F |
Apo.Man.Soli | Dagommer Claire Marie Helene |
Apo.Man.Soli | Burnotte Alexandre Charles V |
Datos registrales: T 25648 , F 185, S 8, H M 19497, I/A 154
30
Jun 2016
Con fecha 30/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 25648 , F 184, S 8, H M 19497, I/A 153
30
May 2016
Con fecha 30/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Puertas Carbonell David |
Apo.Man.Soli | N. Notard Xavier Emile |
Apo.Man.Soli | Lorenzo Mariani Emilio |
Apo.Man.Soli | Jaspar Claire Marie Jose S |
Apo.Man.Soli | Fraiture Hubert Pierre Joseph F |
Apo.Man.Soli | Dagommer Claire Marie Helene |
Apo.Man.Soli | Burnotte Alexandre Charles V |
Datos registrales: T 25648 , F 183, S 8, H M 19497, I/A 152
30
May 2016
Con fecha 30/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Puertas Carbonell David |
Apo.Man.Soli | N. Notard Xavier Emile |
Apo.Man.Soli | Jaspar Claire Marie Jose S |
Apo.Man.Soli | Jackle Markus Sven |
Apo.Man.Soli | Fraiture Hubert Pierre Joseph F |
Apo.Man.Soli | Dagommer Claire Marie Helene |
Datos registrales: T 25648 , F 183, S 8, H M 19497, I/A 152
09
May 2016
Adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.
Datos registrales: T 25648 , F 182, S 8, H M 19497, I/A 151
29
May 2015
Con fecha 29/05/2015, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 44.999.995,2 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 380.77% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 56.818.053,19€.
Datos registrales: T 25648 , F 181, S 8, H M 19497, I/A 150
13
Mar 2015
Con fecha 13/03/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Molcalvillo Miguel Ana Maria |
Apoderado | Melguizo Herreros Vanesa |
Apo.Man.Soli | Lozano Arenal Maria Belen |
Apoderado | Gonzalez Lopez Maria Asuncion |
Apo.Sol. | Genis Arnaud Pierre |
Apoderado | Garcia Albertos Perez Julio |
Apoderado | Cuesta Civis Yago |
Apoderado | Calle Villaverde Francisco |
Apoderado | Alvarez Garcia Jose |
Datos registrales: T 25648 , F 181, S 8, H M 19497, I/A 149
17
Nov 2014
Con fecha 17/11/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Saraiva Ferrao Martins Paulo Jorge |
Datos registrales: T 25648 , F 180, S 8, H M 19497, I/A 148
13
Nov 2014
Con fecha 13/11/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 25648 , F 180, S 8, H M 19497, I/A 147
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2019-24-28 | Madrid | 05/02/2019 | |
BORME-A-2017-122-28 | Madrid | 29/06/2017 | |
BORME-A-2016-130-28 | Madrid | 08/07/2016 | |
BORME-A-2016-106-28 | Madrid | 06/06/2016 | |
BORME-A-2016-92-28 | Madrid | 17/05/2016 | |
BORME-A-2015-106-28 | Madrid | 09/06/2015 | |
BORME-A-2015-56-28 | Madrid | 24/03/2015 | |
BORME-A-2014-225-28 | Madrid | 25/11/2014 | |
BORME-A-2014-223-28 | Madrid | 21/11/2014 | |
BORME-A-2014-106-28 | Madrid | 06/06/2014 | |
BORME-A-2014-26-28 | Madrid | 07/02/2014 | |
BORME-A-2013-146-28 | Madrid | 02/08/2013 | |
BORME-A-2013-145-28 | Madrid | 01/08/2013 | |
BORME-A-2013-143-28 | Madrid | 30/07/2013 | |
BORME-A-2013-40-28 | Madrid | 27/02/2013 | |
BORME-A-2013-23-28 | Madrid | 04/02/2013 | |
BORME-A-2012-220-28 | Madrid | 16/11/2012 | |
BORME-A-2012-34-28 | Madrid | 17/02/2012 | |
BORME-A-2012-16-28 | Madrid | 24/01/2012 | |
BORME-A-2011-199-28 | Madrid | 19/10/2011 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades