Última actualización: 31 de Octubre de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 5 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A82193178 |
Denominación anterior | Nidera Agrocomercial SA |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Via De Las Dos Castillas 33 - Edificio Atica Iii, (Pozuelo De Alarcon). |
Capital social | 19.000.000,0 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Secretario | Toston Diez Lucia Del Pilar | 15/02/2016 | 31/10/2018 |
Presidente | Sepulveda Diaz-Maroto Antonio | 21/06/2017 | 31/10/2018 |
Presidente | Sepulveda Diaz-Maroto Antonio | 04/07/2018 | 31/10/2018 |
Apo.Manc. | Sepulveda Diaz-Maroto Antonio | 21/06/2017 | 31/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Sepulveda Diaz-Maroto Antonio | 04/07/2017 | 31/10/2018 |
Apoderado | Pina Crespo Carlos | 15/02/2016 | 31/10/2018 |
Apoderado | Peinado Guerra Ana Belen | 15/02/2016 | 31/10/2018 |
Consejero | Martins Marcelo Luis Bianchini | 02/11/2017 | 31/10/2018 |
Apoderado | Marin Loriente Olga | 15/02/2016 | 31/10/2018 |
Consejero | Lodge Timothy Ralph Henry | 21/06/2017 | 31/10/2018 |
Apo.Man.Soli | Lodge Timothy Ralph Henry | 28/04/2017 | 31/10/2018 |
Apoderado | Figueroa Mato Antonio | 15/02/2016 | 31/10/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 09/05/2016 | 31/10/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 28/08/2014 | 31/10/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 23/11/2011 | 31/10/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 24/03/2017 | 31/10/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 06/02/2009 | 31/10/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 09/05/2016 | 31/10/2018 |
Apoderado | Conti Marina | 15/02/2016 | 31/10/2018 |
Apo.Manc. | Barreiro Perez Pardo Fernando | 21/06/2017 | 31/10/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Cofco International Agrocomercial SA.
31
Oct 2018
Con fecha 31/10/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 36421 , F 212, S 8, H M 224903, I/A 72
31
Oct 2018
Con fecha 31/10/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 36421 , F 212, S 8, H M 224903, I/A 72
04
Jul 2018
Con fecha 04/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Sepulveda Diaz-Maroto Antonio |
Consejero | Barreiro Perez Pardo Fernando |
Datos registrales: T 36421 , F 212, S 8, H M 224903, I/A 71
11
Abr 2018
Con fecha 11/04/2018, la sociedad cambia su denominación social a COFCO INTERNATIONAL AGROCOMERCIAL SA
Datos registrales: T 36421 , F 211, S 8, H M 224903, I/A 70
02
Nov 2017
Con fecha 02/11/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Martins Marcelo Luis Bianchini |
Datos registrales: T 28307 , F 34, S 8, H M 224903, I/A 68
02
Nov 2017
Con fecha 02/11/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Lodge Timothy Ralph Henry |
Datos registrales: T 28307 , F 34, S 8, H M 224903, I/A 68
02
Nov 2017
Con fecha 02/11/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 28307 , F 34, S 8, H M 224903, I/A 67
26
Sep 2017
Con fecha 26/09/2017, la sociedad cambia su domicilio social a VIA DE LAS DOS CASTILLAS 33 - EDIFICIO ATICA III, (POZUELO DE ALARCON).
Datos registrales: T 28307 , F 34, S 8, H M 224903, I/A 66
21
Ago 2017
Con fecha 21/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Lodge Timothy Ralph Henry |
Datos registrales: T 28307 , F 34, S 8, H M 224903, I/A 65
04
Jul 2017
Con fecha 04/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sepulveda Diaz-Maroto Antonio |
Apo.Man.Soli | Martinez Bernal Paulino |
Datos registrales: T 28307 , F 32, S 8, H M 224903, I/A 64
04
Jul 2017
Con fecha 04/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Mayer Wolf Alejandro Felix |
Apoderado | Arroyo Hemmerling Mario |
Datos registrales: T 28307 , F 32, S 8, H M 224903, I/A 64
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Lodge Timothy Ralph Henry |
Datos registrales: T 28307 , F 30, S 8, H M 224903, I/A 63
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Sepulveda Diaz-Maroto Antonio |
Apo.Manc. | Barreiro Perez Pardo Fernando |
Datos registrales: T 28307 , F 30, S 8, H M 224903, I/A 63
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Mayer Wolf Alejandro Felix |
Apo.Man.Soli | Conti Marina |
Datos registrales: T 28307 , F 30, S 8, H M 224903, I/A 63
21
Jun 2017
Con fecha 21/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mayer Wolf Alejandro Felix |
Con.Delegado | Lodge Timothy Ralph Henry |
Consejero | Conti Marina |
Datos registrales: T 28307 , F 30, S 8, H M 224903, I/A 63
28
Abr 2017
Con fecha 28/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mayer Wolf Alejandro Felix |
Vicepresid. | Lodge Timothy Ralph Henry |
Apo.Man.Soli | Conti Marina |
Datos registrales: T 28307 , F 28, S 8, H M 224903, I/A 62
28
Abr 2017
Con fecha 28/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Overheu Dierk |
Apo.Man.Soli | Mayer Wolf Alejandro Felix |
Apo.Man.Soli | Conti Marina |
Datos registrales: T 28307 , F 28, S 8, H M 224903, I/A 62
28
Abr 2017
Con fecha 28/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicepresid. | Overheu Dierk |
Consejero | Mayer Wolf Alejandro Felix |
Consejero | Conti Marina |
Datos registrales: T 28307 , F 28, S 8, H M 224903, I/A 62
24
Mar 2017
Con fecha 24/03/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 28307 , F 27, S 8, H M 224903, I/A 61
23
Feb 2017
Con fecha 23/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Arroyo Hemmerling Mario |
Datos registrales: T 28307 , F 26, S 8, H M 224903, I/A 60
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-215-28 | Madrid | 08/11/2018 | |
BORME-A-2018-132-28 | Madrid | 11/07/2018 | |
BORME-A-2018-76-28 | Madrid | 19/04/2018 | |
BORME-A-2017-214-28 | Madrid | 10/11/2017 | |
BORME-A-2017-190-28 | Madrid | 04/10/2017 | |
BORME-A-2017-164-28 | Madrid | 29/08/2017 | |
BORME-A-2017-130-28 | Madrid | 11/07/2017 | |
BORME-A-2017-122-28 | Madrid | 29/06/2017 | |
BORME-A-2017-86-28 | Madrid | 09/05/2017 | |
BORME-A-2017-64-28 | Madrid | 03/04/2017 | |
BORME-A-2017-43-28 | Madrid | 02/03/2017 | |
BORME-A-2016-125-28 | Madrid | 01/07/2016 | |
BORME-A-2016-93-28 | Madrid | 18/05/2016 | |
BORME-A-2016-92-28 | Madrid | 17/05/2016 | |
BORME-A-2016-36-28 | Madrid | 23/02/2016 | |
BORME-A-2015-113-28 | Madrid | 18/06/2015 | |
BORME-A-2015-107-28 | Madrid | 10/06/2015 | |
BORME-A-2015-58-28 | Madrid | 26/03/2015 | |
BORME-A-2015-34-28 | Madrid | 19/02/2015 | |
BORME-A-2015-17-28 | Madrid | 27/01/2015 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades