Última actualización: 2 de Febrero de 2016
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 8 años, 1 mes |
---|---|
NIF | G06000681 |
Provincia | Badajoz |
Domicilio | Paseo Fluvial 15 (Badajoz). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Sierra Folgado Francisco | 07/04/2009 | 02/02/2016 |
Consj.Supl. | Ropero Mancera Ramon | 24/07/2009 | 02/02/2016 |
Apo.Man.Soli | Rojo Rey Antonio | 13/05/2010 | 02/02/2016 |
Apoderado | Risco Romero Francisco Javier | 08/04/2009 | 02/02/2016 |
Consj.Supl. | Perez Muñoz Fernando | 24/07/2009 | 02/02/2016 |
Secretario | Moriano Saavedra Andres | 29/05/2012 | 02/02/2016 |
Consj.Supl. | Martinez Matito Manuela | 24/07/2009 | 02/02/2016 |
Apoderado | Majan Diaz Maria Del Carmen | 07/04/2009 | 02/02/2016 |
Vicepresid. | Macias Gata Alfonso Carlos | 29/05/2012 | 02/02/2016 |
Consj. Supl. | Liñan Corrochano Alfredo | 29/05/2012 | 02/02/2016 |
Apoderado | Jaramillo Alvarez Enrique Francisco | 29/07/2011 | 02/02/2016 |
Consejero | Guerrero Gimon Virtudes | 29/05/2012 | 02/02/2016 |
Director | Gordillo Limon Susana Maria | 05/12/2008 | 02/02/2016 |
Consejero | Gonzalez Santos Juana | 29/05/2012 | 02/02/2016 |
Presidente | Garcia Peña Francisco Manuel | 24/07/2009 | 02/02/2016 |
Consejero | Fernandez Gonzalez Ana Belen | 24/07/2009 | 02/02/2016 |
Supl.Comi.C. | Collado Perez Fernando | 24/07/2009 | 02/02/2016 |
Director | Caro Jarillo Angel Manuel | 12/02/2009 | 02/02/2016 |
Consejero | Bernal Carrion Miguel | 24/07/2009 | 02/02/2016 |
Consejero | Aguilar Rodriguez Celestino | 29/05/2012 | 02/02/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Monte De Piedad Y Caja General De Ahorros De Badajoz .
02
Feb 2016
Con fecha 02/02/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 410 , F 206, S 8, H BA 1853, I/A 711
02
Feb 2016
POR OFICIO DE FECHA 21/01/2016, REMITIDO POR EL JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y REGISTROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, LA ENTIDAD DE ESTA HOJA SE HA TRANSFORMADO EN FUNDACION DE CARACTER ESPECIAL, QUEDANDO POR TANTO CERRADA SU HOJA REGISTRAL EN ESTA OFICINA.
Datos registrales: T 410 , F 206, S 8, H BA 1853, I/A 711
02
May 2013
Con fecha 02/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Jimenez Labrador Emilio |
Datos registrales: T 410 , F 204, S 8, H BA 1853, I/A 710
30
Oct 2012
Con fecha 30/10/2012, la sociedad cambia su domicilio social a PASEO FLUVIAL 15 (BADAJOZ).
Datos registrales: T 410 , F 202, S 8, H BA 1853, I/A 709
30
Oct 2012
SE MODIFICA LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA 3 DE LOS VIGENTES ESTATUTOS SOCIALES, ASI COMO LA DISPOSICION TRANSITORIAPRIMERA DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO REGULADOR DEL SISTEMA DE DESIGNACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD.SE ACUERDA LA MODIFICACION Y ADAPTACION DE LOS ARTICULOS 25.2,26.1,26.2,27.1,28.1 Y 40.1 DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDADAL REAL DECRETO LEY 2/2012 DE 3 DE FEBRERO, EN CUANTO MODIFICA EL REAL DECRETO LEY 11/2010 DE 9 DE JULIO, DE ORGANOS DEGOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL REGIMEN JURIDICO DE C.C.A.A.
Datos registrales: T 410 , F 202, S 8, H BA 1853, I/A 709
30
Oct 2012
Con fecha 30/10/2012, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-.
Datos registrales: T 410 , F 202, S 8, H BA 1853, I/A 709
29
May 2012
Con fecha 29/05/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Datos registrales: T 410 , F 201, S 8, H BA 1853, I/A 708
29
May 2012
Con fecha 29/05/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Miem.Com.Ctr | Trinidad Alvarez Maria Del Carmen |
Consj. Supl. | Trejo Garrido Francisco |
Consejero | Sierra Folgado Francisco |
Consj. Supl. | Santiago Lavado Jose |
Vicpres C.E | Ruiz Martinez Miguel |
Miem.Com.Ctr | Rivera Porras Manuel |
Consj. Supl. | Pereira Chorro Jose Carlos |
Supl.Comi.C. | Olea Marquez De Prado Leopoldo |
Miem.Com.Ctr | Muñoz Nuñez Teresa |
Consj. Supl. | Montero Perez Jose |
Consejero | Martinez Moreno Felipe |
Consj. Supl. | Jimenez Sanchez Maria Isabel |
Consj. Supl. | Hernandez Macias Maria Luz |
Consejero | Gordillo Vaquero Estrella |
Miem.Com.Ctr | Gonzalez Serrano Jose Sandalio |
Consejero | Gonzalez Lozano Daniel |
Miem.Com.Ctr | Gobierno De Extremadura |
Miem.Com.Ej. | Garcia Salas Antonio |
Consj. Supl. | Garcia Pizarro Manuel |
Supl.Comi.C. | Diaz Garcia Luis |
Supl.Comi.C. | Castaño Castaño Jose Francisco |
Consejero | Carrasco Mendoza Castor |
Vicepresid. | Astorga Gonzalez Alberto |
Miem.Com.Ej. | Antunez Apolo Agueda |
Consj. Supl. | Albarran Cuenda Lorenzo |
Datos registrales: T 410 , F 201, S 8, H BA 1853, I/A 708
02
Abr 2012
POR LA PRESENTE INSCRIPCION SE ACUERDA EL CIERRE DE LAS SUCURSALES DE: CORDOBA 3, GUADALUPE(CACERES), ALMENDRALEJO URBANA 2 Y BADAJOZ URBANA LAS VAGUADAS.
Datos registrales: T 410 , F 200, S 8, H BA 1853, I/A 707
28
Mar 2012
SE HAN ADAPTADO LOS ESTATUTOS Y EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO REGULADOR DEL SISTEMA DE DESIGNACION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD AL RD LEY 11/2010 DE 9 DE JULIO DE ORGANO DE GOBIERNO Y OTROS ASPECTOS DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAJAS DE AHORROS, ASI COMO A LA LEY 1/2011 DE 31 DE ENERO.
Datos registrales: T 410 , F 184, S 8, H BA 1853, I/A 706
29
Dic 2011
Sociedades beneficiarias de la escisión: BANCO GRUPO CAJATRES S.A.
Datos registrales: T 410 , F 179, S 8, H BA 1853, I/A 705
28
Sep 2011
Adaptación de sociedad
Datos registrales: T 410 , F 164, S 8, H BA 1853, I/A 704
01
Sep 2011
Con fecha 01/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 410 , F 163, S 8, H BA 1853, I/A 703
08
Ago 2011
QUEDA RECTIFICADA LA PRECEDENTE INSCRIPCION 701& DE ESTA HOJA EN EL SENTIDO DE QUE EL APODERADO DON ENRIQUE FRANCISCO JARAMILLO ALVAREZ TIENE COMO DOMICILIO EL DE PASEO DE SAN FRANCISCO 18 EN BADAJOZ.
Datos registrales: T 410 , F 163, S 8, H BA 1853, I/A 702
29
Jul 2011
Con fecha 29/07/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Jaramillo Alvarez Enrique Francisco |
Datos registrales: T 410 , F 162, S 8, H BA 1853, I/A 701
14
Jul 2011
Con fecha 14/07/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Olano Altube Antonio |
Datos registrales: T 410 , F 162, S 8, H BA 1853, I/A 700
05
Jul 2011
Con fecha 05/07/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Valle Mesa Sara |
Datos registrales: T 410 , F 161, S 8, H BA 1853, I/A 699
09
Jun 2011
Con fecha 09/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Navarro Abad Rocio |
Apo.Sol. | Merino Maqueda Jose Luis |
Apo.Sol. | Martos Lara Alfredo |
Apo.Sol. | Cid Quintanilla Fernando |
Apoderado | Bruzon Barreras Oscar |
Datos registrales: T 410 , F 160, S 8, H BA 1853, I/A 698
01
Jun 2011
Con fecha 01/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Babio Mantiñan Gustavo |
Datos registrales: T 410 , F 159, S 8, H BA 1853, I/A 697
17
May 2011
SE DECLARA EL CIERRE DE LAS SIGUIENTES SUCURSALES: OFICINA DE BADAJOZ, URBANA SANTA ISABEL; OFICINA DE BADAJOZ, URBANA MARIA AUXILIADORA; OFICINA DE MERIDA, URBANA LUIS CHAMIZO; OFICINA DE ZAFRA, URBANA 1.
Datos registrales: T 410 , F 159, S 8, H BA 1853, I/A 696
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2016-26-06 | Badajoz | 09/02/2016 | |
BORME-A-2013-86-06 | Badajoz | 09/05/2013 | |
BORME-A-2012-216-06 | Badajoz | 12/11/2012 | |
BORME-A-2012-107-06 | Badajoz | 07/06/2012 | |
BORME-A-2012-71-06 | Badajoz | 13/04/2012 | |
BORME-A-2012-68-06 | Badajoz | 10/04/2012 | |
BORME-A-2012-6-06 | Badajoz | 10/01/2012 | |
BORME-A-2011-192-06 | Badajoz | 07/10/2011 | |
BORME-A-2011-174-06 | Badajoz | 13/09/2011 | |
BORME-A-2011-156-06 | Badajoz | 17/08/2011 | |
BORME-A-2011-151-06 | Badajoz | 09/08/2011 | |
BORME-A-2011-141-06 | Badajoz | 26/07/2011 | |
BORME-A-2011-134-06 | Badajoz | 14/07/2011 | |
BORME-A-2011-117-06 | Badajoz | 20/06/2011 | |
BORME-A-2011-111-06 | Badajoz | 10/06/2011 | |
BORME-A-2011-100-06 | Badajoz | 26/05/2011 | |
BORME-A-2011-68-06 | Badajoz | 07/04/2011 | |
BORME-A-2011-23-06 | Badajoz | 03/02/2011 | |
BORME-A-2010-216-06 | Badajoz | 11/11/2010 | |
BORME-A-2010-215-06 | Badajoz | 10/11/2010 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades