Última actualización: 5 de Junio de 2015
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 8 años, 10 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A82046285 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Avda Doctor Severo Ochoa Numero 29 (Alcobendas). |
Capital social | 1.481.531,11 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Rios Mitchel Jose Miguel | 18/12/2013 | 05/06/2015 |
Apoderado | Porta Ballesteros Barbara | 13/02/2009 | 05/06/2015 |
Consejero | Perez Boada Andres | 09/12/2014 | 05/06/2015 |
Apoderado | Perez Boada Andres | 09/01/2015 | 05/06/2015 |
Presidente | Marion Herve | 09/01/2015 | 05/06/2015 |
Consejero | Marion Herve | 09/01/2015 | 05/06/2015 |
Apoderado | Marion Herve | 09/01/2015 | 05/06/2015 |
Consejero | Lozano Sanchez Fernando | 09/12/2014 | 05/06/2015 |
Apoderado | Lozano Sanchez Fernando | 18/12/2013 | 05/06/2015 |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 21/01/2010 | 05/06/2015 |
Presidente | Gonzalez Martinez Jose Luis | 09/12/2014 | 05/06/2015 |
Consejero | Gonzalez Martinez Jose Luis | 09/12/2014 | 05/06/2015 |
Apoderado | Gonzalez Martinez Jose Luis | 18/12/2013 | 05/06/2015 |
Consejero | Fernandez-Tresguerres Hernandez-Gil Fernando | 09/12/2014 | 05/06/2015 |
Aud.C.Con. | Ernst & Young SL | 03/01/2013 | 05/06/2015 |
SecreNoConsj | Dutilh Carvajal Jose Maria | 09/01/2015 | 05/06/2015 |
Apoderado | Diaz-Varela Arrese Begoña | 18/12/2013 | 05/06/2015 |
Consejero | Brendel Francois | 09/01/2015 | 05/06/2015 |
Consejero | Artieda Gonzalez-Granda Juan | 09/12/2014 | 05/06/2015 |
Apoderado | Artieda Gonzalez-Granda Juan | 18/12/2013 | 05/06/2015 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Molypharma SA.
05
Jun 2015
Con fecha 05/06/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 18943 , F 136, S 8, H M 214351, I/A 38
05
Jun 2015
Con fecha 05/06/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 18943 , F 136, S 8, H M 214351, I/A 38
05
Jun 2015
Con fecha 05/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Marion Herve |
SecreNoConsj | Dutilh Carvajal Jose Maria |
Consejero | Dehareng Renaud |
Consejero | Brendel Francois |
Datos registrales: T 18943 , F 136, S 8, H M 214351, I/A 38
20
Mar 2015
Reducción de capital
Datos registrales: T 18943 , F 135, S 8, H M 214351, I/A 37
09
Ene 2015
Con fecha 09/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Perez Boada Andres |
Presidente | Marion Herve |
SecreNoConsj | Dutilh Carvajal Jose Maria |
Apoderado | Dehareng Renaud |
Datos registrales: T 18943 , F 134, S 8, H M 214351, I/A 36
09
Ene 2015
Con fecha 09/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Rodergas Puntas Fernando |
Apo.Manc. | Rios Mitchell Jose-Miguel |
Apo.Sol. | Rios Mitchel Jose Miguel |
Apo.Manc. | Oyarzabal Delgado Ignacio |
Apo.Sol. | Lozano Sanchez Fernando |
Apo.Sol. | Lluch Tejero Jesus |
Apo.Sol. | Jimenez Shaw Rafael |
Apo.Manc. | Gonzalez Martinez Jose Luis |
Apo.Sol. | Garcia-Calderon Romeo German |
Apo.Sol. | Elias De Tejada Lozano Jose Maria |
Apo.Manc. | Diaz-Varela Arrese Begoña |
Apo.Manc. | Artieda Gonzalez Granda Juan Ignacio |
Datos registrales: T 18943 , F 134, S 8, H M 214351, I/A 36
09
Ene 2015
Con fecha 09/01/2015, la sociedad cambia su domicilio social a AVDA DOCTOR SEVERO OCHOA NUMERO 29 (ALCOBENDAS).
Datos registrales: T 18943 , F 133, S 8, H M 214351, I/A 35
09
Ene 2015
Con fecha 09/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Marion Herve |
Consejero | Dehareng Renaud |
Consejero | Brendel Francois |
Datos registrales: T 18943 , F 133, S 8, H M 214351, I/A 35
09
Ene 2015
Con fecha 09/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Perez Boada Andres |
Secretario | Lozano Sanchez Fernando |
Consejero | Gonzalez Martinez Jose Luis |
Consejero | Fernandez-Tresguerres Hernandez-Gil Fernando |
Consejero | Artieda Gonzalez-Granda Juan |
Datos registrales: T 18943 , F 133, S 8, H M 214351, I/A 35
09
Ene 2015
Con fecha 09/01/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias IBA MOLECULAR SPAIN SA.
Datos registrales: T 18943 , F 133, S 8, H M 214351, I/A 35
09
Dic 2014
Con fecha 09/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Perez Boada Andres |
Consejero | Lozano Sanchez Fernando |
Consejero | Gonzalez Martinez Jose Luis |
Consejero | Fernandez-Tresguerres Hernandez-Gil Fernando |
Consejero | Artieda Gonzalez-Granda Juan |
Datos registrales: T 18943 , F 133, S 8, H M 214351, I/A 34
18
Dic 2013
Con fecha 18/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Rios Mitchel Jose Miguel |
Apoderado | Lozano Sanchez Fernando |
Apoderado | Gonzalez Martinez Jose Luis |
Apoderado | Diaz-Varela Arrese Begoña |
Apoderado | Artieda Gonzalez-Granda Juan |
Datos registrales: T 18943 , F 131, S 8, H M 214351, I/A 33
18
Dic 2013
Con fecha 18/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Lozano Sanchez Fernando |
Datos registrales: T 18943 , F 130, S 8, H M 214351, I/A 32
18
Dic 2013
Con fecha 18/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Oyarzabal Delgado Ignacio |
Datos registrales: T 18943 , F 130, S 8, H M 214351, I/A 32
28
Feb 2013
Con fecha 28/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Saus Cano Marta |
REPR.143 RRM | Oyarzabal Delgado Ignacio |
CONSEJERO | Molypharma SA |
SECRETARIO | Garcia Robles Marin Juan Pedro |
CONSEJERO | Cetir Centre Medic SL |
Datos registrales: T 36205 , F 197, S 8, H B 93988, I/A 26
07
Feb 2013
Con fecha 07/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
PRESIDENTE | Saus Mas Vicente |
REPR.143 RRM | Saus Cano Marta |
REPR.143 RRM | Oyarzabal Delgado Ignacio |
CONSEJERO | Molypharma SA |
SECR.NO CONS | Garcia Robles Marin Juan Pedro |
CONS. DELEG. | Cetir Centre Medic SL |
Datos registrales: T 35644 , F 123, S 8, H B 193423, I/A 21
11
Ene 2013
Con fecha 11/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Saus Cano Marta |
REPR.143 RRM | Oyarzabal Delgado Ignacio |
CONSEJERO | Molypharma SA |
CONSEJERO | Garcia Robles Marin Juan Pedro |
CONSEJERO | Cetir Centre Medic SL |
Datos registrales: T 36205 , F 196, S 8, H B 93988, I/A 24
11
Ene 2013
Con fecha 11/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Saus Cano Marta |
REPR.143 RRM | Oyarzabal Delgado Ignacio |
CONSEJERO | Molypharma SA |
CONSEJERO | Garcia Robles Marin Juan Pedro |
CONS. DELEG. | Cetir Centre Medic SL |
Datos registrales: T 36205 , F 196, S 8, H B 93988, I/A 24
11
Ene 2013
Con fecha 11/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
PRESIDENTE | Molypharma SA |
Datos registrales: T 36205 , F 195, S 8, H B 93988, I/A 23
11
Ene 2013
Con fecha 11/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Saus Cano Marta |
PRESIDENTE | Molypharma SA |
SECR.NO CONS | Lozano Sanchez Fernando |
CONSEJERO | Enusa Industrias Avanzadas SA |
CONSEJERO | Centre Diagnostic Pedralbes SA |
Datos registrales: T 36205 , F 193, S 8, H B 93988, I/A 20
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2015-110-28 | Madrid | 15/06/2015 |
BORME-A-2015-62-28 | Madrid | 01/04/2015 |
BORME-A-2015-11-28 | Madrid | 19/01/2015 |
BORME-A-2014-240-28 | Madrid | 17/12/2014 |
BORME-A-2013-247-28 | Madrid | 27/12/2013 |
BORME-A-2013-246-28 | Madrid | 26/12/2013 |
BORME-A-2013-47-08 | Barcelona | 08/03/2013 |
BORME-A-2013-32-08 | Barcelona | 15/02/2013 |
BORME-A-2013-12-08 | Barcelona | 18/01/2013 |
BORME-A-2013-8-28 | Madrid | 14/01/2013 |
BORME-A-2012-145-08 | Barcelona | 31/07/2012 |
BORME-A-2011-94-28 | Madrid | 18/05/2011 |
BORME-A-2011-67-28 | Madrid | 06/04/2011 |
BORME-A-2010-21-28 | Madrid | 02/02/2010 |
BORME-A-2009-238-28 | Madrid | 15/12/2009 |
BORME-A-2009-151-08 | Barcelona | 11/08/2009 |
BORME-A-2009-37-28 | Madrid | 24/02/2009 |
BORME-A-2009-3-28 | Madrid | 07/01/2009 |
BORME-A-2009-1-08 | Barcelona | 02/01/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades