Última actualización: 12 de Abril de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A78609088 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Orense 11 6ª - Oficina 1 (Madrid). |
Objeto social | La obtencion de concesiones o contratos de obra publica, la tramitacion de concesiones de centrales o intalaciones de cualquier tipo para la produccion de energias renovables . el analisis y asesoramiento de oportunidades de inversion en proyectos de energia.- |
Capital social | 3.005.005,0 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL | 12/04/2024 | Actualidad |
SecreNoConsj | Sangro Gomez-Acebo Pedro | 29/10/2014 | Actualidad |
Representan | Palazon Quevedo Antonio | 29/10/2014 | Actualidad |
Representan | Lozano Muñoz Jose Maria | 29/10/2014 | Actualidad |
Presidente | Hidroelectrica Gormaz SL | 29/10/2014 | Actualidad |
Consejero | Hidroelectrica Gormaz SL | 29/10/2014 | Actualidad |
Con.Delegado | Hidroelectrica Gormaz SL | 29/10/2014 | Actualidad |
Consejero | Hidroelectrica Fuentermosa SL | 29/10/2014 | Actualidad |
Consejero | Hidroelectrica De Xerta SL | 29/10/2014 | Actualidad |
Representan | Garcia De Juana Santiago | 29/10/2014 | Actualidad |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 10/02/2014 | Actualidad |
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 10/02/2014 | Actualidad |
M.Comit.Aud | Sorger Lenning Adrian | 09/07/2013 | Actualidad |
Presidente | Piganeau Henri Marie Bernad Francis | 18/07/2012 | Actualidad |
Consejero | Piganeau Henri Marie Bernad Francis | 18/07/2012 | Actualidad |
Auditor | Bdo Auditores SLP | 15/02/2012 | Actualidad |
Pte.Comit.Au | Sangro Gomez Acebo Pedro Maria | 17/06/2011 | Actualidad |
Apo.Manc. | Palazon Quevedo Antonio Marino | 17/06/2011 | Actualidad |
Sec.Comit.Au | Lozano Muñoz Jose | 17/06/2011 | Actualidad |
Apo.Manc. | Garcia De Juana Santiago | 17/06/2011 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M.Comit.Aud | Sorger Lenning Adrian | Desconocido | 15/02/2022 |
SecreNoConsj | Sangro Gomez-Acebo Pedro | Desconocido | 15/02/2022 |
Pte.Comit.Au | Sangro Gomez Acebo Pedro Maria | Desconocido | 15/02/2022 |
Presidente | Renewable Power International Partners SL | 04/10/2019 | 15/02/2022 |
Consejero | Renewable Power International Partners SL | 04/10/2019 | 15/02/2022 |
Con.Delegado | Renewable Power International Partners SL | 04/10/2019 | 15/02/2022 |
Representan | Palazon Quevedo Antonio | 04/10/2019 | 15/02/2022 |
Representan | Lozano Muñoz Jose Maria | 04/10/2019 | 15/02/2022 |
Sec.Comit.Au | Lozano Muñoz Jose | Desconocido | 15/02/2022 |
ComiSinObli | Latorre Atance Alejandro | Desconocido | 15/02/2022 |
Consejero | Hidroelectrica Fuentermosa SL | 04/10/2019 | 15/02/2022 |
Consejero | Hidroelectrica De Xerta SL | 04/10/2019 | 15/02/2022 |
Representan | Garcia De Juana Santiago | 04/10/2019 | 15/02/2022 |
Apo.Manc. | Almeras Jerome Robert Herve Marie | Desconocido | 15/02/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 03/02/2020 | 27/01/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 04/02/2021 | 27/01/2015 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 13/04/2022 | 27/01/2015 |
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 03/02/2020 | 27/01/2015 |
Apoderado | Lozano Muñoz Jose | 22/07/2011 | 27/01/2015 |
Adm. Mancom. | Hidroelectrica Gormaz SL | 26/01/2015 | 27/01/2015 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Renewable Power International SA.
12
Abr 2024
Con fecha 12/04/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 38388 , F 176, S 8, H M 51870, I/A 63
01
Nov 2023
Con fecha 01/11/2023, la sociedad cambia su domicilio social a C/ ORENSE 11 6ª - OFICINA 1 (MADRID).
Datos registrales: T 38388 , F 176, S 8, H M 51870, I/A 62
16
Ago 2023
Emisión de un nuevo y único título múltiple (el "Título Múltiple") en favor del Accionista Unico representativo de la totalidad de las acciones de la Sociedad: 1.202.002 acciones, de dos euros y cincuenta céntimos (2,5 E) de valor nominal cada una de ellas, e íntegramente desembolsadas.
Datos registrales: T 38388 , F 172, S 8, H M 51870, I/A 53M
26
Jun 2023
Con fecha 26/06/2023 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias HIDROCENTRAIS REUNIDAS S.A.
Datos registrales: T 38388 , F 175, S 8, H M 51870, I/A 61
09
Jun 2023
Con fecha 09/06/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
INCLUSION DE UN ARTICULO 6º BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Datos registrales: T 38388 , F 175, S 8, H M 51870, I/A 60
13
Abr 2022
Con fecha 13/04/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 38388 , F 175, S 8, H M 51870, I/A 59
15
Feb 2022
Con fecha 15/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Almeras Jerome Robert Herve Marie |
Datos registrales: T 38388 , F 175, S 8, H M 51870, I/A 58
15
Feb 2022
Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados. Modificación del artículo 21º de los Estatutos sociales relativo a la forma del órgano de administración de la sociedad.
Datos registrales: T 38388 , F 174, S 8, H M 51870, I/A 57
15
Feb 2022
Con fecha 15/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Mancom. | Lozano Muñoz Jose Maria |
Adm. Mancom. | Garcia De Juana Santiago |
Datos registrales: T 38388 , F 174, S 8, H M 51870, I/A 57
15
Feb 2022
Con fecha 15/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
M.Comit.Aud | Sorger Lenning Adrian |
SecreNoConsj | Sangro Gomez-Acebo Pedro |
Pte.Comit.Au | Sangro Gomez Acebo Pedro Maria |
Con.Delegado | Renewable Power International Partners SL |
Representan | Palazon Quevedo Antonio |
Representan | Lozano Muñoz Jose Maria |
Sec.Comit.Au | Lozano Muñoz Jose |
ComiSinObli | Latorre Atance Alejandro |
Consejero | Hidroelectrica Fuentermosa SL |
Consejero | Hidroelectrica De Xerta SL |
Representan | Garcia De Juana Santiago |
Datos registrales: T 38388 , F 174, S 8, H M 51870, I/A 57
04
Feb 2021
Con fecha 04/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 38388 , F 174, S 8, H M 51870, I/A 56
03
Feb 2020
Con fecha 03/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 38388 , F 174, S 8, H M 51870, I/A 55
04
Oct 2019
Con fecha 04/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Renewable Power International Partners SL |
Representan | Palazon Quevedo Antonio |
Representan | Lozano Muñoz Jose Maria |
Consejero | Hidroelectrica Fuentermosa SL |
Consejero | Hidroelectrica De Xerta SL |
Representan | Garcia De Juana Santiago |
Datos registrales: T 38388 , F 173, S 8, H M 51870, I/A 54
18
Mar 2019
Reducción de capital
Datos registrales: T 38388 , F 172, S 8, H M 51870, I/A 53
07
Feb 2019
Con fecha 07/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 38388 , F 172, S 8, H M 51870, I/A 52
29
Nov 2018
Con fecha 29/11/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias RENEWABLE POWER VEHICLE SL.
Datos registrales: T 38388 , F 172, S 8, H M 51870, I/A 51
28
Nov 2018
MODIFICACION DE LA ESCRITURA DE EMISION DE OBLIGACIONES DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2004 - INSCRITA POR LA 22ª DE ESTA HOJA-
Datos registrales: T 20673 , F 39, S 8, H M 51870, I/A 50
21
Nov 2018
MODIFICACION DE LA ESCRITURA DE EMISION DE OBLIGACIONES DE 17 DE MARZO DE 2000 -INSCRITA POR LA 17ª DE ESTA HOJA-
Datos registrales: T 20673 , F 36, S 8, H M 51870, I/A 49
24
Ene 2018
Con fecha 24/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.C.Con. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 20673 , F 35, S 8, H M 51870, I/A 48
28
Nov 2016
Con fecha 28/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 20673 , F 35, S 8, H M 51870, I/A 47
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-77-28 | Madrid | 19/04/2024 | |
BORME-A-2023-213-28 | Madrid | 08/11/2023 | |
BORME-A-2023-160-28 | Madrid | 23/08/2023 | |
BORME-A-2023-124-28 | Madrid | 03/07/2023 | |
BORME-A-2023-113-28 | Madrid | 16/06/2023 | |
BORME-A-2022-77-28 | Madrid | 22/04/2022 | |
BORME-A-2022-36-28 | Madrid | 22/02/2022 | |
BORME-A-2021-28-28 | Madrid | 11/02/2021 | |
BORME-A-2020-27-28 | Madrid | 10/02/2020 | |
BORME-A-2019-196-28 | Madrid | 11/10/2019 | |
BORME-A-2019-58-28 | Madrid | 25/03/2019 | |
BORME-A-2019-31-28 | Madrid | 14/02/2019 | |
BORME-A-2018-234-28 | Madrid | 07/12/2018 | |
BORME-A-2018-233-28 | Madrid | 05/12/2018 | |
BORME-A-2018-228-28 | Madrid | 28/11/2018 | |
BORME-A-2018-23-28 | Madrid | 01/02/2018 | |
BORME-A-2016-232-28 | Madrid | 07/12/2016 | |
BORME-A-2015-23-28 | Madrid | 04/02/2015 | |
BORME-A-2015-21-28 | Madrid | 02/02/2015 | |
BORME-A-2012-147-28 | Madrid | 02/08/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades