Última actualización: 8 de Febrero de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Disuelta desde hace 3 años, 5 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B95045167 |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 45.462.690,0 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM.CONJUNTO | Reig Britapaja Nayara | 03/02/2020 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Mateo Di Carlo | 03/02/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Soria Diaz Daniel | 02/10/2019 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 17/01/2019 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Rebecca Kate Verano Luri | 27/11/2018 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Merida Rodriguez Esteban | 07/12/2015 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 12/11/2015 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Paolo D'Orso | 20/02/2014 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Ojeda Lopez Laura | 20/02/2014 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Grañena Aracil Ariadna | 20/02/2014 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Costa Lopez Silvia | 20/02/2014 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Bove Collado Xavier | 20/02/2014 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 10/12/2013 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 10/12/2013 | Actualidad |
APODERADO | Ravij Chandra | 02/07/2009 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 20/04/2009 | Actualidad |
APODERADO | Camero Gonzalez Jose Joaquin | 15/01/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM.CONJUNTO | Adrian Hennah | 21/03/2014 | 20/08/2020 |
ADM.CONJUNTO | Rebecca Kate Verano Luri | 18/01/2018 | 03/02/2020 |
ADM.CONJUNTO | Christian James Ardern | 30/04/2019 | 03/02/2020 |
ADM.CONJUNTO | Merida Rodriguez Esteban | 27/08/2015 | 30/04/2019 |
ADM.CONJUNTO | Paolo D'Orso | 20/02/2014 | 18/01/2018 |
APOD.SOL/MAN | Millan Camacho Gabriel | 20/02/2014 | 07/12/2015 |
ADM.CONJUNTO | Millan Camacho Gabriel | 20/02/2014 | 27/08/2015 |
ADM.CONJUNTO | Rajiv Chandra | 02/07/2009 | 20/02/2014 |
APODERADO | Martin Anfruns Alfred | Desconocido | 20/02/2014 |
APODERADO | Jimenez Garcia Sergio | 15/01/2009 | 20/02/2014 |
APODERADO | Echapresto Martinez Jorge | Desconocido | 20/02/2014 |
ADM.CONJUNTO | Camero Gonzalez Jose Joaquin | Desconocido | 20/02/2014 |
APODERADO | Torroella Sans Jordi | Desconocido | 13/05/2013 |
APODERADO | Imedio Beltri Carol | 20/10/2009 | 13/05/2013 |
ADM.CONJUNTO | Colin Richard Day | Desconocido | 22/12/2011 |
APODERADO | Lara Arana Mercedes | 15/01/2009 | 01/06/2010 |
ADM.CONJUNTO | Ignacio Andres Mauricio Schmidt | Desconocido | 02/07/2009 |
APODERADO | Martinez Carretero Daniel | Desconocido | 15/01/2009 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Lancaster Square Holdings SL.
08
Feb 2021
De conformidad con el articulo 233.2 del Reglamento del Registro Mercantil, queda EXTINGUIDA la hoja de esta sociedad y CANCELADOS sus asientos.
Datos registrales: T 44280 , F 200, S 8, H B 220355, I/A 89
09
Nov 2020
Con fecha 09/11/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 44280 , F 197, S 8, H B 220355, I/A 88
13
Oct 2020
Con fecha 13/10/2020, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 1.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 0.00% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 45.462.690,0€.
Datos registrales: T 44280 , F 197, S 8, H B 220355, I/A 87
30
Sep 2020
DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: RECKITT BENCKISER LIMITED.
Datos registrales: T 44280 , F 196, S 8, H B 220355, I/A 86
20
Ago 2020
Con fecha 20/08/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Adrian Hennah |
Datos registrales: T 44280 , F 196, S 8, H B 220355, I/A 85
20
Ago 2020
RECTIFICADO EL NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA MANCOMUNADA SIENDO EL CORRECTO NAARA REIG BRITAPAJA.
Datos registrales: T 44280 , F 196, S 8, H B 220355, I/A 84
03
Feb 2020
Con fecha 03/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Mateo Di Carlo |
Datos registrales: T 44280 , F 196, S 8, H B 220355, I/A 82
03
Feb 2020
Con fecha 03/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Rebecca Kate Verano Luri |
Datos registrales: T 44280 , F 196, S 8, H B 220355, I/A 82
03
Feb 2020
Con fecha 03/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Reig Britapaja Nayara |
Datos registrales: T 44280 , F 196, S 8, H B 220355, I/A 83
03
Feb 2020
Con fecha 03/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Christian James Ardern |
Datos registrales: T 44280 , F 196, S 8, H B 220355, I/A 83
05
Dic 2019
Con fecha 05/12/2019, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 44.353.396,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 4001.95% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 45.461.690,0€.
Datos registrales: T 44280 , F 195, S 8, H B 220355, I/A 81
02
Oct 2019
Con fecha 02/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Soria Diaz Daniel |
Datos registrales: T 44280 , F 194, S 8, H B 220355, I/A 80
30
Abr 2019
Con fecha 30/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Christian James Ardern |
Datos registrales: T 44280 , F 194, S 8, H B 220355, I/A 79
30
Abr 2019
Con fecha 30/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Merida Rodriguez Esteban |
Datos registrales: T 44280 , F 194, S 8, H B 220355, I/A 79
17
Ene 2019
Con fecha 17/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 44280 , F 194, S 8, H B 220355, I/A 78
27
Nov 2018
Con fecha 27/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Rebecca Kate Verano Luri |
Datos registrales: T 44280 , F 193, S 8, H B 220355, I/A 77
05
Oct 2018
DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: NORWICH SQUARE HOLDINGS S.L.
Datos registrales: T 44280 , F 193, S 8, H B 220355, I/A 76
05
Oct 2018
Con fecha 05/10/2018, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL.
Datos registrales: T 44280 , F 193, S 8, H B 220355, I/A 76
18
Ene 2018
Con fecha 18/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Rebecca Kate Verano Luri |
Datos registrales: T 44280 , F 192, S 8, H B 220355, I/A 75
18
Ene 2018
Con fecha 18/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Paolo D'Orso |
Datos registrales: T 44280 , F 192, S 8, H B 220355, I/A 75
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2021-33-08 | Barcelona | 18/02/2021 | |
BORME-A-2020-222-08 | Barcelona | 18/11/2020 | |
BORME-A-2020-204-08 | Barcelona | 21/10/2020 | |
BORME-A-2020-196-08 | Barcelona | 08/10/2020 | |
BORME-A-2020-167-08 | Barcelona | 28/08/2020 | |
BORME-A-2020-28-08 | Barcelona | 11/02/2020 | |
BORME-A-2019-239-08 | Barcelona | 16/12/2019 | |
BORME-A-2019-195-08 | Barcelona | 10/10/2019 | |
BORME-A-2019-87-08 | Barcelona | 09/05/2019 | |
BORME-A-2019-17-08 | Barcelona | 25/01/2019 | |
BORME-A-2018-233-08 | Barcelona | 05/12/2018 | |
BORME-A-2018-199-08 | Barcelona | 16/10/2018 | |
BORME-A-2018-19-08 | Barcelona | 26/01/2018 | |
BORME-A-2015-239-08 | Barcelona | 16/12/2015 | |
BORME-A-2015-222-08 | Barcelona | 20/11/2015 | |
BORME-A-2015-168-08 | Barcelona | 03/09/2015 | |
BORME-A-2014-62-08 | Barcelona | 31/03/2014 | |
BORME-A-2014-41-08 | Barcelona | 28/02/2014 | |
BORME-A-2013-241-08 | Barcelona | 18/12/2013 | |
BORME-A-2013-94-08 | Barcelona | 22/05/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades