Última actualización: 25 de Octubre de 2016
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 7 años, 5 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B85446409 |
Denominación anterior | Brysam Spain SL |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Principe De Vergara 131, Planta Primera (Madrid). |
Capital social | 7.446.330,0 euros |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Tmf Management Spain SL | 19/05/2016 | 25/10/2016 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 14/03/2014 | 25/10/2016 |
Vicepresid. | Olivares Ynzenga Javier | 14/01/2016 | 25/10/2016 |
Consejero | Olivares Ynzenga Javier | 14/03/2013 | 25/10/2016 |
Apo.Manc. | Olivares Ynzenga Javier | 14/03/2013 | 25/10/2016 |
Secretario | Garrigues Calderon Belen | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Consejero | Garrigues Calderon Belen | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Apo.Sol. | Garrigues Calderon Belen | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Apo.Manc. | Garrigues Calderon Belen | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Presidente | Capella Gomez-Acebo Ana | 15/12/2010 | 25/10/2016 |
Liquidador | Capella Gomez-Acebo Ana | 25/10/2016 | 25/10/2016 |
Consejero | Capella Gomez-Acebo Ana | 15/12/2010 | 25/10/2016 |
Con.Delegado | Capella Gomez-Acebo Ana | 15/12/2010 | 25/10/2016 |
Apoderado | Capella Gomez-Acebo Ana | 15/12/2010 | 25/10/2016 |
Apo.Manc. | Capella Gomez-Acebo Ana | 07/09/2012 | 25/10/2016 |
Consejero | Huang Mitchell Young | 07/09/2012 | 14/03/2013 |
Apo.Manc. | Huang Mitchell Young | 07/09/2012 | 14/03/2013 |
Consejero | Wilmot John | 15/12/2010 | 07/09/2012 |
Secretario | Kavelaars Erik Leonardus Christian Jacobus | 04/03/2009 | 07/09/2012 |
Consejero | Kavelaars Erik Leonardus Christian Jacobus | 04/03/2009 | 07/09/2012 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Jp Morgan International Finance SL.
25
Oct 2016
Con fecha 25/10/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 25625 , F 219, S 8, H M 461751, I/A 16
25
Oct 2016
Con fecha 25/10/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 25625 , F 219, S 8, H M 461751, I/A 16
25
Oct 2016
Con fecha 25/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Capella Gomez-Acebo Ana |
Datos registrales: T 25625 , F 219, S 8, H M 461751, I/A 16
25
Oct 2016
Con fecha 25/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicepresid. | Olivares Ynzenga Javier |
Consejero | Garrigues Calderon Belen |
Presidente | Capella Gomez-Acebo Ana |
Datos registrales: T 25625 , F 219, S 8, H M 461751, I/A 16
19
May 2016
Con fecha 19/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tmf Management Spain SL |
Datos registrales: T 25625 , F 133, S 8, H M 461751, I/A 15
14
Ene 2016
Con fecha 14/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicepresid. | Olivares Ynzenga Javier |
Datos registrales: T 25625 , F 133, S 8, H M 461751, I/A 14
11
Ene 2016
Con fecha 11/01/2016, la sociedad cambia su domicilio social a C/ PRINCIPE DE VERGARA 131, PLANTA PRIMERA (MADRID).
Datos registrales: T 25625 , F 133, S 8, H M 461751, I/A 13
06
Abr 2015
Con fecha 06/04/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
10. - EL CONSEJO DE ADMINISTRACION-.
Datos registrales: T 25625 , F 132, S 8, H M 461751, I/A 12
14
Mar 2014
Con fecha 14/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 25625 , F 132, S 8, H M 461751, I/A 11
20
Jun 2013
Con fecha 20/06/2013, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 11.RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.MODIFICADO.
Datos registrales: T 25625 , F 132, S 8, H M 461751, I/A 10
14
Mar 2013
Con fecha 14/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Olivares Ynzenga Javier |
Datos registrales: T 25625 , F 131, S 8, H M 461751, I/A 9
14
Mar 2013
Con fecha 14/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Huang Mitchell Young |
Datos registrales: T 25625 , F 131, S 8, H M 461751, I/A 9
14
Mar 2013
Con fecha 14/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Huang Mitchell Young |
Datos registrales: T 25625 , F 131, S 8, H M 461751, I/A 9
08
Mar 2013
Con fecha 08/03/2013 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias J.P. MORGAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED.
Datos registrales: T 25625 , F 130, S 8, H M 461751, I/A 8
07
Sep 2012
Con fecha 07/09/2012, la sociedad cambia su domicilio social a C/ AYALA 66 (MADRID).
Datos registrales: T 25625 , F 129, S 8, H M 461751, I/A 8
07
Sep 2012
Con fecha 07/09/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Huang Mitchell Young |
Consejero | Garrigues Calderon Belen |
Apo.Manc. | Capella Gomez-Acebo Ana |
Datos registrales: T 25625 , F 129, S 8, H M 461751, I/A 8
07
Sep 2012
Con fecha 07/09/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Wilmot John |
Apoderado | Kavelaars Erik Leonardus Christian Jacobus |
Datos registrales: T 25625 , F 129, S 8, H M 461751, I/A 8
07
Sep 2012
Con fecha 07/09/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Wilmot John |
Secretario | Kavelaars Erik Leonardus Christian Jacobus |
Datos registrales: T 25625 , F 129, S 8, H M 461751, I/A 8
20
May 2011
Con fecha 20/05/2011, la sociedad cambia su denominación social a JP MORGAN INTERNATIONAL FINANCE SL
Datos registrales: T 25625 , F 129, S 8, H M 461751, I/A 7
15
Dic 2010
Con fecha 15/12/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Wilmot John |
Apoderado | Capella Gomez-Acebo Ana |
Datos registrales: T 25625 , F 127, S 8, H M 461751, I/A 6
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2016-214-28 | Madrid | 10/11/2016 |
BORME-A-2016-100-28 | Madrid | 27/05/2016 |
BORME-A-2016-15-28 | Madrid | 25/01/2016 |
BORME-A-2016-11-28 | Madrid | 19/01/2016 |
BORME-A-2015-68-28 | Madrid | 13/04/2015 |
BORME-A-2014-56-28 | Madrid | 21/03/2014 |
BORME-A-2013-121-28 | Madrid | 28/06/2013 |
BORME-A-2013-57-28 | Madrid | 25/03/2013 |
BORME-A-2013-53-28 | Madrid | 19/03/2013 |
BORME-A-2012-182-28 | Madrid | 20/09/2012 |
BORME-A-2011-103-28 | Madrid | 31/05/2011 |
BORME-A-2010-247-28 | Madrid | 28/12/2010 |
BORME-A-2009-51-28 | Madrid | 16/03/2009 |
BORME-A-2009-36-28 | Madrid | 23/02/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades